Buscador CIF Logo

Actos BORME Heroslam Sociedad Anonima Laboral

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Heroslam Sociedad Anonima Laboral

Actos BORME Heroslam Sociedad Anonima Laboral - A48571269

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Vizcaya para Heroslam Sociedad Anonima Laboral con CIF A48571269

馃敊 Perfil de Heroslam Sociedad Anonima Laboral
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Vizcaya

Actos BORME de Heroslam Sociedad Anonima Laboral

24 de Febrero de 2022
Reelecciones. Auditor: LKS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 3230 , F 221, S 8, H BI5356,A , I/ 45 .(17.02.22).

21 de Mayo de 2021
Nombramientos. Auditor: LKS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 3230 , F 220, S 8, H BI5356,A , I/ 44 .(12.05.21).

26 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER;RUIZ GERMAN NEREA. Secretario: RUIZ GERMAN NEREA.Nombramientos. Consejero: VILLORIA DIEZ LEIRE;MATESANZ BILBAO AITOR. Secretario: VILLORIA DIEZ LEIRE. Datosregistrales. T 3230 , F 207, S 8, H BI 5356,A , I/ 42 .(15.04.21).

Revocaciones. Apoderado: NIETO CEINOS JOSE ANTONIO;MARQUINA MORENO JESUS MANUEL;RUIZ GERMANNEREA;GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER;CARRO ALONSO RAUL. Nombramientos. Apoderado: NIETO CEINOS JOSEANTONIO;MARQUINA MORENO JESUS MANUEL;VILLORIA DIEZ LEIRE;CARRO ALONSO RAUL;MATESANZ BILBAOAITOR;RUIZ GERMAN NEREA. Datos registrales. T 3230 , F 208, S 8, H BI 5356,A , I/ 43 .(15.04.21).

08 de Mayo de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: SUBERVIOLA ORTIZ CHRISTIAN;RUIZ GERMAN NEREA;DELGADO FERNANDEZ LUIS MARIA;NIETOCEINOS JOSE ANTONIO;PEREZ MARTIN ROBERTO. Nombramientos. Apoderado: NIETO CEINOS JOSE ANTONIO;MARQUINAMORENO JESUS MANUEL;RUIZ GERMAN NEREA;GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER;CARRO ALONSO RAUL. Datosregistrales. T 3230 , F 206, S 8, H BI 5356,A , I/ 41 .(28.04.20).

07 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ GERMAN NEREA;MENDIOLA ANGULO ISKANDER. Secretario: RUIZ GERMAN NEREA.Nombramientos. Consejero: CARRO ALONSO RAUL;RUIZ GERMAN NEREA. Secretario: RUIZ GERMAN NEREA. Datosregistrales. T 3230 , F 206, S 8, H BI 5356,A , I/ 40 .(27.11.18).

04 de Enero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARQUINA MORENO JESUS MANUEL;SANCHEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS;NIETO CEINOSJOSE ANTONIO. Presidente: NIETO CEINOS JOSE ANTONIO. Vicepresid.: MARQUINA MORENO JESUS MANUEL.Nombramientos. Consejero: MARQUINA MORENO JESUS MANUEL. Vicepresid.: MARQUINA MORENO JESUS MANUEL.Consejero: NIETO CEINOS JOSE ANTONIO. Presidente: NIETO CEINOS JOSE ANTONIO. Consejero: GARCIA GARCIAFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3230 , F 205, S 8, H BI 5356,A , I/ 39 .(21.12.17).

23 de Marzo de 2017
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n y nueva redacci贸n de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la Ley 44/2015 de octubrede Sociedades Laborales y Participadas.. Datos registrales. T 3230 , F 202, S 8, H BI 5356,A , I/ 38 .(16.03.17).

23 de Abril de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 16.527,50 Euros. Resultante Suscrito: 966.420,02 Euros. Modificaciones estatutarias.se modifican los art铆culos 6 y 16 de estatutos.. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.heroslam.com. Datos registrales. T 3230 , F 201, S 8, H BI 5356,A , I/ 37 .(16.04.15).

25 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. Presidente: RUIZ GERMAN NEREA. Nombramientos. Consejero: MARQUINA MORENO JESUSMANUEL;SANCHEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS. Vicepresid.: PEREZ MARTIN ROBERTO. Secretario: RUIZ GERMAN NEREA.Presidente: NIETO CEINOS JOSE ANTONIO. Reelecciones. Consejero: NIETO CEINOS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T3230 , F 195, S 8, H BI 5356,A , I/ 35 .(13.06.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ GERMAN NEREA;PEREZ MARTIN ROBERTO. Vicepresid.: PEREZ MARTIN ROBERTO.Secretario: RUIZ GERMAN NEREA. Nombramientos. Consejero: MENDIOLA ANGULO ISKANDER;RUIZ GERMAN NEREA.Vicepresid.: MARQUINA MORENO JESUS MANUEL. Secretario: RUIZ GERMAN NEREA. Reelecciones. Presidente: NIETOCEINOS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3230 , F 201, S 8, H BI 5356,A , I/ 36 .(13.06.14).

30 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: SUBERVIOLA ORTIZ CHRISTIAN;DELGADO FERNANDEZ LUIS MARIA. Secretario: SUBERVIOLAORTIZ CHRISTIAN. Vicepresid.: DELGADO FERNANDEZ LUIS MARIA. Datos registrales. T 3230 , F 195, S 8, H BI 5356,A , I/ 34.(19.11.12).

07 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: GABIKAGOXEASKOA BENITO ALBERTO. Datos registrales. T 3230 , F 195, S 8, H BI 5356,A , I/ 33.(19.10.11).

01 de Julio de 2011
Revocaciones. Apoderado: ARRIETA ELORRIAGA BORJA. Datos registrales. T 3230 , F 194, S 8, H BI 5356,A , I/ 32 .(15.06.11).

04 de Mayo de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ BUSTINZA IGOR. Presidente: SANCHEZ BUSTINZA IGOR. Vicepresid.: RUIZ GERMANNEREA. Consejero: GUTIERREZ TELLAECHE ANGEL. Revocaciones. Apo.Manc.: SANCHEZ BUSTINZA IGOR;GUTIERREZTELLAECHE ANGEL. Nombramientos. Consejero: PEREZ MARTIN ROBERTO;NIETO CEINOS JOSE ANTONIO. Apo.Manc.:NIETO CEINOS JOSE ANTONIO;PEREZ MARTIN ROBERTO. Presidente: RUIZ GERMAN NEREA. Vicepresid.: DELGADOFERNANDEZ LUIS MARIA. Datos registrales. T 3230 , F 192, S 8, H BI 5356,A , I/ 30 .(13.04.11).

Reelecciones. Consejero: PEREZ MARTIN ROBERTO;NIETO CEINOS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3230 , F 194, S 8, HBI 5356,A , I/ 31 .(13.04.11).

24 de Marzo de 2009
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 299.310,02 Euros. Desembolsado: 299.310,02 Euros. Resultante Suscrito: 982.947,52 Euros.Resultante Desembolsado: 982.947,52 Euros. Datos registrales. T 3230 , F 190, S 8, H BI 5356,A , I/ 29 .( 6.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n