Actos BORME de Heroslam Sociedad Anonima Laboral
24 de Febrero de 2022Reelecciones. Auditor: LKS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 3230 , F 221, S 8, H BI5356,A , I/ 45 .(17.02.22).
21 de Mayo de 2021Nombramientos. Auditor: LKS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 3230 , F 220, S 8, H BI5356,A , I/ 44 .(12.05.21).
26 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER;RUIZ GERMAN NEREA. Secretario: RUIZ GERMAN NEREA.Nombramientos. Consejero: VILLORIA DIEZ LEIRE;MATESANZ BILBAO AITOR. Secretario: VILLORIA DIEZ LEIRE. Datosregistrales. T 3230 , F 207, S 8, H BI 5356,A , I/ 42 .(15.04.21).
Revocaciones. Apoderado: NIETO CEINOS JOSE ANTONIO;MARQUINA MORENO JESUS MANUEL;RUIZ GERMANNEREA;GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER;CARRO ALONSO RAUL. Nombramientos. Apoderado: NIETO CEINOS JOSEANTONIO;MARQUINA MORENO JESUS MANUEL;VILLORIA DIEZ LEIRE;CARRO ALONSO RAUL;MATESANZ BILBAOAITOR;RUIZ GERMAN NEREA. Datos registrales. T 3230 , F 208, S 8, H BI 5356,A , I/ 43 .(15.04.21).
08 de Mayo de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: SUBERVIOLA ORTIZ CHRISTIAN;RUIZ GERMAN NEREA;DELGADO FERNANDEZ LUIS MARIA;NIETOCEINOS JOSE ANTONIO;PEREZ MARTIN ROBERTO. Nombramientos. Apoderado: NIETO CEINOS JOSE ANTONIO;MARQUINAMORENO JESUS MANUEL;RUIZ GERMAN NEREA;GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER;CARRO ALONSO RAUL. Datosregistrales. T 3230 , F 206, S 8, H BI 5356,A , I/ 41 .(28.04.20).
07 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ GERMAN NEREA;MENDIOLA ANGULO ISKANDER. Secretario: RUIZ GERMAN NEREA.Nombramientos. Consejero: CARRO ALONSO RAUL;RUIZ GERMAN NEREA. Secretario: RUIZ GERMAN NEREA. Datosregistrales. T 3230 , F 206, S 8, H BI 5356,A , I/ 40 .(27.11.18).
04 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MARQUINA MORENO JESUS MANUEL;SANCHEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS;NIETO CEINOSJOSE ANTONIO. Presidente: NIETO CEINOS JOSE ANTONIO. Vicepresid.: MARQUINA MORENO JESUS MANUEL.Nombramientos. Consejero: MARQUINA MORENO JESUS MANUEL. Vicepresid.: MARQUINA MORENO JESUS MANUEL.Consejero: NIETO CEINOS JOSE ANTONIO. Presidente: NIETO CEINOS JOSE ANTONIO. Consejero: GARCIA GARCIAFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3230 , F 205, S 8, H BI 5356,A , I/ 39 .(21.12.17).
23 de Marzo de 2017Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n y nueva redacci贸n de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la Ley 44/2015 de octubrede Sociedades Laborales y Participadas.. Datos registrales. T 3230 , F 202, S 8, H BI 5356,A , I/ 38 .(16.03.17).
23 de Abril de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 16.527,50 Euros. Resultante Suscrito: 966.420,02 Euros. Modificaciones estatutarias.se modifican los art铆culos 6 y 16 de estatutos.. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.heroslam.com. Datos registrales. T 3230 , F 201, S 8, H BI 5356,A , I/ 37 .(16.04.15).
25 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Presidente: RUIZ GERMAN NEREA. Nombramientos. Consejero: MARQUINA MORENO JESUSMANUEL;SANCHEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS. Vicepresid.: PEREZ MARTIN ROBERTO. Secretario: RUIZ GERMAN NEREA.Presidente: NIETO CEINOS JOSE ANTONIO. Reelecciones. Consejero: NIETO CEINOS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T3230 , F 195, S 8, H BI 5356,A , I/ 35 .(13.06.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ GERMAN NEREA;PEREZ MARTIN ROBERTO. Vicepresid.: PEREZ MARTIN ROBERTO.Secretario: RUIZ GERMAN NEREA. Nombramientos. Consejero: MENDIOLA ANGULO ISKANDER;RUIZ GERMAN NEREA.Vicepresid.: MARQUINA MORENO JESUS MANUEL. Secretario: RUIZ GERMAN NEREA. Reelecciones. Presidente: NIETOCEINOS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3230 , F 201, S 8, H BI 5356,A , I/ 36 .(13.06.14).
30 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: SUBERVIOLA ORTIZ CHRISTIAN;DELGADO FERNANDEZ LUIS MARIA. Secretario: SUBERVIOLAORTIZ CHRISTIAN. Vicepresid.: DELGADO FERNANDEZ LUIS MARIA. Datos registrales. T 3230 , F 195, S 8, H BI 5356,A , I/ 34.(19.11.12).
07 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apoderado: GABIKAGOXEASKOA BENITO ALBERTO. Datos registrales. T 3230 , F 195, S 8, H BI 5356,A , I/ 33.(19.10.11).
01 de Julio de 2011Revocaciones. Apoderado: ARRIETA ELORRIAGA BORJA. Datos registrales. T 3230 , F 194, S 8, H BI 5356,A , I/ 32 .(15.06.11).
04 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ BUSTINZA IGOR. Presidente: SANCHEZ BUSTINZA IGOR. Vicepresid.: RUIZ GERMANNEREA. Consejero: GUTIERREZ TELLAECHE ANGEL. Revocaciones. Apo.Manc.: SANCHEZ BUSTINZA IGOR;GUTIERREZTELLAECHE ANGEL. Nombramientos. Consejero: PEREZ MARTIN ROBERTO;NIETO CEINOS JOSE ANTONIO. Apo.Manc.:NIETO CEINOS JOSE ANTONIO;PEREZ MARTIN ROBERTO. Presidente: RUIZ GERMAN NEREA. Vicepresid.: DELGADOFERNANDEZ LUIS MARIA. Datos registrales. T 3230 , F 192, S 8, H BI 5356,A , I/ 30 .(13.04.11).
Reelecciones. Consejero: PEREZ MARTIN ROBERTO;NIETO CEINOS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3230 , F 194, S 8, HBI 5356,A , I/ 31 .(13.04.11).
24 de Marzo de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 299.310,02 Euros. Desembolsado: 299.310,02 Euros. Resultante Suscrito: 982.947,52 Euros.Resultante Desembolsado: 982.947,52 Euros. Datos registrales. T 3230 , F 190, S 8, H BI 5356,A , I/ 29 .( 6.03.09).