Actos BORME de Herrenknecht Iberica Sa
06 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. D. Gerente: ANGEL AVILA FRANCISCO. Datos registrales. T 41762 , F 202, S 8, H M 198982, I/A 35(27.10.23).
04 de Octubre de 2023Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 192 8陋 - DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 41762 , F 202, S 8,H M 198982, I/A 34 (27.09.23).
03 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: HERRENKNECHT MARTIN. Presidente: HERRENKNECHT MARTIN. Cons.Del.Sol:HERRENKNECHT MARTIN. Consejero: GLATZ WERNER. Cons.Del.Sol: GLATZ WERNER. Consejero: SPRANG MICHAEL.Cons.Del.Sol: SPRANG MICHAEL. SecreNoConsj: FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO. Nombramientos. Adm. Unico: ARROYOMALPARTIDA JUAN. Modificaciones estatutarias. Se aprueba un nuevo texto de Estatutos Sociales. Otros conceptos: Cambiodel Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 12487 , F 224, S 8, H M198982, I/A 33 (26.10.21).
14 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL. Datosregistrales. T 12487 , F 223, S 8, H M 198982, I/A 32 ( 7.02.20).
13 de Febrero de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 12487 , F 223, S 8, H M 198982, I/A 31 ( 1.02.18).
13 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 12487 , F 223, S 8, H M 198982, I/A 30 ( 5.01.17).
19 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GLATZ WERNER;HERRENKNECHT MARTIN;STIEFEL KURT. Presidente: HERRENKNECHTMARTIN. Cons.Del.Sol: GLATZ WERNER;HERRENKNECHT MARTIN;STIEFEL KURT. Revocaciones. Apoderado: GARCIA SECOROBERTO;HUERTAS SIERRA GUADALUPE. Nombramientos. SecreNoConsj: FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO. Consejero:HERRENKNECHT MARTIN. Presidente: HERRENKNECHT MARTIN. Cons.Del.Sol: HERRENKNECHT MARTIN. Consejero: GLATZWERNER. Cons.Del.Sol: GLATZ WERNER. Consejero: SPRANG MICHAEL. Cons.Del.Sol: SPRANG MICHAEL. Datos registrales. T12487 , F 222, S 8, H M 198982, I/A 29 ( 8.10.15).
21 de Noviembre de 2013Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 12487 , F 222, S 8, H M 198982, I/A 28 (13.11.13).
14 de Enero de 2013Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 12487 , F 222, S 8, H M 198982, I/A 27 ( 3.01.13).
14 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: ARROYO MALPARTIDA JUAN;MONTALVO MONTALVO ANA ISABEL;BORUTZKI PATRICK.Nombramientos. Apoderado: ARROYO MALPARTIDA JUAN;BORUTZKI PATRICK;MONTALVO MONTALVO ANAISABEL;HUERTAS SIERRA GUADALUPE. Datos registrales. T 12487 , F 221, S 8, H M 198982, I/A 26 (31.10.12).
03 de Abril de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: ANGEL AVILA FRANCISCO. Nombramientos. Apo.Manc.: ARROYO MALPARTIDA JUAN;BORUTZKIPATRICK. Otros conceptos: REVOCADA LA AMPLIACION DE LOS PODERES CONFERIDOS A DON JUANARROYOMALPARTIDA Y DON FRANCISCO ANGEL AVILA, EN EL ACUERDO PRIMERO DE LA ESCRITURA QUE CAUSO LAINSCRIPCION 9&. Datos registrales. T 12487 , F 220, S 8, H M 198982, I/A 25 (23.03.12).
28 de Octubre de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 12487 , F 220, S 8, H M 198982, I/A 24 (19.10.11).
21 de Enero de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 12487 , F 220, S 8, H M 198982, I/A 23 ( 5.01.11).
17 de Enero de 2011Reelecciones. Consejero: GLATZ WERNER;HERRENKNECHT MARTIN;STIEFEL KURT. Presidente: HERRENKNECHT MARTIN.Cons.Del.Sol: GLATZ WERNER;HERRENKNECHT MARTIN;STIEFEL KURT. Secretario: FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO. Datosregistrales. T 12487 , F 219, S 8, H M 198982, I/A 22 ( 4.01.11).
28 de Enero de 2010Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 12487 , F 219, S 8, H M 198982, I/A 21 (18.01.10).