Buscador CIF Logo

Actos BORME Hexcel Fibers Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Hexcel Fibers Sl

Actos BORME Hexcel Fibers Sl - B45598463

Tenemos registrados 28 Actos BORME del Registro Mercantil de Toledo para Hexcel Fibers Sl con CIF B45598463

🔙 Perfil de Hexcel Fibers Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Toledo

Actos BORME de Hexcel Fibers Sl

22 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1738 , F 212, S 8, H TO 23613, I/A 34 (14.12.22).

24 de Agosto de 2022
Fe de erratas: Rectificado el D.N.I. del apoderado DON EDUARDO GARRANDES FERNANDEZ, siendo el correcto 71222696-E.Datos registrales. T 1738 , F 212, S 8, H TO 23613, I/A 33 (17.08.22).

26 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN GOMEZ MARIO;SEVILLA PORTERO LUIS ENRIQUE. Datos registrales. T 1738 , F 211, S 8,H TO 23613, I/A 32 (19.05.22).

20 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ALONSO LEON ALFONSO. Nombramientos. SecreNoConsj: MARTIN GOMEZ MARIO. Datosregistrales. T 1676 , F 94, S 8, H TO 23613, I/A 30 (12.05.22).

Revocaciones. Apo.Manc.: MERLOT THIERRY PHILIPPE;ALONSO LEON ALFONSO;OGAYAR CORTES JUANGABRIEL;GARRANDES FERNANDEZ EDUARDO;SEVILLA PORTERO LUIS ENRIQUE. Apo.Sol.: SEVILLA PORTERO LUISENRIQUE;ALONSO LEON ALFONSO. Apo.Manc.: ALONSO LEON ALFONSO;MARTIN GOMEZ MARIO. Nombramientos.Apo.Manc.: MERLOT THIERRY PHILIPPE;MARTIN GOMEZ MARIO;SEVILLA PORTERO LUIS ENRIQUE;OGAYAR CORTES JUANGABRIEL;GARRANDES FERNANDEZ EDUARDO. Datos registrales. T 1676 , F 94, S 8, H TO 23613, I/A 31 (12.05.22).

12 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: MARTIN GOMEZ MARIO. Datos registrales. T 1674 , F 187, S 8, H TO 23613, I/A 29 ( 3.11.21).

29 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: MACKENZIE PAUL DOMINIC. Revocaciones. Apo.Manc.: MACKENZIE PAUL DOMINIC;MERLOTTHIERRY PHILIPPE;ALONSO LEON ALFONSO;SEVILLA PORTERO LUIS ENRIQUE;OGAYAR CORTES JUANGABRIEL;GARRANDES FERNANDEZ EDUARDO. Nombramientos. Apo.Manc.: MERLOT THIERRY PHILIPPE;ALONSO LEONALFONSO;SEVILLA PORTERO LUIS ENRIQUE;OGAYAR CORTES JUAN GABRIEL;GARRANDES FERNANDEZ EDUARDO. Datosregistrales. T 1674 , F 186, S 8, H TO 23613, I/A 28 (19.03.21).

03 de Diciembre de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1674 , F 185, S 8, H TO 23613, I/A 27 (22.11.19).

11 de Diciembre de 2018
Revocaciones. Apo.Manc.: MACKENZIE PAUL DOMINIC;MERLOT THIERRY PHILIPPE;ALONSO LEON ALFONSO;SEVILLAPORTERO LUIS ENRIQUE;OGAYAR CORTES JUAN GABRIEL;GARCIA GIL RAFAEL. Nombramientos. Apo.Manc.: MACKENZIEPAUL DOMINIC;ALONSO LEON ALFONSO;SEVILLA PORTERO LUIS ENRIQUE;OGAYAR CORTES JUAN GABRIEL;GARRANDESFERNANDEZ EDUARDO;MERLOT THIERRY PHILIPPE. Datos registrales. T 1616 , F 82, S 8, H TO 23613, I/A 26 (29.11.18).

21 de Junio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: PENSKY WAYNE CHARLES. Presidente: PENSKY WAYNE CHARLES. Con.Delegado: PENSKYWAYNE CHARLES. Nombramientos. Consejero: WINTERLICH PATRICK. Presidente: WINTERLICH PATRICK. Datos registrales.T 1616 , F 82, S 8, H TO 23613, I/A 25 (12.06.18).

09 de Mayo de 2017
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: HEXCEL FINANCE HOLDING SPAIN SL. Datos registrales. T 1616, F 81, S 8, H TO 23613, I/A 23 (27.04.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: JAY KRAKOWER IRA. Nombramientos. Consejero: LEHMAN GAIL E. Datos registrales. T 1616 ,F 81, S 8, H TO 23613, I/A 24 (27.04.17).

16 de Enero de 2017
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1616 , F 81, S 8, H TO 23613, I/A 22 ( 9.01.17).

17 de Mayo de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTHONY YOUNG PETER THOMAS. Datos registrales. T 1616 , F 81, S 8, H TO 23613, I/A 21 (9.05.16).

19 de Enero de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: MACKENZIE PAUL DOMINIC;MERLOT THIERRY PHILIPPE;ALONSO LEON ALFONSO;SEVILLAPORTERO LUIS ENRIQUE;OGAYAR CORTES JUAN GABRIEL;SERNA MIGUEL JOSE MARIA. Nombramientos. Apo.Manc.:MACKENZIE PAUL DOMINIC;MERLOT THIERRY PHILIPPE;ALONSO LEON ALFONSO;SEVILLA PORTERO LUISENRIQUE;OGAYAR CORTES JUAN GABRIEL;GARCIA GIL RAFAEL. Datos registrales. T 1575 , F 21, S 8, H TO 23613, I/A 20(11.01.16).

13 de Febrero de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1575 , F 21, S 8, H TO 23613, I/A19 (23.12.13).

17 de Octubre de 2013
Revocaciones. Apo.Manc.: ALONSO LEON ALFONSO;SEVILLA PORTERO LUIS ENRIQUE;OGAYAR CORTES JUANGABRIEL;SERNA MIGUEL JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: MERLOT THIERRY PHILIPPE;MACKENZIE PAULDOMINIC;SEVILLA PORTERO LUIS ENRIQUE. Apo.Manc.: OGAYAR CORTES JUAN GABRIEL;SERNA MIGUEL JOSEMARIA;MACKENZIE PAUL DOMINIC;MERLOT THIERRY PHILIPPE;ALONSO LEON ALFONSO;SEVILLA PORTERO LUISENRIQUE. Con.Delegado: PENSKY WAYNE CHARLES. Datos registrales. T 1517 , F 147, S 8, H TO 23613, I/A 18 (10.10.13).

13 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: DOMENICHINI LOMBARDI ANDREA. Presidente: DOMENICHINI LOMBARDI ANDREA.Revocaciones. Apo.Manc.: DOMENICHINI ANDREA. Nombramientos. Presidente: PENSKY WAYNE CHARLES. Datosregistrales. T 1517 , F 147, S 8, H TO 23613, I/A 17 ( 6.05.13).

26 de Diciembre de 2012
Cambio de domicilio social. C/ CUTIDORES 15 (ILLESCAS). Datos registrales. T 1517 , F 147, S 8, H TO 23613, I/A 15(17.12.12).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1517 , F 147, S 8, H TO 23613, I/A16 (17.12.12).

04 de Abril de 2012
Revocaciones. Apo.Manc.: DOMENICHINI LOMBARDI ANDREA;ALONSO LEON ALFONSO;SEVILLA PORTERO LUISENRIQUE;OGAYAR CORTES JUAN GABRIEL;SERNA MIGUEL JOSE MARIA. Nombramientos. Apo.Manc.: DOMENICHINIANDREA;ALONSO LEON ALFONSO;SEVILLA PORTERO LUIS ENRIQUE;OGAYAR CORTES JUAN GABRIEL;SERNA MIGUELJOSE MARIA. Datos registrales. T 1517 , F 145, S 8, H TO 23613, I/A 14 (26.03.12).

05 de Abril de 2011
Revocaciones. Apo.Manc.: ALONSO LEON ALFONSO;DOMENICHINI LOMBARDI ANDREA;SEVILLA PORTERO LUIS ENRIQUE.Nombramientos. Apo.Manc.: SEVILLA PORTERO LUIS ENRIQUE;OGAYAR CORTES JUAN GABRIEL;SERNA MIGUEL JOSEMARIA;DOMENICHINI LOMBARDI ANDREA;ALONSO LEON ALFONSO. Datos registrales. T 1313 , F 76, S 8, H TO 23613, I/A 11(24.03.11).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA FERNANDEZ-REGATILLO ANGEL. Apo.Manc.: GARCIA FERNANDEZ-REGATILLOANGEL;SEVILLA PORTERO LUIS ENRIQUE;ALONSO LEON ALFONSO;SERNA MIGUEL JOSE MARIA. Datos registrales. T 1517 ,F 145, S 8, H TO 23613, I/A 12 (24.03.11).

Nombramientos. Apoderado: HEXCEL CORPORATION. Datos registrales. T 1517 , F 145, S 8, H TO 23613, I/A 13 (24.03.11).

28 de Mayo de 2010
Otros conceptos: Cambiado el número del pasaporte de Don Andrea Domenichini Lombardi, por el de AA 3692897. Datosregistrales. T 1312 , F 143, S 8, H TO 23613, I/A 10 (19.05.10).

24 de Febrero de 2010
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1312 , F 143, S 8, H TO 23613,I/A 9 (11.02.10).

07 de Abril de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO LEON ALFONSO;SEVILLA PORTERO LUIS ENRIQUE. Datos registrales. T 1312 , F 143, S8, H TO 23613, I/A 7 (27.03.09).

Nombramientos. Apo.Manc.: DE SALAMANCA CELADA IGNACIO ENRIQUE. Apo.Sol.: DE SALAMANCA CELADA IGNACIOENRIQUE. Datos registrales. T 1312 , F 143, S 8, H TO 23613, I/A 8 (27.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información