Buscador CIF Logo

Actos BORME Hidroelectrica Del Cantabrico Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Hidroelectrica Del Cantabrico Sa

Actos BORME Hidroelectrica Del Cantabrico Sa - A33000944

Tenemos registrados 65 Actos BORME del Registro Mercantil de Asturias para Hidroelectrica Del Cantabrico Sa con CIF A33000944

馃敊 Perfil de Hidroelectrica Del Cantabrico Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Asturias

Actos BORME de Hidroelectrica Del Cantabrico Sa

02 de Noviembre de 2017
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 1. Denominaci贸n social.-. Cambio de denominaci贸n social. EDP ESPA脩ASA. Datos registrales. T 3311 , F 51, S 8, H AS 14614, I/A A) (23.10.17).

19 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: FREIRE BRANDAO DE BRITO JOSE MARIA. Datos registrales. T 3311 , F 51, S 8, H AS 14614, I/A145 (10.10.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ROSSINI MASSIMO ADELMO LUCIO. Miem.Com.Ej.: ROSSINI MASSIMO ADELMO LUCIO. Datosregistrales. T 3311 , F 51, S 8, H AS 14614, I/A 146 (10.10.17).

26 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: MENENDEZ MENENDEZ MANUEL;MANSO NETO JOAO MANUEL;SAENZ DE JUBERAALVAREZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: PRAGANA DA CRUZ MORAIS JORGE. Pres.Com.Ej.: MENENDEZ MENENDEZMANUEL. Miem.Com.Ej.: PRAGANA DA CRUZ MORAIS JORGE. Nombramientos. Miem.Com.Ej.: MENENDEZ MENENDEZMANUEL;MANSO NETO JOAO MANUEL;SAENZ DE JUBERA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER. Pres.Com.Ej.: MENENDEZMENENDEZ MANUEL. Reelecciones. Consejero: MENENDEZ MENENDEZ MANUEL;MANSO NETO JOAO MANUEL;MASAVEUHERRERO FERNANDO MARIA;SAENZ DE JUBERA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: MENENDEZ MENENDEZMANUEL. Datos registrales. T 3311 , F 51, S 8, H AS 14614, I/A 144 (19.05.17).

25 de Mayo de 2017
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3311 , F 51, S 8, H AS 14614, I/A 143 (16.05.17).

21 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: SAENZ DE JUBERA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER;MATEOS VALLES MIGUEL;FERNANDEZMONTES YOLANDA;ANTU脩A EGOCHEAGA MARCOS. Datos registrales. T 3311 , F 51, S 8, H AS 14614, I/A 142 (10.03.17).

23 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: DOS SANTOS PIRES JOSE LUIS;BARRETO CHUNG NUNO MIGUEL;PERESTRELO DA CAMARARIBEIRO FERREIRA MIGUEL TIAGO;NUNES DO CARMO VITOR MANUEL;FLAVIO NUNES ANTONIO;DA MOTA FERREIRAMARINHO ANA MARIA;RIBEIRO RODRIGUES FERREIRA ISABEL MARIA;FERNANDES GASPAR MARIA ALICE DEJESUS;GOMES DE ALMEIDA CARLOS MIGUEL;BAPTISTA RASTEIRO JOCO;DOS SANTOS RODRIGUES HENRIQUE.

21 de Febrero de 2017
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: EDP ENERGIA GAS SOCIEDAD LIMITADA. NATURGAS ENERGIA SERVICIOS SA.Datos registrales. T 3311 , F 49, S 8, H AS 14614, I/A 140 (13.02.17).

11 de Enero de 2017
Revocaciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3311 , F 48, S 8, H AS 14614, I/A 138 ( 3.01.17).

14 de Noviembre de 2016
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: EDP COGENERACION SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3311 , F 48, S8, H AS 14614, I/A 137 ( 2.11.16).

19 de Mayo de 2016
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: STILWELL DE ANDRADE MIGUEL. Miem.Com.Ej.: STILWELL DE ANDRADE MIGUEL.Nombramientos. Con.Delegado: STILWELL DE ANDRADE MIGUEL. Miem.Com.Ej.: STILWELL DE ANDRADE MIGUEL.Reelecciones. Consejero: STILWELL DE ANDRADE MIGUEL. Vicepresid.: STILWELL DE ANDRADE MIGUEL. Datos registrales. T3311 , F 47, S 8, H AS 14614, I/A 136 (10.05.16).

01 de Abril de 2016
Revocaciones. Apo.Sol.: ALVAREZ DE TOLEDO SAAVEDRA JOSE. Datos registrales. T 3311 , F 47, S 8, H AS 14614, I/A 135(22.03.16).

01 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: FERNANDEZ FERNANDEZ FELIPE;PESTANA DE ALMEIDA ALVES NUNO MARIA;FREIREBRANDAO DE BRITO JOSE MARIA;MASAVEU HERRERO FERNANDO MARIA. Pres.Com.Ej.: MASAVEU HERRERO FERNANDOMARIA. Datos registrales. T 3311 , F 47, S 8, H AS 14614, I/A 133 (22.01.16).

Modificaciones estatutarias. 27. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 3311 , F 47, S 8, H AS 14614, I/A 134(22.01.16).

01 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: SUAREZ SARO JOAQUIN. Datos registrales. T 3311 , F 47, S 8, H AS 14614, I/A 132 (23.11.15).

02 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ PRADO RODRIGO. Datos registrales. T 3311 , F 46, S 8, H AS 14614, I/A 131(23.09.15).

28 de Agosto de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: SOARES DE ALBERGARIA ALMIRO RUI MANUEL;DOS SANTOS PIRES JOSE LUIS;DAPURIFICACAO CARVALHO EUGENIO ANDRE;NUNES DO CARMO VITOR MANUEL;GALHAVANO FRAGOSO JULIAEMILIA;RIBEIRO RODRIGUES FERREIRA ISABEL MARIA;FLAVIO NUNES ANTONIO;FERNANDES GASPAR MARIA ALICE DEJESUS;MARTINS LOPES ALICE PATROCINIO;DOS SANTOS RODRIGUES HENRIQUE;PERESTRELO DA CAMARA RIBEIROFERREIRA MIGUEL TIAGO;DA MOTA FERREIRA MARINHO ANA MARIA. Nombramientos. Apo.Manc.: DOS SANTOS PIRESJOSE LUIS;BARRETO CHUNG NUNO MIGUEL;PERESTRELO DA CAMARA RIBEIRO FERREIRA MIGUEL TIAGO;NUNES DOCARMO VITOR MANUEL;FLAVIO NUNES ANTONIO;DA MOTA FERREIRA MARINHO ANA MARIA;RIBEIRO RODRIGUESFERREIRA ISABEL MARIA;FERNANDES GASPAR MARIA ALICE DE JESUS;GOMES DE ALMEIDA CARLOS MIGUEL;BAPTISTA

Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA. Datos registrales. T 3311 , F 46, S 8, H AS14614, I/A 130 (20.08.15).

11 de Junio de 2015
Reelecciones. Consejero: ROSSINI MASSIMO ADELMO LUCIO. Miem.Com.Ej.: ROSSINI MASSIMO ADELMO LUCIO. Datosregistrales. T 3311 , F 45, S 8, H AS 14614, I/A 128 ( 3.06.15).

09 de Abril de 2015
Nombramientos. Miem.Com.Ej.: FERNANDEZ FERNANDEZ FELIPE;ROZA FRESNO VICTOR. Datos registrales. T 3311 , F 44, S8, H AS 14614, I/A 127 (30.03.15).

24 de Marzo de 2015
Modificaciones estatutarias. 1. Denominaci贸n.-. 5. Transmisi贸n de Acciones/Participaciones.-. 7. Transmisi贸n deAcciones/Participaciones.-. 13. Funcionamiento Junta Gral.-. 14. Funcionamiento Junta Gral.-. 19. Administraci贸n y Representacion.-.26. Administraci贸n y Representacion.-. 27. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 3311 , F 43, S 8, H AS 14614, I/A126 (13.03.15).

03 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: ASTURIANA DE ADMINISTRACION DE VALORES MOBILIARIO;NORTE脩A PATRIMONIAL SL.Miem.Com.Ej.: ASTURIANA DE ADMINISTRACION DE VALORES MOBILIARIO;NORTE脩A PATRIMONIAL SL. Nombramientos.Consejero: FERNANDEZ FERNANDEZ FELIPE;ROZA FRESNO VICTOR. Datos registrales. T 3311 , F 43, S 8, H AS 14614, I/A 125(20.02.15).

05 de Enero de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ ROCES HILARIO. Datos registrales. T 3311 , F 42, S 8, H AS 14614, I/A 124 (26.12.14).

27 de Agosto de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: SAENZ DE JUBERA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER;FERNANDEZ PRADO RODRIGO;CORTE-REALALVES PEREIRA CARLOS MANUEL;LOBO FERREIRA HENRIQUE JOSE PIMENTEL;PAES DE OLIVEIRA GOULAO ANTONIOFRANCISCO. Nombramientos. Apo.Manc.: SAENZ DE JUBERA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER;MATEOS VALLESMIGUEL;FERNANDEZ PRADO RODRIGO;SOLA PEREIRA DA MATA CARLOS MANUEL;LOBO FERREIRA HENRIQUE JOSEPIMENTEL. Datos registrales. T 3311 , F 41, S 8, H AS 14614, I/A 122 (20.08.14).

Revocaciones. Apo.Sol.: PALACIOS SOLAR RAMIRO. Nombramientos. Apo.Sol.: PALACIOS SOLAR RAMIRO. Datosregistrales. T 3311 , F 41, S 8, H AS 14614, I/A 123 (20.08.14).

28 de Julio de 2014
Nombramientos. Miem.Com.Ej.: MELO MARTINS DA COSTA ANTONIO FERNANDO;PESTANA DE ALMEIDA ALVES NUNOMARIA. Datos registrales. T 3311 , F 41, S 8, H AS 14614, I/A 121 (18.07.14).

01 de Julio de 2014
Revocaciones. Miem.Com.Ej.: MELO MARTINS DA COSTA ANTONIO FERNANDO;PESTANA DE ALMEIDA ALVES NUNO MARIA.Reelecciones. Consejero: MELO MARTINS DA COSTA ANTONIO FERNANDO;PESTANA DE ALMEIDA ALVES NUNO MARIA.Datos registrales. T 3311 , F 40, S 8, H AS 14614, I/A 120 (24.06.14).

25 de Junio de 2014
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3311 , F 40, S 8, H AS14614, I/A 119 (13.06.14).

09 de Mayo de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: PALACIO VALLE-LERSUNDI ANA. Miem.Com.Ej.: PALACIO VALLE-LERSUNDI ANA.Nombramientos. Consejero: FREIRE BRANDAO DE BRITO JOSE MARIA. Datos registrales. T 3311 , F 40, S 8, H AS 14614, I/A117 (10.04.14).

Nombramientos. Miem.Com.Ej.: FREIRE BRANDAO DE BRITO JOSE MARIA. Datos registrales. T 3311 , F 40, S 8, H AS 14614,I/A 118 (29.04.14).

16 de Abril de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA-CONDE NORIEGA EMILIO. Apo.Manc.: GARCIA-CONDE NORIEGA EMILIO. Apo.Sol.: MENDEZ-VILLAAMIL MENENDEZ MARTA. Nombramientos. Apo.Sol.: ECHEVARRIA YBARRA PELAYO. Apo.Manc.: ECHEVARRIAYBARRA PELAYO. Datos registrales. T 3311 , F 37, S 8, H AS 14614, I/A 115 ( 8.04.14).

Nombramientos. Apo.Sol.: CAREAGA ARLUNDUAGA RAFAEL. Apo.Manc.: CAREAGA ARLUNDUAGA RAFAEL. Datosregistrales. T 3311 , F 39, S 8, H AS 14614, I/A 116 ( 8.04.14).

04 de Marzo de 2014
Nombramientos. Miem.Com.Ej.: PALACIO VALLE-LERSUNDI ANA. Modificaciones estatutarias. 27. Administraci贸n yRepresentacion.-. Datos registrales. T 3311 , F 37, S 8, H AS 14614, I/A 114 (25.02.14).

17 de Enero de 2014
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ELECTRICA DE LA RIBERA DEL EBRO SA. PATRIMONIAL DE LA RIBERA DELEBRO SL. CICLO COMBINADO SOTO 5 SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3311 , F 36, S 8, H AS 14614, I/A 113 (8.01.14).

20 de Diciembre de 2013
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: HIDROCANTABRICO SERVICIOS SA. Datos registrales. T 3311 , F 35, S 8, H AS14614, I/A 111 (12.12.13).

13 de Noviembre de 2013
Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ ZORRILLA ANGEL. Apo.Sol.: FERNANDEZ ZORRILLA ANGEL;REY ARENASFRANCISCO. Apo.Manc.: REY ARENAS FRANCISCO. Nombramientos. Apo.Manc.: GIMENO RODRIGUEZ ALBERTO. Apo.Sol.:GIMENO RODRIGUEZ ALBERTO. Datos registrales. T 3311 , F 34, S 8, H AS 14614, I/A 110 ( 6.11.13).

22 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: LASSO DE LA VEGA MARTINEZ EDUARDO;GARROTE MAYORGA JOSE IGNACIO;SORIANOMARTINEZ LUIS;BERNALDO DE QUIROS ZUBIZARRETA JOSE MARIA VALENTIN;RODRIGUEZ CASES AQUILINO;MORALESDORADO MARIA DOLORES;PRIETO IBA脩EZ JOSE ANTONIO;MURGA TOME JOSE FERNANDO;FERNANDEZ CARRATALALUIS;FERNANDEZ ZORRILLA ANGEL;REY ARENAS FRANCISCO;MAYORAL BERMEJO ANTONIO;MORENO HERNANDEZSANTIAGO. Apo.Sol.: LASSO DE LA VEGA MARTINEZ EDUARDO;GARROTE MAYORGA JOSE IGNACIO;BERNALDO DE QUIROSZUBIZARRETA JOSE MARIA VALENTIN;SORIANO MARTINEZ LUIS;RODRIGUEZ CASES AQUILINO;MORALES DORADO MARIADOLORES;PRIETO IBA脩EZ JOSE ANTONIO;MURGA TOME JOSE FERNANDO;FERNANDEZ CARRATALA LUIS;FERNANDEZZORRILLA ANGEL;REY ARENAS FRANCISCO;MAYORAL BERMEJO ANTONIO;MORENO HERNANDEZ SANTIAGO. Datosregistrales. T 3311 , F 32, S 8, H AS 14614, I/A 109 (13.08.13).

25 de Junio de 2013
Revocaciones. Vicepresid.: MANSO NETO JOAO MANUEL. Miem.Com.Ej.: MENENDEZ MENENDEZ MANUEL. Pres.Com.Ej.:MENENDEZ MENENDEZ MANUEL. Miem.Com.Ej.: MANSO NETO JOAO MANUEL;PRAGANA DA CRUZ MORAISJORGE;NORTE脩A PATRIMONIAL SL;ASTURIANA DE ADMINISTRACION DE VALORES MOBILIARIO;MENENDEZ MENENDEZMANUEL. Pres.Com.Ej.: MASAVEU HERRERO FERNANDO. Nombramientos. Miem.Com.Ej.: MENENDEZ MENENDEZMANUEL;NORTE脩A PATRIMONIAL SL;PRAGANA DA CRUZ MORAIS JORGE;MANSO NETO JOAO MANUEL. Vicepresid.:STILWELL DE ANDRADE MIGUEL. Consejero: SAENZ DE JUBERA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER. Pres.Com.Ej.: MENENDEZMENENDEZ MANUEL. Miem.Com.Ej.: MASAVEU HERRERO FERNANDO;ASTURIANA DE ADMINISTRACION DE VALORESMOBILIARIO. Pres.Com.Ej.: MASAVEU HERRERO FERNANDO. Miem.Com.Ej.: SAENZ DE JUBERA ALVAREZ FRANCISCOJAVIER. Reelecciones. Consejero: MANSO NETO JOAO MANUEL;PRAGANA DA CRUZ MORAIS JORGE;MASAVEU HERREROFERNANDO;MENENDEZ MENENDEZ MANUEL;ASTURIANA DE ADMINISTRACION DE VALORES MOBILIARIO;NORTE脩APATRIMONIAL SL. Presidente: MENENDEZ MENENDEZ MANUEL. Datos registrales. T 3311 , F 32, S 8, H AS 14614, I/A 107(17.06.13).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3311 , F 32, S 8, H AS14614, I/A 108 (17.06.13).

20 de Mayo de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: SALAS ORTA JOSE. Apo.Manc.: SALAS ORTA JOSE. Datos registrales. T 3311 , F 31, S 8, H AS 14614,I/A 105 (10.05.13).

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ MORENO MARIA. Datos registrales. T 3311 , F 32, S 8, H AS 14614, I/A 106 (10.05.13).

29 de Abril de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ NOVAL LUIS. Datos registrales. T 3311 , F 31, S 8, H AS 14614, I/A 104 (18.04.13).

21 de Marzo de 2013
Revocaciones. Apo.Manc.: SOARES DE ALBERGARIA ALMIRO RUI MANUEL;DA PURIFICACAO CARVALHO EUGENIOANDRE;NUNES DO CARMO VITOR MANUEL;FLAVIO NUNES ANTONIO;DA MOTA FERREIRA MARINHO ANAMARIA;GALHAVANO FRAGOSO JULIA EMILIA;RIBEIRO RODRIGUES FERREIRA ISABEL MARIA;MARTINS LOPES ALICEPATROCINIO;FERNANDES GASPAR MARIA ALICE DE JESUS;DOS SANTOS RODRIGUES HENRIQUE. Nombramientos.Apo.Manc.: SOARES DE ALBERGARIA ALMIRO RUI MANUEL;DA PURIFICACAO CARVALHO EUGENIO ANDRE;DOS SANTOS

31 de Enero de 2013
Revocaciones. Apo.Manc.: OREJAS FERNANDEZ RODRIGO;PAZOS CAMPOS CARLOS. Apo.Sol.: MARQUES BRAVOAGUSTIN;COLLARES PEREIRA GALVAO TELES NUNO PEDRO;VELOSO CARO JULIO EDUARDO;GARCIA GALLARDO GILFOURNIER JOSE RAMON;PAZOS CAMPOS CARLOS;RUBIO VALLINA CARLOS;OREJAS FERNANDEZ RODRIGO;PINTOCORREIA CARLOS;ALCALDE BARRIO JESUS MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINS PARENTE DAMIAO. Apo.Manc.:SAENZ DE JUBERA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER;MARTINS PARENTE DAMIAO;ARRIBAS ARIAS FELIX. Datos registrales. T3311 , F 30, S 8, H AS 14614, I/A 102 (22.01.13).

04 de Diciembre de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ BLAS JOAQUIN;BENEYTO PEREZ JOSE MARIA. Apo.Manc.: PEON CADAVIECOJESUS;PEON CADAVIECO JESUS. Datos registrales. T 3311 , F 30, S 8, H AS 14614, I/A 101 (22.11.12).

01 de Octubre de 2012
Nombramientos. Consejero: MARTINEZ NOVAL LUIS. Datos registrales. T 3311 , F 30, S 8, H AS 14614, I/A 100 (19.09.12).

02 de Agosto de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: MOLERO MANGLANO CARLOS;PEDRAJAS QUILES ANTONIO;LOPEZ GARCIA DE LA RIVAIVAN;GOMEZ ALVAREZ TOMAS;ORIO GONZALEZ MARIA;MIRON PARRA EVA;TRIGUEROS RAMOS MARIA TERESA;GUTIEZSAINZ-PARDO ALEJANDRA;PRIETO RAMOS CRISTINA. Datos registrales. T 3311 , F 29, S 8, H AS 14614, I/A 99 (23.07.12).

13 de Junio de 2012
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3311 , F 29, S 8, H AS14614, I/A 98 ( 1.06.12).

04 de Mayo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: MACHADO FERNANDES ANA MARIA. Revocaciones. Con.Delegado: MANSO NETO JOAOMANUEL. Nombramientos. Consejero: STILWELL DE ANDRADE MIGUEL;PALACIO VALLE-LERSUNDI ANA. Con.Delegado:STILWELL DE ANDRADE MIGUEL. Miem.Com.Ej.: STILWELL DE ANDRADE MIGUEL. Datos registrales. T 3311 , F 28, S 8, H AS14614, I/A 97 (20.04.12).

15 de Diciembre de 2011
Otros conceptos: Rectificaci贸n de la inscripci贸n 89& por error en el t铆tulo que la caus贸 en cuanto a la omisi贸n de las siguientesfrases: "... efectivo" detr谩s de "cobro de valores" en el apartadoC; y "... y movimiento de fondos" detr谩s de "transferencia de valores" enlos apartados D y E de las facultades. Datos registrales. T 3311 , F 28, S 8, H AS 14614, I/A 96 ( 1.12.11).

19 de Octubre de 2011
Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: BERGASA CACERES FERNANDO. Consejero: BERGASA CACERES FERNANDO.Nombramientos. Consejero: ROSSINI MASSIMO ADELMO LUCIO. Miem.Com.Ej.: ROSSINI MASSIMO ADELMO LUCIO. Datosregistrales. T 3311 , F 28, S 8, H AS 14614, I/A 93 ( 7.10.11).

Revocaciones. Apo.Sol.: PALOMINO BILBAO ENRIQUE. Nombramientos. Apo.Sol.: FLOREZ FERNANDEZ JAVIER. Datosregistrales. T 3311 , F 28, S 8, H AS 14614, I/A 94 ( 7.10.11).

Revocaciones. Apo.Sol.: VALLINA DEL ROSAL VALENTIN. Nombramientos. Apo.Sol.: SALAMANCA SEGOVIANO JUANCARLOS. Datos registrales. T 3311 , F 28, S 8, H AS 14614, I/A 95 ( 7.10.11).

08 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: ARRIBAS ARIAS FELIX;BLANCO PEREZ EUGENIO. Datos registrales. T 3311 , F 27, S 8, H AS 14614,I/A 92 (25.08.11).

24 de Mayo de 2011
Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: BERGASA CACERES FERNANDO. Nombramientos. Miem.Com.Ej.: BERGASA CACERESFERNANDO. Reelecciones. Consejero: BERGASA CACERES FERNANDO. Otros conceptos: Delegaci贸n en el consejo paraacordar la emisi贸n de obligaciones, bonos pagar茅s de empresa u otros valores. Datos registrales. T 3311 , F 27, S 8, H AS 14614,I/A 91 (12.05.11).

16 de Mayo de 2011
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3311 , F 27, S 8, H AS14614, I/A 90 ( 4.05.11).

19 de Abril de 2011
Nombramientos. Apo.Manc.: SOARES DE ALBERGARIA ALMIRO RUI MANUEL;DA PURIFICACAO CARVALHO EUGENIOANDRE;NUNES DO CARMO VITOR MANUEL;FLAVIO NUNES ANTONIO;DA MOTA FERREIRA MARINHO ANAMARIA;GALHAVANO FRAGOSO JULIA EMILIA;RIBEIRO RODRIGUES FERREIRA ISABEL MARIA;MARTINS LOPES ALICEPATROCINIO;FERNANDES GASPAR MARIA ALICE DE JESUS;DOS SANTOS RODRIGUES HENRIQUE. Datos registrales. T3311 , F 26, S 8, H AS 14614, I/A 89 ( 7.04.11).

11 de Febrero de 2011
Revocaciones. Apo.Manc.: BLANCO PEDREGAL FLORENTINO;BLANCO PEDREGAL FLORENTINO. Apo.Sol.: BLANCOPEDREGAL FLORENTINO. Apo.Manc.: BLANCO PEDREGAL FLORENTINO. Apo.Sol.: ALVAREZ ARIAS DE VELASCO LUIS.Nombramientos. Apo.Sol.: MATEOS VALLES MIGUEL. Apo.Manc.: MATEOS VALLES MIGUEL;ARRIBAS ARIAS FELIX;ANTU脩AEGOCHEAGA MARCOS;SAENZ DE JUBERA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: PALOMINO BILBAO ENRIQUE. Datosregistrales. T 3311 , F 24, S 8, H AS 14614, I/A 88 ( 1.02.11).

16 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: SANTOS MORO LUIS MANUEL. Datos registrales. T 3311 , F 23, S 8, H AS 14614, I/A 87 ( 3.11.10).

18 de Junio de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRETO PITA DE ABREU ANTONIO MANUEL. Miem.Com.Ej.: BARRETO PITA DE ABREUANTONIO MANUEL. Revocaciones. Miem.Com.Ej.: PESTANA DE ALMEIDA ALVES NUNO MARIA. Nombramientos. Consejero:MELO MARTINS DA COSTA ANTONIO FERNANDO. Miem.Com.Ej.: PESTANA DE ALMEIDA ALVES NUNO MARIA;MELO MARTINSDA COSTA ANTONIO FERNANDO. Reelecciones. Consejero: PESTANA DE ALMEIDA ALVES NUNO MARIA;MACHADOFERNANDES ANA MARIA. Otros conceptos: Delegaci贸n en el conejo para acordar la emisi贸n de obligaciones, bonos pagar茅s deempresa u otros valores. Datos registrales. T 3311 , F 23, S 8, H AS 14614, I/A 86 ( 8.06.10).

04 de Junio de 2010
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3311 , F 23, S 8, H AS14614, I/A 85 (21.05.10).

04 de Agosto de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: CAPARROS GARCIA MIGUEL. Apo.Manc.: CAPARROS GARCIA MIGUEL. Datos registrales. T 3311 , F23, S 8, H AS 14614, I/A 84 (24.07.09).

09 de Junio de 2009
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3311 , F 22, S 8, H AS14614, I/A 83 (28.05.09).

Ceses/Dimisiones. Presidente: MENENDEZ MENENDEZ MANUEL. Miem.Com.Ej.: MENENDEZ MENENDEZ MANUEL;NORTE脩APATRIMONIAL SL;PRAGANA DA CRUZ MORAIS JORGE. Pres.Com.Ej.: MENENDEZ MENENDEZ MANUEL. Miem.Com.Ej.:ASTURIANA DE ADMINISTRACION DE VALORES MOBILIARIO. Vicepresid.: MANSO NETO JOAO MANUEL. Con.Delegado:MANSO NETO JOAO MANUEL. Miem.Com.Ej.: MANSO NETO JOAO MANUEL;MASAVEU HERRERO FERNANDO.Nombramientos. Presidente: MENENDEZ MENENDEZ MANUEL. Con.Delegado: MANSO NETO JOAO MANUEL. Vicepresid.:MANSO NETO JOAO MANUEL. Miem.Com.Ej.: MENENDEZ MENENDEZ MANUEL;MANSO NETO JOAO MANUEL;PRAGANA DACRUZ MORAIS JORGE;NORTE脩A PATRIMONIAL SL. Pres.Com.Ej.: MENENDEZ MENENDEZ MANUEL;MASAVEU HERREROFERNANDO. Miem.Com.Ej.: MENENDEZ MENENDEZ MANUEL;ASTURIANA DE ADMINISTRACION DE VALORES MOBILIARIO.Reelecciones. Consejero: ASTURIANA DE ADMINISTRACION DE VALORES MOBILIARIO;NORTE脩A PATRIMONIALSL;MENENDEZ MENENDEZ MANUEL;MANSO NETO JOAO MANUEL;PRAGANA DA CRUZ MORAIS JORGE;MASAVEU HERREROFERNANDO. Datos registrales. T 3311 , F 22, S 8, H AS 14614, I/A 81 (28.05.09).

16 de Marzo de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ CASAS BENIGNO. Apo.Manc.: FERNANDEZ CASAS BENIGNO;FERNANDEZ CASASBENIGNO. Datos registrales. T 3311 , F 21, S 8, H AS 14614, I/A 80 ( 4.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n