Actos BORME de Hidrofersa Fabrica De Chavin Sl
10 de Octubre de 2022Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1066/22. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 6/09/2022. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 2 DE LUGO. Juez: AURELIA BELLOFERNANDEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1066/22. Fecha de resoluci贸n 6/09/2022. Nombramiento deadministradores. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 2 DE LUGO. Juez: AURELIA BELLOFERNANDEZ. Administrador Concursal. Fecha 6/09/2022, NIF/CIF 36977783Q. NU脩EZ NU脩EZ JOSE MANUEL. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 1066/22. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 6/09/2022. Resoluciones acordando la intervenci贸n osuspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIANUMERO 2 DE LUGO. Juez: AURELIA BELLO FERNANDEZ. Datos registrales. T 469 , F 130, S 8, H LU 981, I/A A (30.09.22).
19 de Julio de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.249.962,80 Euros. Resultante Suscrito: 287.054,20 Euros. Datos registrales. T 469 , F129, S 8, H LU 981, I/A 24 (11.07.22).
25 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: PRADO CADAVID JOSE LUIS. Apo.Manc.: RODRIGUEZ REGO ALFREDO;FERNANDEZ CAOMARIA LUCIA;RODRIGUEZ FREIRE MANUEL. Datos registrales. T 469 , F 129, S 8, H LU 981, I/A 23 (11.05.18).
23 de Marzo de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ FERNANDEZ DIEGO. Datos registrales. T 469 , F 129, S 8, H LU 981, I/A 22(12.03.18).
30 de Enero de 2017Modificaciones estatutarias. El cargo de administrador ser谩 retribuido. La retribuci贸n, sin perjuicio del reembolso de los gastosdebidamente justificados en que incurran por el desempe帽o del cargo, consistir谩 en una dieta por asistencia a las reuniones delConsejo de Administraci贸n, cuyo importe ser谩 el que determine cada a帽o. Datos registrales. T 469 , F 128, S 8, H LU 981, I/A 21(19.01.17).
03 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ FREIRE MANUEL;FERNANDEZ CAO MARIA LUCIA;RODRIGUEZ REGO ALFREDO.Datos registrales. T 469 , F 128, S 8, H LU 981, I/A 19 (24.11.15).
Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ FREIRE MANUEL;FERNANDEZ CAO MARIA LUCIA;RODRIGUEZ REGO ALFREDO.
15 de Octubre de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ FERNANDEZ DIEGO. Datos registrales. T 403 , F 22, S 8, H LU 981, I/A 18 (3.10.14).
11 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: XESGALICIA S.G.E.C.R. SA. Datos registrales. T 403 , F 22, S 8, H LU 981, I/A 17 (31.07.14).
04 de Julio de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: ARAGON ESPALLARGAS SERGIO. Datos registrales. T 403 , F 22, S 8, H LU 981, I/A 16 (25.06.13).
01 de Agosto de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: ARAGON ESPALLARGAS SERGIO;FERNANDEZ CAO MARIA LUCIA;RODRIGUEZ REGO ALFREDO.Datos registrales. T 403 , F 22, S 8, H LU 981, I/A 15 (18.07.12).
02 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: MANUEL GARCIA BUEY. Presidente: MANUEL GARCIA BUEY. Consejero: RODRIGUEZ FREIREMANUEL. Vicepresid.: RODRIGUEZ FREIRE MANUEL. Consejero: RODRIGUEZ REGO ALFREDO. Secretario: RODRIGUEZ REGOALFREDO. Miem.Com.Ej.: RODRIGUEZ FREIRE MANUEL;RODRIGUEZ REGO ALFREDO;FERNANDEZ CAO MARIA LUCIA.Nombramientos. Presidente: MONSERRAT FERNANDEZ CAO. Vicepresid.: CATALINA FERNANDEZ CAO. Secretario:FERNANDEZ CAO MARIA LUCIA. Datos registrales. T 403 , F 20, S 8, H LU 981, I/A 13 (21.10.09).
Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ FREIRE MANUEL;FERNANDEZ CAO MARIA LUCIA;RODRIGUEZ REGO ALFREDO.Datos registrales. T 403 , F 21, S 8, H LU 981, I/A 14 (21.10.09).