Actos BORME de Hierros Del Noroeste Sl
22 de Agosto de 2023Nombramientos. Auditor: JP AUDITORES CONSULTORES Y ECONOMISTAS SOCIEDAD LI. Datos registrales. T 3373 , F 24, S8, H MU 574, I/A 16 (10.08.23).
21 de Marzo de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 8.654,40 Euros. Resultante Suscrito: 15.385,60 Euros. Datos registrales. T 551 , F 76, S8, H MU 574, I/A 14 (15.03.19).
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE FERNANDO DE GEA SANCHEZ. Secretario: JOSE FERNANDO DE GEA SANCHEZ.Nombramientos. Consejero: JESUS MARTIN SANCHEZ DE LA CRUZ. Secretario: JESUS MARTIN SANCHEZ DE LA CRUZ. Datosregistrales. T 3373 , F 24, S 8, H MU 574, I/A 15 (15.03.19).
29 de Junio de 2017Otros conceptos: Se modifica el punto 3 del art铆culo 9潞 de los estatutos sociales pasando a ser el cargo de administrador retribuido.-Datos registrales. T 551 , F 76, S 8, H MU 574, I/A 13 (22.06.17).
25 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: JESUS SANCHEZ FERRER. Presidente: JESUS SANCHEZ FERRER. Secretario: JOSE FERNANDOGEA SANCHEZ. Vicesecret.: ANA CRUZ MELERO. Con.Delegado: JESUS SANCHEZ FERRER. Consejero: JOSE FERNANDO DEGEA SANCHEZ;ANA DE LA CRUZ MELERO. Nombramientos. Consejero: MARIA JOSEFA SANCHEZ DE LA CRUZ;JOSEFERNANDO DE GEA SANCHEZ;ALFONSO SANCHEZ DE LA CRUZ. Presidente: MARIA JOSEFA SANCHEZ DE LA CRUZ.Secretario: JOSE FERNANDO DE GEA SANCHEZ. Vicesecret.: ALFONSO SANCHEZ DE LA CRUZ. Con.Delegado: MARIA JOSEFASANCHEZ DE LA CRUZ. Datos registrales. T 551 , F 76, S 8, H MU 574, I/A 12 (18.01.17).
28 de Febrero de 2013Reelecciones. Auditor: GABINETE DE AUDITORIA EVG SLP. Datos registrales. T 551 , F 76, S 8, H MU 574, I/A 11 (22.02.13).
21 de Agosto de 2009Nombramientos. Auditor: GABINETE DE AUDITORIA EVG SLP. Datos registrales. T 551 , F 76, S 8, H MU 574, I/A 10 (12.08.09).