Actos BORME de Higienica De Biosanitarios Sl
26 de Octubre de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 157.512,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:220.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 220.600,00 Euros. Datos registrales. T 45686 , F 74, S 8, H M 585876, I/A 26 (19.10.23).
27 de Enero de 2023Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ LOUREIRO JUAN JOSE;HUERTAS SANCHEZ MIGUEL ANGEL;HERNANDEZ LERMASILVESTRE MANUEL;DOLERA GAY JORDI EDGAR;NAVALPOTRO GOMEZ EVA MARIA;MARCO ASENSIO LAURA. Datosregistrales. T 41326 , F 29, S 8, H M 585876, I/A 25 (20.01.23).
28 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: MELGAREJO MEGIAS EUGENIO;GOMEZ BLAZQUEZ MARIA ISABEL;MORALES DOMINGUEZELENA;ALONSO RODRIGUEZ MARIA PILAR. Datos registrales. T 41326 , F 29, S 8, H M 585876, I/A 24 (20.07.22).
13 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: PONCE ALONSO ANTONIO OSCAR. Datos registrales. T 41326 , F 27, S 8, H M 585876, I/A 22 (6.07.22).
Nombramientos. Apoderado: BRU ANGELATS ANTONI;HELBIG PANEDES JORGE;DEL COTO IBARRA ALEJANDRA;UBIA PRATMARTA. Datos registrales. T 41326 , F 28, S 8, H M 585876, I/A 23 ( 6.07.22).
12 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: PONCE ALONSO ANTONIO OSCAR. Datos registrales. T 41326 , F 26, S 8, H M 585876, I/A 21 (5.07.22).
11 de Enero de 2022Nombramientos. Apoderado: MARCO ASENSIO LAURA. Datos registrales. T 41326 , F 26, S 8, H M 585876, I/A 20 ( 3.01.22).
13 de Octubre de 2021Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 3潞 y 12潞 de los estatutos sociales. Cambio de domicilio social. C/TORRELAGUNA 60 (MADRID). Datos registrales. T 41326 , F 26, S 8, H M 585876, I/A 19 ( 5.10.21).
29 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: ALONSO RODRIGUEZ ALBERTO. Datos registrales. T 41326 , F 25, S 8, H M 585876, I/A 18(22.03.21).
16 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: BORDERIA PASTOR JUAN ENRIQUE. Datos registrales. T 41326 , F 21, S 8, H M 585876, I/A 14 (9.03.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ LOUREIRO JUAN JOSE. Datos registrales. T 41326 , F 22, S 8, H M 585876, I/A 15 (9.03.21).
Revocaciones. Apo.Manc.: ALONSO RODRIGUEZ ALBERTO;PORTAS MARTAGON JOSE MANUEL. Datos registrales. T 41326 ,F 24, S 8, H M 585876, I/A 16 ( 9.03.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ GARRIDO CRISTOBAL. Datos registrales. T 41326 , F 24, S 8, H M 585876, I/A 17 (9.03.21).
03 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CLEMENTE JA脩EZ JESUS. Nombramientos. Adm. Unico: VEOLIA ESPA脩A SL. Representan:VILLALOBOS LOPEZ FRANCISCO ANTONIO. Datos registrales. T 32551 , F 47, S 8, H M 585876, I/A 5 (27.01.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO RODRIGUEZ ALBERTO. Datos registrales. T 32551 , F 48, S 8, H M 585876, I/A 6 (28.01.21).
Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ LOUREIRO JUAN JOSE;HUERTAS SANCHEZ MIGUEL ANGEL;CAMAREROCAMARERO JOSE LUIS;NAVALPOTRO GOMEZ EVA MARIA;MARCO ASENSIO LAURA. Datos registrales. T 32551 , F 49, S 8, HM 585876, I/A 7 (28.01.21).
Nombramientos. Apoderado: GAMERO MARTIN VICTOR ANDRES. Datos registrales. T 32551 , F 49, S 8, H M 585876, I/A 8(28.01.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: DE LA TORRE RAMOS LUIS FERNANDO;GONZALEZ BALLESTEROS ENRIQUE;PE脩A VARELASORAYA;GONZALEZ MARTINEZ ALEJANDRA. Datos registrales. T 32551 , F 50, S 8, H M 585876, I/A 9 (28.01.21).
Nombramientos. Apoderado: MARCO ASENSIO LAURA. Datos registrales. T 32551 , F 51, S 8, H M 585876, I/A 10 (28.01.21).
Nombramientos. Apoderado: TEJEDA HIDALGO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 32551 , F 51, S 8, H M 585876, I/A 11(28.01.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: GAMERO MARTIN VICTOR ANDRES;FONDEVILLA BARBER MIREIA CONCEPCION;GONZALEZLOUREIRO JUAN JOSE;NAVALPOTRO GOMEZ EVA MARIA. Datos registrales. T 41326 , F 20, S 8, H M 585876, I/A 12 (28.01.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: PLAZA MORENO MIGUEL. Datos registrales. T 41326 , F 20, S 8, H M 585876, I/A 13 (28.01.21).
11 de Octubre de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 150.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 157.512,00 Euros. Cambio de domicilio social. AVDA DELA ENCINA 26 (FUENLABRADA). Datos registrales. T 32551 , F 46, S 8, H M 585876, I/A 4 ( 4.10.19).
12 de Junio de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.508,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.512,00 Euros. Datos registrales. T 32551 , F 46, S 8, H M585876, I/A 3 ( 2.06.17).
12 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: ALONSO RODRIGUEZ ALBERTO;PORTAS MARTAGON JOSE MANUEL. Datos registrales. T 32551, F 44, S 8, H M 585876, I/A 2 ( 4.11.14).
07 de Agosto de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 23.07.14. Objeto social: a) El tratamiento y eliminaci贸n de residuos. b) la compra, venta,importaci贸n, exportaci贸n y distribuci贸n de productos, equipos y maquinaria para la industria, la medicina, el uso personal o losservicios; y tambi茅n de productos de alimentaci贸n y consumo humano. c) La explotaci贸n de negocios o estab. Domicilio: C/ MARIECURIE NUMERO 5, EDIFICIO ALFA , OFICINA 1 (RIVAS-VACIAMADRID). Capital: 3.004,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico:CLEMENTE JA脩EZ JESUS. Datos registrales. T 32551 , F 42, S 8, H M 585876, I/A 1 (31.07.14).