Actos BORME de Hiplus Aire Acondicionado Sl
27 de Julio de 2023Nombramientos. Apoderado: BLANCH VALLHONRAT JUAN;RAMOS GUERRA OLGA VICTORIA;SANCHEZ TORRESESTHER;SIERRA VENTURA ENRIC;SOLE GARCIA RUTH;ANDREU PHILPOTT XAVIER;NOGUERA LOPEZ HECTOR;NAVARROTRISTAN FERNANDO;REAL DIEZ JOSE LUIS;VILANOVA GIRALT LLUIS;ALCOVER ARNAU JAIME;HELLIN PINEDALUIS;HERNANDEZ TOSCA DAVID;BORI KAUFFMANN CESAR;TORNAMORELL GARCIA REGINA;ROSAL MOHEDANO EVAMARIA. Datos registrales. T 39267 , F 145, S 8, H M 537258, I/A 19 (20.07.23).
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MESTRES SOLA JORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN. Nombramientos. Adm. Unico:BLANCH VALLHONRAT JUAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 39267 , F 215, S 8, H M 537258, I/A 20 (20.07.23).
20 de Febrero de 2023Cambio de domicilio social. C/ LOPEZ DE HOYOS 35 - BAJOS (MADRID). Datos registrales. T 39267 , F 144, S 8, H M 537258,I/A 18 (13.02.23).
24 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ GANDARA MOISES. SecreNoConsj: SANCHEZ SOLE SERGIO. Consejero: MESTRESSOLA JORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN. Presidente: MESTRES SOLA JORGE. Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZGANDARA MOISES. Apo.Manc.: SANCHEZ GANDARA MOISES;SANCHEZ GANDARA MOISES. Nombramientos. Adm. Mancom.:MESTRES SOLA JORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN. Apo.Sol.: SANCHEZ SOLE SERGIO;ARTIGAS GRAU ELENA. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales.T 39267 , F 143, S 8, H M 537258, I/A 17 (17.01.23).
22 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 39267 , F 143, S 8, H M 537258,I/A 16 (15.12.22).
06 de Abril de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: MESTRES SOLA JORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN;MATA LABAJOS JOSE ANTONIO;SANCHEZGANDARA MOISES;RAMOS GUERRA OLGA VICTORIA. Datos registrales. T 39267 , F 141, S 8, H M 537258, I/A 14 (30.03.22).
18 de Enero de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 39267 , F 140, S 8, H M 537258,I/A 13 (11.01.22).
03 de Enero de 2022Revocaciones. Apoderado: RAMOS GUERRA OLGA VICTORIA;SANCHEZ GANDARA MOISES. Apo.Sol.: ALONSO GINERMANUEL;ROSENBERG GUILLERMO JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: MESTRES SOLA JORGE;SANCHEZ GANDARAMOISES;BLANCH VALLHONRAT JUAN;BLANCH VALLHONRAT JUAN;MATA LABAJOS JOSE ANTONIO;RAMOS GUERRA OLGAVICTORIA. Apo.Manc.: MESTRES SOLA JORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN;MATA LABAJOS JOSE ANTONIO;SANCHEZGANDARA MOISES;RAMOS GUERRA OLGA VICTORIA. Datos registrales. T 39267 , F 134, S 8, H M 537258, I/A 12 (27.12.21).
21 de Diciembre de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: BAXI CLIMATIZACION SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico:ROSENBERG GUILLERMO JOSE. Nombramientos. SecreNoConsj: SANCHEZ SOLE SERGIO. Consejero: MESTRES SOLAJORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN;SANCHEZ GANDARA MOISES. Presidente: MESTRES SOLA JORGE. Modificacionesestatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 13潞 de los estatutos . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 39267 , F 133, S 8, H M 537258, I/A 11 (14.12.21).
23 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apoderado: ALONSO GINER MANUEL. Datos registrales. T 39267 , F 133, S 8, H M 537258, I/A 10 (16.12.19).
01 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ GANDARA MOISES. Datos registrales. T 29859 , F 91, S 8, H M 537258, I/A 9 (24.09.19).
22 de Julio de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 29859 , F 91, S 8, H M 537258, I/A8 (15.07.19).
28 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: RAMOS GUERRA OLGA VICTORIA. Datos registrales. T 29859 , F 91, S 8, H M 537258, I/A 7(21.03.19).
22 de Enero de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 47.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 50.000,00 Euros. Datos registrales. T 29859 , F 90, S 8, H M537258, I/A 6 (14.01.19).
12 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apoderado: ALONSO GINER MANUEL. Datos registrales. T 29859 , F 89, S 8, H M 537258, I/A 5 (30.08.18).
02 de Enero de 2018Cambio de domicilio social. C/ DE LA CALENDULA 95 - EDIFICIO O, COMPLEJO MINIP (ALCOBENDAS). Datos registrales. T29859 , F 90, S 8, H M 537258, I/A 4 (21.12.17).
04 de Diciembre de 2015Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 43270 , F 184, S 8, H B422279, I/A 9 (25.11.15).
11 de Agosto de 2014Nombramientos. APODERAD.SOL: RAMOS GUERRA OLGA VICTORIA. Datos registrales. T 43270 , F 183, S 8, H B 422279, I/A8 ( 4.08.14).
11 de Noviembre de 2013Modificaciones estatutarias. ART. 16 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DEENERO Y FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA A脩O. Otros conceptos: ACLARACION DEL PLAZO DE DURACIONDEL AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD, COMO CONSECUENCIA DE LA MODIFICACION DE LA FECHA DE CIERRE DELEJERCICIO SOCIAL. Datos registrales. T 43270 , F 183, S 8, H B 422279, I/A 7 ( 4.11.13).
19 de Abril de 2013Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 43270 , F 183, S 8, H B422279, I/A 6 (12.04.13).
19 de Noviembre de 2012Nombramientos. APODERADO: RAMOS GUERRA OLGA VICTORIA. Datos registrales. T 43270 , F 182, S 8, H B 422279, I/A 5 (6.11.12).
Revocaciones. ADM.UNICO: PHI ASSET MANAGEMENT PARTNERS SGECR SA. REPR.143 RRM: BRICIO GARCIA JORDI.Nombramientos. ADM.UNICO: GUILLERMO JOSE ROSENBERG. Datos registrales. T 43270 , F 182, S 8, H B 422279, I/A 4 (6.11.12).
18 de Julio de 2012Cambio de domicilio social. CL MASIA TORRENTS Num.2 (VILANOVA I LA GELTRU). Datos registrales. T 43270 , F 181, S 8, HB 422279, I/A 3 ( 5.07.12).
04 de Junio de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO GINER MANUEL;ROSENBERG GUILLERMO JOSE. Datos registrales. T 29859 , F 85, S 8, HM 537258, I/A 2 (23.05.12).
04 de Mayo de 2012Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 20.03.12. Objeto social: A.- LA INVESTIGACION, DESARROLLO, FABRICACION,MONTAJE, TRANSFORMACION, REPARACION, INSTALACION, MATENIMIENTO, COMPRA, VENTA, COMERCIALZACION,IMPORTACION, Y EXPORTACION DE EQUIPOS, COMPONENTES Y TECNOLOGIA RELATIVOS A: ACONDICONAMIENTO DEAIRE, CLIMATIZACION, HUMIDICIFICACION, DESMUHIMIFICACION, CA. Domicilio: C/ LAGASCA 121 1潞 - CENTRO (MADRID).Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PHI FUND I F C R DE REGIMEN SIMPLIFICADO.Nombramientos. Adm. Unico: PHI ASSET MANAGEMENT PARTNERS SGECR SA. Representan: BRICIO GARCIA JORDI. Datosregistrales. T 29859 , F 82, S 8, H M 537258, I/A 1 (20.04.12).