Buscador CIF Logo

Actos BORME Hiplus Aire Acondicionado Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Hiplus Aire Acondicionado Sl

Actos BORME Hiplus Aire Acondicionado Sl - B86435658

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Hiplus Aire Acondicionado Sl con CIF B86435658

馃敊 Perfil de Hiplus Aire Acondicionado Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Hiplus Aire Acondicionado Sl

27 de Julio de 2023
Nombramientos. Apoderado: BLANCH VALLHONRAT JUAN;RAMOS GUERRA OLGA VICTORIA;SANCHEZ TORRESESTHER;SIERRA VENTURA ENRIC;SOLE GARCIA RUTH;ANDREU PHILPOTT XAVIER;NOGUERA LOPEZ HECTOR;NAVARROTRISTAN FERNANDO;REAL DIEZ JOSE LUIS;VILANOVA GIRALT LLUIS;ALCOVER ARNAU JAIME;HELLIN PINEDALUIS;HERNANDEZ TOSCA DAVID;BORI KAUFFMANN CESAR;TORNAMORELL GARCIA REGINA;ROSAL MOHEDANO EVAMARIA. Datos registrales. T 39267 , F 145, S 8, H M 537258, I/A 19 (20.07.23).

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MESTRES SOLA JORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN. Nombramientos. Adm. Unico:BLANCH VALLHONRAT JUAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 39267 , F 215, S 8, H M 537258, I/A 20 (20.07.23).

20 de Febrero de 2023
Cambio de domicilio social. C/ LOPEZ DE HOYOS 35 - BAJOS (MADRID). Datos registrales. T 39267 , F 144, S 8, H M 537258,I/A 18 (13.02.23).

24 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ GANDARA MOISES. SecreNoConsj: SANCHEZ SOLE SERGIO. Consejero: MESTRESSOLA JORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN. Presidente: MESTRES SOLA JORGE. Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZGANDARA MOISES. Apo.Manc.: SANCHEZ GANDARA MOISES;SANCHEZ GANDARA MOISES. Nombramientos. Adm. Mancom.:MESTRES SOLA JORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN. Apo.Sol.: SANCHEZ SOLE SERGIO;ARTIGAS GRAU ELENA. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales.T 39267 , F 143, S 8, H M 537258, I/A 17 (17.01.23).

22 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 39267 , F 143, S 8, H M 537258,I/A 16 (15.12.22).

06 de Abril de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: MESTRES SOLA JORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN;MATA LABAJOS JOSE ANTONIO;SANCHEZGANDARA MOISES;RAMOS GUERRA OLGA VICTORIA. Datos registrales. T 39267 , F 141, S 8, H M 537258, I/A 14 (30.03.22).

18 de Enero de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 39267 , F 140, S 8, H M 537258,I/A 13 (11.01.22).

03 de Enero de 2022
Revocaciones. Apoderado: RAMOS GUERRA OLGA VICTORIA;SANCHEZ GANDARA MOISES. Apo.Sol.: ALONSO GINERMANUEL;ROSENBERG GUILLERMO JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: MESTRES SOLA JORGE;SANCHEZ GANDARAMOISES;BLANCH VALLHONRAT JUAN;BLANCH VALLHONRAT JUAN;MATA LABAJOS JOSE ANTONIO;RAMOS GUERRA OLGAVICTORIA. Apo.Manc.: MESTRES SOLA JORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN;MATA LABAJOS JOSE ANTONIO;SANCHEZGANDARA MOISES;RAMOS GUERRA OLGA VICTORIA. Datos registrales. T 39267 , F 134, S 8, H M 537258, I/A 12 (27.12.21).

21 de Diciembre de 2021
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: BAXI CLIMATIZACION SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico:ROSENBERG GUILLERMO JOSE. Nombramientos. SecreNoConsj: SANCHEZ SOLE SERGIO. Consejero: MESTRES SOLAJORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN;SANCHEZ GANDARA MOISES. Presidente: MESTRES SOLA JORGE. Modificacionesestatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 13潞 de los estatutos . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 39267 , F 133, S 8, H M 537258, I/A 11 (14.12.21).

23 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: ALONSO GINER MANUEL. Datos registrales. T 39267 , F 133, S 8, H M 537258, I/A 10 (16.12.19).

01 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ GANDARA MOISES. Datos registrales. T 29859 , F 91, S 8, H M 537258, I/A 9 (24.09.19).

22 de Julio de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 29859 , F 91, S 8, H M 537258, I/A8 (15.07.19).

28 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: RAMOS GUERRA OLGA VICTORIA. Datos registrales. T 29859 , F 91, S 8, H M 537258, I/A 7(21.03.19).

22 de Enero de 2019
Ampliaci贸n de capital. Capital: 47.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 50.000,00 Euros. Datos registrales. T 29859 , F 90, S 8, H M537258, I/A 6 (14.01.19).

12 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: ALONSO GINER MANUEL. Datos registrales. T 29859 , F 89, S 8, H M 537258, I/A 5 (30.08.18).

02 de Enero de 2018
Cambio de domicilio social. C/ DE LA CALENDULA 95 - EDIFICIO O, COMPLEJO MINIP (ALCOBENDAS). Datos registrales. T29859 , F 90, S 8, H M 537258, I/A 4 (21.12.17).

04 de Diciembre de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 43270 , F 184, S 8, H B422279, I/A 9 (25.11.15).

11 de Agosto de 2014
Nombramientos. APODERAD.SOL: RAMOS GUERRA OLGA VICTORIA. Datos registrales. T 43270 , F 183, S 8, H B 422279, I/A8 ( 4.08.14).

11 de Noviembre de 2013
Modificaciones estatutarias. ART. 16 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DEENERO Y FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA A脩O. Otros conceptos: ACLARACION DEL PLAZO DE DURACIONDEL AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD, COMO CONSECUENCIA DE LA MODIFICACION DE LA FECHA DE CIERRE DELEJERCICIO SOCIAL. Datos registrales. T 43270 , F 183, S 8, H B 422279, I/A 7 ( 4.11.13).

19 de Abril de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 43270 , F 183, S 8, H B422279, I/A 6 (12.04.13).

19 de Noviembre de 2012
Nombramientos. APODERADO: RAMOS GUERRA OLGA VICTORIA. Datos registrales. T 43270 , F 182, S 8, H B 422279, I/A 5 (6.11.12).

Revocaciones. ADM.UNICO: PHI ASSET MANAGEMENT PARTNERS SGECR SA. REPR.143 RRM: BRICIO GARCIA JORDI.Nombramientos. ADM.UNICO: GUILLERMO JOSE ROSENBERG. Datos registrales. T 43270 , F 182, S 8, H B 422279, I/A 4 (6.11.12).

18 de Julio de 2012
Cambio de domicilio social. CL MASIA TORRENTS Num.2 (VILANOVA I LA GELTRU). Datos registrales. T 43270 , F 181, S 8, HB 422279, I/A 3 ( 5.07.12).

04 de Junio de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO GINER MANUEL;ROSENBERG GUILLERMO JOSE. Datos registrales. T 29859 , F 85, S 8, HM 537258, I/A 2 (23.05.12).

04 de Mayo de 2012
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 20.03.12. Objeto social: A.- LA INVESTIGACION, DESARROLLO, FABRICACION,MONTAJE, TRANSFORMACION, REPARACION, INSTALACION, MATENIMIENTO, COMPRA, VENTA, COMERCIALZACION,IMPORTACION, Y EXPORTACION DE EQUIPOS, COMPONENTES Y TECNOLOGIA RELATIVOS A: ACONDICONAMIENTO DEAIRE, CLIMATIZACION, HUMIDICIFICACION, DESMUHIMIFICACION, CA. Domicilio: C/ LAGASCA 121 1潞 - CENTRO (MADRID).Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PHI FUND I F C R DE REGIMEN SIMPLIFICADO.Nombramientos. Adm. Unico: PHI ASSET MANAGEMENT PARTNERS SGECR SA. Representan: BRICIO GARCIA JORDI. Datosregistrales. T 29859 , F 82, S 8, H M 537258, I/A 1 (20.04.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n