Actos BORME de Hispadul Sl
09 de Diciembre de 2022Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6913 , F 12, S 8, H SE 11729, I/A 14 (30.11.22).
01 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: SANTOS VELEZ LUIS. Secretario: SANTOS VELEZ LUIS. Cons.Del.Sol: SANTOS VELEZ LUIS.Nombramientos. Consejero: SANTOS PEREZ LUIS FRANCISCO. Secretario: SANTOS PEREZ LUIS FRANCISCO. Cons.Del.Sol:SANTOS PEREZ LUIS FRANCISCO. Datos registrales. T 1671 , F 72, S 8, H SE 11729, I/A 12 (18.09.20).
Modificaciones estatutarias. Artículo 5.- CAPITAL SOCIAL. Artículo 9 - REGIMEN DE LA TRANSMISION VOLUNTARIA PORACTOS INTER VIVOS. ADICION de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales, el artículo 9.bis.-. ADICION de un nuevo artículo a losEstatutos Sociales, el artículo 9.ter.-. ADICION de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales, el artículo 9.quarter.-. ADICION de unnuevo artículo a los Estatutos Sociales, el artículo 9.quinquies.-. ADICION de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales, el artículo8.bis.-. ARTICULO 19.- Duración del cargo y retribución. Datos registrales. T 6913 , F 11, S 8, H SE 11729, I/A 13 (18.09.20).
17 de Diciembre de 2019Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1671 , F 72, S 8, H SE 11729, I/A 11 (10.12.19).
25 de Septiembre de 2017Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social.-. Ampliaciondel objeto social. Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.Cambio de domicilio social. AVDA ZOTAL 1 - POLIGONO INDUSTRIAL PARQUE PLATA, C (CAMAS). Datos registrales. T 1671 ,F 72, S 8, H SE 11729, I/A 10 (15.09.17).
14 de Diciembre de 2016Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1671 , F 71, S 8, H SE 11729, I/A 9 ( 5.12.16).
02 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: ESTEVAN MORELL ANGELES. Datos registrales. T 1671 , F 70, S 8, H SE 11729, I/A 8 (23.02.16).
30 de Julio de 2015Modificaciones estatutarias. 19. Duración del cargo y retribución.-. Datos registrales. T 1671 , F 70, S 8, H SE 11729, I/A 7(22.07.15).
12 de Marzo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ PRIETO VICTORIA;PEREZ GOMEZ MANUELA. Presidente: FERNANDEZ PRIETOVICTORIA. Secretario: PEREZ GOMEZ MANUELA. Cons.Del.Sol: PEREZ GOMEZ MANUELA. Consejero: DULCESA SA.Cons.Del.Sol: DULCESA SA. Nombramientos. Consejero: JUAN FERNANDEZ JUAN JOSE. Presidente: JUAN FERNANDEZ JUANJOSE. Consejero: SANTOS VELEZ LUIS. Secretario: SANTOS VELEZ LUIS. Consejero: JUAN FERNANDEZ RAFAEL. Cons.Del.Sol:JUAN FERNANDEZ JUAN JOSE;SANTOS VELEZ LUIS;JUAN FERNANDEZ RAFAEL. Datos registrales. T 1671 , F 69, S 8, H SE11729, I/A 6 ( 2.03.10).