Actos BORME de Hispanica De Caldereria Sal
20 de Diciembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL;AGUNDEZ PLANO FERNANDO. Presidente: AGUNDEZPLANO FERNANDO. Vicepresid.: SANTOS VAQUERO DAVID. Secretario: GARCIA SOLIS FRANCISCO. Nombramientos.Consejero: MORA GARCIA FRANCISCO;DOMINGUEZ ANTON MANUEL JOAQUIN. Presidente: SANTOS VAQUERO DAVID.Secretario: AGUNDEZ FLORES FERNANDO. Vicepresid.: GARCIA SOLIS FRANCISCO. Datos registrales. T 38583 , F 105, S 8, HM 482, I/A 49 (13.12.23).
Revocaciones. Apoderado: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Apoderado: GARCIA SOLIS FRANCISCO.Datos registrales. T 38583 , F 106, S 8, H M 482, I/A 50 (13.12.23).
12 de Junio de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 15.880,00 Euros. Resultante Suscrito: 144.300,00 Euros. Datos registrales. T 38583 , F105, S 8, H M 482, I/A 48 ( 3.06.23).
25 de Mayo de 2022Reelecciones. Auditor: CAPITAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 38583 , F 104, S 8, H M 482, I/A 47 (18.05.22).
16 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. Presidente: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: AGUNDEZ PLANOFERNANDO. Presidente: AGUNDEZ PLANO FERNANDO. Reelecciones. Vicepresid.: SANTOS VAQUERO DAVID. Secretario:GARCIA SOLIS FRANCISCO. Datos registrales. T 38583 , F 104, S 8, H M 482, I/A 46 ( 9.07.20).
29 de Julio de 2019Reelecciones. Consejero: AGUNDEZ FLORES FERNANDO;SANTOS VAQUERO DAVID;CASTA脩EDA PEREZ JOSEMANUEL;MORA GARCIA JOSE ANTONIO;LLORENTE FERNANDEZ-CABALLERO ESTHER;GARCIA SOLIS FRANCISCO.Presidente: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Vicepresid.: SANTOS VAQUERO DAVID. Secretario: GARCIA SOLISFRANCISCO. Datos registrales. T 38583 , F 103, S 8, H M 482, I/A 45 (22.07.19).
27 de Mayo de 2019Reelecciones. Auditor: CAPITAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 11285 , F 103, S 8, H M 482, I/A 44 (20.05.19).
12 de Abril de 2019Modificaciones estatutarias. 1-32. MODIFICADOS LOS ESTATUTOS SOCIALES. Otros conceptos: MODIFICADOS YADAPTADOS LOS ESTATUTOS SOCIALES A LAS MODIFICACIONES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Y LA LEY44/2015. DE 14 DE OCTUBRE, DE SOCIEDADES LABORALES Y PARTICIPADAS. Datos registrales. T 11285 , F 199, S 8, H M482, I/A 43 ( 5.04.19).
10 de Abril de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 15.230,00 Euros. Resultante Suscrito: 160.180,00 Euros. Datos registrales. T 11285 , F199, S 8, H M 482, I/A 42 ( 3.04.19).
07 de Julio de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 8.030,00 Euros. Resultante Suscrito: 175.410,00 Euros. Datos registrales. T 11285 , F198, S 8, H M 482, I/A 41 (30.06.16).
06 de Julio de 2016Reelecciones. Auditor: CAPITAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 11285 , F 198, S 8, H M 482, I/A 40 (29.06.16).
22 de Agosto de 2014Revocaciones. Apoderado: MORA PEREZ FRANCISCO. Apo.Sol.: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Apoderado: AGUNDEZPLANO FERNANDO;SANTOS VAQUERO DAVID. Datos registrales. T 11285 , F 179, S 8, H M 482, I/A 36 (14.08.14).
Nombramientos. Apoderado: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 11285 , F 179, S 8, H M 482, I/A 37(14.08.14).
Nombramientos. Apoderado: SANTOS VAQUERO DAVID. Datos registrales. T 11285 , F 196, S 8, H M 482, I/A 38 (14.08.14).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA SOLIS FRANCISCO. Datos registrales. T 11285 , F 198, S 8, H M 482, I/A 39 (14.08.14).
19 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUNDEZ PLANO FERNANDO. Presidente: AGUNDEZ PLANO FERNANDO. Vicepresid.:CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Secretario: SANTOS VAQUERO DAVID. Nombramientos. Consejero: AGUNDEZ FLORESFERNANDEZ. Presidente: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Vicepresid.: SANTOS VAQUERO DAVID. Secretario: GARCIASOLIS FRANCISCO. Reelecciones. Consejero: SANTOS VAQUERO DAVID;CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL;MORA GARCIAJOSE ANTONIO;LLORENTE FERNANDEZ-CABALLERO ETHER;GARCIA SOLIS FRANCISCO. Modificaciones estatutarias. 5潞.Capital social. Otros conceptos: SE TRANFORMAN LAS ACCIONES NUMERO DEL 6973 AL 10372, AMBAS INCLUSIVE, DEACCIONES DE LA CLASE A, DE CLASE LABORAL, RESERVADAS A LOS SOCIOS TRABAJADORES, A ACCIONES DE LA CLASEB, DE CLASE GENERAL, MODIFICANDOSE EL ARTICULO 5潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 11285 , F178, S 8, H M 482, I/A 35 (11.08.14).
17 de Octubre de 2013Nombramientos. Auditor: CAPITAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 11285 , F 178, S 8, H M 482, I/A 34 ( 9.10.13).
21 de Junio de 2012Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3潞. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ PORTUGAL 56(MEJORADA DEL CAMPO). Datos registrales. T 11285 , F 178, S 8, H M 482, I/A 33 (11.06.12).
12 de Marzo de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 14.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 183.440,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 11285 , F 177, S 8, H M 482, I/A 32 (28.02.12).
22 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: SANZ DOCTOR PEDRO. Nombramientos. Consejero: LLORENTE FERNANDEZ-CABALLEROETHER;GARCIA SOLIS FRANCISCO. Datos registrales. T 11285 , F 177, S 8, H M 482, I/A 31 (13.06.11).
23 de Febrero de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 23.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 197.440,00 Euros. Datos registrales. T 11285 , F177, S 8, H M 482, I/A 30 (11.02.11).
01 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTRELO GARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 11285 , F 176, S 8, H M 482, I/A 29(21.06.10).
24 de Marzo de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 25.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 220.440,00 Euros. Datos registrales. T 11285 , F176, S 8, H M 482, I/A 28 (11.03.10).
15 de Diciembre de 2009Nombramientos. Auditor: CAPITAL AUDITORES SLP. Reelecciones. Consejero: SANTOS VAQUERO DAVID. Secretario:SANTOS VAQUERO DAVID. Consejero: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Vicepresid.: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL.Consejero: AGUNDEZ PLANO FERNANDO. Presidente: AGUNDEZ PLANO FERNANDO. Consejero: CASTRELO GARCIA JOSEMANUEL;SANZ DOCTOR PEDRO;MORA GARCIA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 11285 , F 175, S 8, H M 482, I/A 27 (3.12.09).
30 de Enero de 2009Reelecciones. Auditor: CAPITAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 11285 , F 175, S 8, H M 482, I/A 26 (21.01.09).