Buscador CIF Logo

Actos BORME Hispanica De Caldereria Sal

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Hispanica De Caldereria Sal

Actos BORME Hispanica De Caldereria Sal - A79382610

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Hispanica De Caldereria Sal con CIF A79382610

馃敊 Perfil de Hispanica De Caldereria Sal
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Hispanica De Caldereria Sal

20 de Diciembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL;AGUNDEZ PLANO FERNANDO. Presidente: AGUNDEZPLANO FERNANDO. Vicepresid.: SANTOS VAQUERO DAVID. Secretario: GARCIA SOLIS FRANCISCO. Nombramientos.Consejero: MORA GARCIA FRANCISCO;DOMINGUEZ ANTON MANUEL JOAQUIN. Presidente: SANTOS VAQUERO DAVID.Secretario: AGUNDEZ FLORES FERNANDO. Vicepresid.: GARCIA SOLIS FRANCISCO. Datos registrales. T 38583 , F 105, S 8, HM 482, I/A 49 (13.12.23).

Revocaciones. Apoderado: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Apoderado: GARCIA SOLIS FRANCISCO.Datos registrales. T 38583 , F 106, S 8, H M 482, I/A 50 (13.12.23).

12 de Junio de 2023
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 15.880,00 Euros. Resultante Suscrito: 144.300,00 Euros. Datos registrales. T 38583 , F105, S 8, H M 482, I/A 48 ( 3.06.23).

25 de Mayo de 2022
Reelecciones. Auditor: CAPITAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 38583 , F 104, S 8, H M 482, I/A 47 (18.05.22).

16 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Presidente: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: AGUNDEZ PLANOFERNANDO. Presidente: AGUNDEZ PLANO FERNANDO. Reelecciones. Vicepresid.: SANTOS VAQUERO DAVID. Secretario:GARCIA SOLIS FRANCISCO. Datos registrales. T 38583 , F 104, S 8, H M 482, I/A 46 ( 9.07.20).

29 de Julio de 2019
Reelecciones. Consejero: AGUNDEZ FLORES FERNANDO;SANTOS VAQUERO DAVID;CASTA脩EDA PEREZ JOSEMANUEL;MORA GARCIA JOSE ANTONIO;LLORENTE FERNANDEZ-CABALLERO ESTHER;GARCIA SOLIS FRANCISCO.Presidente: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Vicepresid.: SANTOS VAQUERO DAVID. Secretario: GARCIA SOLISFRANCISCO. Datos registrales. T 38583 , F 103, S 8, H M 482, I/A 45 (22.07.19).

27 de Mayo de 2019
Reelecciones. Auditor: CAPITAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 11285 , F 103, S 8, H M 482, I/A 44 (20.05.19).

12 de Abril de 2019
Modificaciones estatutarias. 1-32. MODIFICADOS LOS ESTATUTOS SOCIALES. Otros conceptos: MODIFICADOS YADAPTADOS LOS ESTATUTOS SOCIALES A LAS MODIFICACIONES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Y LA LEY44/2015. DE 14 DE OCTUBRE, DE SOCIEDADES LABORALES Y PARTICIPADAS. Datos registrales. T 11285 , F 199, S 8, H M482, I/A 43 ( 5.04.19).

10 de Abril de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 15.230,00 Euros. Resultante Suscrito: 160.180,00 Euros. Datos registrales. T 11285 , F199, S 8, H M 482, I/A 42 ( 3.04.19).

07 de Julio de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 8.030,00 Euros. Resultante Suscrito: 175.410,00 Euros. Datos registrales. T 11285 , F198, S 8, H M 482, I/A 41 (30.06.16).

06 de Julio de 2016
Reelecciones. Auditor: CAPITAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 11285 , F 198, S 8, H M 482, I/A 40 (29.06.16).

22 de Agosto de 2014
Revocaciones. Apoderado: MORA PEREZ FRANCISCO. Apo.Sol.: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Apoderado: AGUNDEZPLANO FERNANDO;SANTOS VAQUERO DAVID. Datos registrales. T 11285 , F 179, S 8, H M 482, I/A 36 (14.08.14).

Nombramientos. Apoderado: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 11285 , F 179, S 8, H M 482, I/A 37(14.08.14).

Nombramientos. Apoderado: SANTOS VAQUERO DAVID. Datos registrales. T 11285 , F 196, S 8, H M 482, I/A 38 (14.08.14).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA SOLIS FRANCISCO. Datos registrales. T 11285 , F 198, S 8, H M 482, I/A 39 (14.08.14).

19 de Agosto de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUNDEZ PLANO FERNANDO. Presidente: AGUNDEZ PLANO FERNANDO. Vicepresid.:CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Secretario: SANTOS VAQUERO DAVID. Nombramientos. Consejero: AGUNDEZ FLORESFERNANDEZ. Presidente: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Vicepresid.: SANTOS VAQUERO DAVID. Secretario: GARCIASOLIS FRANCISCO. Reelecciones. Consejero: SANTOS VAQUERO DAVID;CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL;MORA GARCIAJOSE ANTONIO;LLORENTE FERNANDEZ-CABALLERO ETHER;GARCIA SOLIS FRANCISCO. Modificaciones estatutarias. 5潞.Capital social. Otros conceptos: SE TRANFORMAN LAS ACCIONES NUMERO DEL 6973 AL 10372, AMBAS INCLUSIVE, DEACCIONES DE LA CLASE A, DE CLASE LABORAL, RESERVADAS A LOS SOCIOS TRABAJADORES, A ACCIONES DE LA CLASEB, DE CLASE GENERAL, MODIFICANDOSE EL ARTICULO 5潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 11285 , F178, S 8, H M 482, I/A 35 (11.08.14).

17 de Octubre de 2013
Nombramientos. Auditor: CAPITAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 11285 , F 178, S 8, H M 482, I/A 34 ( 9.10.13).

21 de Junio de 2012
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3潞. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ PORTUGAL 56(MEJORADA DEL CAMPO). Datos registrales. T 11285 , F 178, S 8, H M 482, I/A 33 (11.06.12).

12 de Marzo de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 14.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 183.440,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 11285 , F 177, S 8, H M 482, I/A 32 (28.02.12).

22 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANZ DOCTOR PEDRO. Nombramientos. Consejero: LLORENTE FERNANDEZ-CABALLEROETHER;GARCIA SOLIS FRANCISCO. Datos registrales. T 11285 , F 177, S 8, H M 482, I/A 31 (13.06.11).

23 de Febrero de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 23.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 197.440,00 Euros. Datos registrales. T 11285 , F177, S 8, H M 482, I/A 30 (11.02.11).

01 de Julio de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTRELO GARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 11285 , F 176, S 8, H M 482, I/A 29(21.06.10).

24 de Marzo de 2010
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 25.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 220.440,00 Euros. Datos registrales. T 11285 , F176, S 8, H M 482, I/A 28 (11.03.10).

15 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Auditor: CAPITAL AUDITORES SLP. Reelecciones. Consejero: SANTOS VAQUERO DAVID. Secretario:SANTOS VAQUERO DAVID. Consejero: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL. Vicepresid.: CASTA脩EDA PEREZ JOSE MANUEL.Consejero: AGUNDEZ PLANO FERNANDO. Presidente: AGUNDEZ PLANO FERNANDO. Consejero: CASTRELO GARCIA JOSEMANUEL;SANZ DOCTOR PEDRO;MORA GARCIA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 11285 , F 175, S 8, H M 482, I/A 27 (3.12.09).

30 de Enero de 2009
Reelecciones. Auditor: CAPITAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 11285 , F 175, S 8, H M 482, I/A 26 (21.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n