Buscador CIF Logo

Actos BORME Hispaninver Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Hispaninver Sl

Actos BORME Hispaninver Sl - B78535325

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Hispaninver Sl con CIF B78535325

馃敊 Perfil de Hispaninver Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Hispaninver Sl

22 de Abril de 2022
Nombramientos. Apoderado: RUBIO MERINO ANTONIO. Datos registrales. T 26413 , F 87, S 8, H M 76615, I/A 55 (13.04.22).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: GIMENO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 43037 , F 201, S 8, H M 76615, I/A56 (13.04.22).

31 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ RANERO JUAN CARLOS. Apo.Sol.: SANCHEZ RANERO JUAN CARLOS. Apoderado:SANCHEZ RANERO JUAN CARLOS;SANCHEZ RANERO JUAN CARLOS. Apo.Man.Soli: SANCHEZ RANERO JUAN CARLOS.Otros conceptos: REVOCADO EL PODER CONFERIDO A DON JUAN CARLOS SANCHEZ RANERO QUE CAUSO LAINSCRIPCION 49陋 DE LA HOJA SOCIAL. Datos registrales. T 26413 , F 86, S 8, H M 76615, I/A 54 (24.03.21).

03 de Diciembre de 2020
Cambio de domicilio social. C/ SANTA SABINA 8 2 (MADRID). Datos registrales. T 26413 , F 86, S 8, H M 76615, I/A 52(26.11.20).

Revocaciones. Apoderado: DE BORBON DOS SICILIAS Y DE ORLEANS PEDRO JUAN;MORALES MORALES ALFONSO;DEBORBON DOS SICILIAS Y DE ORLEANS PEDRO JUAN. Datos registrales. T 26413 , F 86, S 8, H M 76615, I/A 53 (26.11.20).

14 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: REVOREDO DELVECCHIO HELENA IRENE. Nombramientos. Adm. Unico: GUBEL SL.Representan: GUT REVOREDO BARBARA. Datos registrales. T 26413 , F 86, S 8, H M 76615, I/A 51 ( 3.01.20).

03 de Agosto de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUERRA GARCIA FRANCISCO JAVIER;FERNANDEZ ALONSO LORENZO. Datos registrales. T26413 , F 82, S 8, H M 76615, I/A 50 (27.07.17).

03 de Noviembre de 2014
Otros conceptos: Subsanaci贸n de la inscripci贸n 48 de esta hoja social. Datos registrales. T 26413 , F 79, S 8, H M 76615, I/A 49(24.10.14).

28 de Julio de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GIMENO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER;SANCHEZ RANERO JUAN CARLOS. Datosregistrales. T 26413 , F 76, S 8, H M 76615, I/A 48 (21.07.14).

24 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: DE BORBON DOS SICILIAS Y DE ORLEANS PEDRO JUAN. Datos registrales. T 26413 , F 76, S 8,H M 76615, I/A 47 (17.12.12).

25 de Julio de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 8.829.684,28 Euros. Resultante Suscrito: 5.172.005,04 Euros. Datos registrales. T 26413, F 75, S 8, H M 76615, I/A 46 (13.07.12).

20 de Diciembre de 2011
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GUBEL SL. Datos registrales. T 26413 , F 75, S 8, H M 76615, I/A 45 ( 5.12.11).

13 de Diciembre de 2011
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 140 11 B (MADRID). Datos registrales. T 26413 , F 75, S 8, H M 76615,I/A 44 (29.11.11).

11 de Noviembre de 2010
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 140 10 B (MADRID). Datos registrales. T 26413 , F 75, S 8, H M 76615,I/A 43 (28.10.10).

24 de Marzo de 2010
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ IBOR ALCOCER JAIME. Nombramientos. Apoderado: EGIDO VOLLANDT INES. Datosregistrales. T 26413 , F 71, S 8, H M 76615, I/A 42 (12.03.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n