Actos BORME de Hm Hospitales De Galicia Sl
27 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: GARCIA PEREZ ARANCHA. Datos registrales. T 32168 , F 43, S 8, H M 578864, I/A 12 (20.10.22).
10 de Enero de 2022Nombramientos. Apoderado: DIEZ ANDRES FLORENTINO. Datos registrales. T 32168 , F 42, S 8, H M 578864, I/A 11 (31.12.21).
09 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: BELTRAN GAMIR RAFAEL BJORN. Datos registrales. T 32168 , F 41, S 8, H M 578864, I/A 10 (2.04.21).
04 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: GARCIA PEREZ ARANCHA. Datos registrales. T 32168 , F 41, S 8, H M 578864, I/A 9 (25.02.21).
19 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: ABARCA CIDON ALEJANDRO. Datos registrales. T 32168 , F 39, S 8, H M 578864, I/A 8 (11.06.18).
19 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y DE LA EMPRESA SA. Representan: ABARCA CIDONALEJANDRO. Nombramientos. Consejero: COBIAN CASARES RAMON JULIO CESAR;ABARCA CIDON JUAN;ABARCA CIDONALEJANDRO;FERNANDEZ-ALBOR BALTAR ANGEL;ABARCA CIDON ELENA. Presidente: COBIAN CASARES RAMON JULIOCESAR. SecreNoConsj: LOPEZ RUBAL JOSE ANTONIO. Modificaciones estatutarias. HA QUEDADO SUPRIMIDO EL VOTO DECALIDAD DEL PRESIDENTE Y HA QUEDADO MODIFICADO EL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 32168 , F38, S 8, H M 578864, I/A 7 ( 8.03.18).
07 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: BELTRAN GAMIR RAFAEL BJORN. Datos registrales. T 32168 , F 37, S 8, H M 578864, I/A 5(31.01.17).
Nombramientos. Apoderado: ABARCA CIDON ELENA. Datos registrales. T 32168 , F 38, S 8, H M 578864, I/A 6 (31.01.17).
02 de Noviembre de 2016Cambio de domicilio social. PLAZA DEL CONDE DEL VALLE SUCHIL 2 (MADRID). Datos registrales. T 32168 , F 37, S 8, H M578864, I/A 4 (21.10.16).