Actos BORME de Hnos Zara Velez Sl
20 de Julio de 2021Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ LIGERO FRANCISCA. Datos registrales. T 1269 , F 98, S 8, H CA 15814, I/A 7 (12.07.21).
22 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: ZARA VELEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 1269 , F 97, S 8, H CA 15814, I/A 6 (15.06.21).
03 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ZARA VELEZ DIEGO. Presidente: ZARA VELEZ DIEGO. Con.Delegado: ZARA VELEZ DIEGO.Secretario: ZARA VELEZ FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: ZARA VELEZ JOSE MARIA. Presidente: ZARA VELEZFRANCISCO. Secretario: ZARA VELEZ CRISTOBAL. Datos registrales. T 1269 , F 96, S 8, H CA 15814, I/A 5 (26.11.20).
30 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: MORILLO PEREZ MANUEL. Datos registrales. T 1269 , F 96, S 8, H CA 15814, I/A 4 (19.05.17).
23 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ZARA VELEZ DIEGO. Nombramientos. Consejero: ZARA VELEZ DIEGO;ZARA VELEZCRISTOBAL;ZARA VELEZ FRANCISCO. Presidente: ZARA VELEZ DIEGO. Secretario: ZARA VELEZ FRANCISCO. Con.Delegado:ZARA VELEZ DIEGO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 1269 , F 95, S 8, H CA 15814, I/A 3 (11.12.09).