Actos BORME de Hogares Carugran Sa
31 de Mayo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: MARIAM VAZQUEZ HURTADO. Datos registrales. T 1745 , F 126, S 8, H GR 42617, I/A 52 (23.05.23).
01 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: IGNACIO VELASCO SANCHEZ. Datos registrales. T 1745 , F 126, S 8, H GR 42617, I/A 51(24.11.22).
02 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: MARIA TERESA RODERO FRIAS. Datos registrales. T 1745 , F 125, S 8, H GR 42617, I/A 48(24.10.22).
Revocaciones. Apo.Manc.: SCHMOLLING GUINOVART ANGEL LUIS. Apo.Man.Soli: SCHMOLLING GUINOVART ANGELLUIS;SANCHEZ MU脩OZ FRANCISCO;TERRON MORENO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1745 , F 125, S 8, H GR 42617,I/A 49 (25.10.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARIA TERESA RODERO FRIAS. Datos registrales. T 1745 , F 125, S 8, H GR 42617, I/A 50(25.10.22).
09 de Junio de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: VICENTE EMILIO CARRION SANCHEZ. Datos registrales. T 1745 , F 123, S 8, H GR 42617, I/A46 ( 1.06.22).
Nombramientos. Apoderado: VICENTE EMILIO CARRION SANCHEZ. Datos registrales. T 1745 , F 124, S 8, H GR 42617, I/A 47 (1.06.22).
13 de Enero de 2022Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ GUERRERO MANUEL;GORDO FUENTES MARIA JESUS. Apo.Man.Soli: VILLENAMARTINEZ BERNARDINO. Datos registrales. T 1745 , F 123, S 8, H GR 42617, I/A 44 ( 5.01.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALJARO SANCHEZ RAFAEL CARLOS;BECERRA GARCIA MARIA JESUS;LOPEZ BLANCOVICTOR;VAZQUEZ HURTADO MARIAM;DOMINGUEZ MARTINEZ ANDRES;FERNANDEZ JIMENEZ CARMEN MAGDALENA. Datosregistrales. T 1745 , F 123, S 8, H GR 42617, I/A 45 ( 5.01.22).
28 de Julio de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: CUESTA ORTIZ BALTASAR;JIMENEZ LOPEZ FRANCISCO. Apo.Sol.: JIMENEZ LOPEZFRANCISCO. Datos registrales. T 1745 , F 122, S 8, H GR 42617, I/A 43 (20.07.21).
14 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ-NOGUERAS JIMENEZ MATILDE CELIA;RODRIGUEZ MARTINEZ ANTONIO-JACINTO;TEJERO BERHEIDE RAMON JOSE;ALONSO CONDE VIRGINIA MARIA. Datos registrales. T 1745 , F 122, S 8, H GR42617, I/A 41 ( 7.04.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: OLEA LIROLA CARLOS;ALONSO CONDE VIRGINIA;RUIZ HIDALGO RAFAELA;TEJEROBERHEIDE RAMON JOSE. Datos registrales. T 1745 , F 122, S 8, H GR 42617, I/A 42 ( 7.04.21).
15 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILLENA MARTINEZ BERNARDINO. Datos registrales. T 1688 , F 220, S 8, H GR 42617, I/A 40 (8.03.21).
26 de Octubre de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: VILLAMON DEL CUBO FERNANDO. Datos registrales. T 1688 , F 219, S 8, H GR 42617, I/A 38(15.10.20).
Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ MARTINEZ IVAN. Datos registrales. T 1688 , F 219, S 8, H GR 42617, I/A 39(15.10.20).
07 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: PESO FERNANDEZ FERNANDO. Datos registrales. T 1688 , F 218, S 8, H GR 42617, I/A 36(31.07.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: LUQUE FRIAS GERENIMO SIMON;OLEA LIROLA CARLOS;SERRANO REIFS ANTONIO;JIMENEZRUIZ JORGE JOSE;SENEN DEL PINO GONZALEZ MIGUEL;HERNANDEZ RUIZ JOSE AURELIO. Datos registrales. T 1688 , F219, S 8, H GR 42617, I/A 37 (31.07.20).
25 de Junio de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: INDRA BPO SOCIEDAD LIMITADA. Apoderado: INDRA BPO SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T1688 , F 218, S 8, H GR 42617, I/A 35 (18.06.20).
21 de Enero de 2020Nombramientos. Apoderado: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA. Datos registrales. T 1688 , F 218, S 8, H GR42617, I/A 33 (14.01.20).
Nombramientos. Apoderado: QUI脩OZ GALLARDO ENCARNACION;QUESADA ENCISO CONCEPCION;GORDO FUENTES MARIAJESUS;MARTIN MARTINEZ JOSE MANUEL;JIMENEZ GUERRERO MANUEL;CILLERO PE脩UELA MARIA DELCARMEN;ESCORIZA MARTIN ELISABET. Datos registrales. T 1688 , F 218, S 8, H GR 42617, I/A 34 (14.01.20).
26 de Julio de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA TORRES SANDRA. Apo.Man.Soli: GARCIA TORRES SANDRA. Datos registrales. T 1688 , F217, S 8, H GR 42617, I/A 32 (19.07.19).
04 de Junio de 2019Reelecciones. Adm. Unico: CAJA RURAL DE GRANADA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRED. Datos registrales. T 1688 , F 217,S 8, H GR 42617, I/A 31 (29.05.19).
25 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: CARMONA FRESNEDA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1688 , F 217, S 8, H GR 42617, I/A 29(17.04.19).
Nombramientos. Apo.Manc.: CARMONA FRESNEDA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1688 , F 217, S 8, H GR 42617, I/A 30(17.04.19).
02 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: RAMIREZ RUIZ JORGE;RODRIGUEZ TAMAYO DAVID. Datos registrales. T 1601 , F 30, S 8, H GR42617, I/A 28 (25.03.19).
13 de Febrero de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: GOMEZ BARBERO SILVIA. Datos registrales. T 1601 , F 30, S 8, H GR 42617, I/A 26 ( 6.02.19).
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA VERA JUAN JOSE. Datos registrales. T 1601 , F 30, S 8, H GR 42617, I/A 27 ( 6.02.19).
17 de Enero de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: SANCHEZ GOMEZ AMADOR. Apo.Man.Soli: SANCHEZ GOMEZ AMADOR. Apo.Sol.: SANCHEZGOMEZ AMADOR. Apo.Manc.: JUSTICIA LINDE FERNANDO. Datos registrales. T 1601 , F 28, S 8, H GR 42617, I/A 21 ( 8.01.19).
Nombramientos. Apo.Manc.: RAMIREZ RUIZ JORGE. Datos registrales. T 1601 , F 28, S 8, H GR 42617, I/A 22 ( 8.01.19).
Nombramientos. Apo.Manc.: GOMEZ BARBERO SILVIA. Datos registrales. T 1601 , F 29, S 8, H GR 42617, I/A 23 ( 8.01.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ BARBERO SILVIA. Datos registrales. T 1601 , F 29, S 8, H GR 42617, I/A 24 ( 8.01.19).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ BARBERO SILVIA. Datos registrales. T 1601 , F 30, S 8, H GR 42617, I/A 25 ( 8.01.19).
22 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: INDRA BPO SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1601 , F 28, S 8, H GR 42617, I/A 20(15.05.18).
13 de Abril de 2018Nombramientos. Apoderado: INDRA BPO SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1601 , F 28, S 8, H GR 42617, I/A 19 (5.04.18).
09 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: CAMACHO RAMOS MARIA VICTORIA;ROBLES MORILLAS LORENA;LAZUEN NAVARRO MARIA DELA CRUZ;VILLANUEVA CA脩ADA PATRICIA;ALONSO CONDE ALFREDO LUIS. Datos registrales. T 1601 , F 27, S 8, H GR 42617,I/A 17 ( 2.02.18).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JIMENEZ GARRIDO ANTONIO;LEGEREN FELIX JUAN RAMON. Datos registrales. T 1601 , F 27, S8, H GR 42617, I/A 18 ( 2.02.18).
25 de Octubre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA VERA JUAN JOSE;SANCHEZ GOMEZ AMADOR;GARCIA TORRES SANDRA;JIMENEZ LOPEZFRANCISCO;MORALES VALDIVIA BERNARDO JOSE;VILLAMON DEL CUBO FERNANDO. Datos registrales. T 1601 , F 27, S 8, HGR 42617, I/A 16 (18.10.17).
05 de Octubre de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: VELASCO SANCHEZ IGNACIO;RODRIGUEZ MARTINEZ ANTONIO-JACINTO. Datos registrales.T 1601 , F 26, S 8, H GR 42617, I/A 14 (29.09.17).
Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ RUTE DIMAS. Nombramientos. Apoderado: LUQUE FRIAS GERONIMO SIMEON.Datos registrales. T 1601 , F 27, S 8, H GR 42617, I/A 15 (29.09.17).
14 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: ORTEGA CONDE JUAN PEDRO;RUIZ CABRERA EDUARDO. Apoderado: MORENO BASTIDA PILAR.Datos registrales. T 1601 , F 26, S 8, H GR 42617, I/A 13 ( 7.09.16).
09 de Agosto de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ CA脩ETE PATRICIA;YAGUEZ JIMENEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1480 , F 44, S8, H GR 42617, I/A 11 ( 3.08.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LEGEREN FELIX JUAN RAMON. Datos registrales. T 1480 , F 44, S 8, H GR 42617, I/A 12 (3.08.16).
24 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA VERA JUAN JOSE. Apo.Manc.: RUIZ OCHOA EMILIO. Datos registrales. T 1480 , F 43, S8, H GR 42617, I/A 10 (17.12.15).
30 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apoderado: MARTOS MU脩OZ ANTONIO. Datos registrales. T 1480 , F 43, S 8, H GR 42617, I/A 9 (23.11.15).
09 de Octubre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: TERRON MORENO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1480 , F 42, S 8, H GR 42617, I/A 8 (2.10.15).
14 de Julio de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUIZ OCHOA EMILIO. Datos registrales. T 1480 , F 42, S 8, H GR 42617, I/A 7 ( 7.07.15).
23 de Octubre de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTOS MU脩OZ ANTONIO. Datos registrales. T 1480 , F 42, S 8, H GR 42617, I/A 6 (17.10.13).
18 de Abril de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ MU脩OZ FRANCISCO;MORALES VALDIVIA BERNARDO JOSE;TALAVERA GARCIAJOSE MARIA;VILLAMON DEL CUBO FERNANDO. Datos registrales. T 1480 , F 41, S 8, H GR 42617, I/A 5 (11.04.13).
01 de Marzo de 2013Otros conceptos: SE RECTIFICA la inscripci贸n 1& de constituci贸n de esta Sociedad, en el sentido de incluir, en los poderesotorgados en la misma, las siguientes facultades que no quedaron suficientemente determinadas: "conferir y revocar apoderamientos".Datos registrales. T 1480 , F 41, S 8, H GR 42617, I/A 3 (21.02.13).
20 de Febrero de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: SCHMOLLING GUINOVART ANGEL LUIS;SERRANO REIFS ANTONIO;FERNANDEZ-NOGUERASJIMENEZ MATILDE CELIA;JIMENEZ GARRIDO ANTONIO;YAGUEZ JIMENEZ JOSE MANUEL;RUIZ OCHOA EMILIO;GARCIA VERAJUAN JOSE;GARCIA TORRES SANDRA;LOPEZ CA脩ETE PATRICIA;JIMENEZ LOPEZ FRANCISCO;SANCHEZ GOMEZAMADOR;GARCIA LOSADA DIEGO;LINARES GARCIA MARIA DOLORES;CUESTA ORTIZ BALTASAR;JIMENEZ CANOVACAMARIA DE LOS ANGELES;GARCIA RUIZ FERMIN MIGUEL. Datos registrales. T 1480 , F 40, S 8, H GR 42617, I/A 2 (13.02.13).
25 de Enero de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 21.12.12. Objeto social: a) La tenencia, explotaci贸n, gesti贸n, administraci贸n, adquisici贸n,enajenaci贸n y arrendamiento, ya sea de forma directa o indirecta, de todo tipo de inmuebles, urbanos o r煤sticos. Quedan excluidas delobjeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales.... Domicilio: AVDA DON BOSCO 2(GRANADA). Capital suscrito: 60.000,00 Euros. Desembolsado: 60.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico:CAJA RURAL DE GRANADA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRED. Nombramientos. Adm. Unico: CAJA RURAL DE GRANADASOCIEDAD COOPERATIVA DE CRED. Apo.Manc.: RODRIGUEZ RUTE DIMAS;SERRANO REIFS ANTONIO;SCHMOLLINGGUINOVART ANGEL LUIS;JUSTICIA LINDE FERNANDO;SANCHEZ GOMEZ AMADOR;JIMENEZ LOPEZ FRANCISCO;ALONSOCONDE ALFREDO. Datos registrales. T 1480 , F 39, S 8, H GR 42617, I/A 1 (18.01.13).