Buscador CIF Logo

Actos BORME Holdirent S I C A V Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Holdirent S I C A V Sa

Actos BORME Holdirent S I C A V Sa - A84660166

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Holdirent S I C A V Sa con CIF A84660166

馃敊 Perfil de Holdirent S I C A V Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Holdirent S I C A V Sa

08 de Noviembre de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PALMER ARROM ANDRES. Consejero: GARCIA LOPEZ ANTONIO JOSE;ARANDA AMILIBIAENRIQUE. Presidente: ARANDA AMILIBIA ENRIQUE. Con.Delegado: ARANDA AMILIBIA ENRIQUE. Consejero: FERNANDEZMIRANDA VIDAL ALFONSO. Ent. Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D. EntidDeposit:BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO.Revocaciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Liquidador: GARAYGORDOBILURIBARRENA MARIA. Liq.Sup.: GALINDO HORMIGOS JAVIER. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 22683 , F113, S 8, H M 405749, I/A 17 (31.10.22).

25 de Octubre de 2022
Otros conceptos: Dada de baja a la sociedad "HOLDIRENT S I C A V SA" en el Registro de Sociedades de Inversi贸n de CapitalVariable, como consecuencia de la decisi贸n de los acuerdos sociales adoptados con fecha 8 de septiembre de 2022. Datosregistrales. T 22683 , F 98, S 8, H M 405749, I/A 1M (18.10.22).

06 de Agosto de 2021
Reelecciones. Consejero: FERNANDEZ MIRANDA VIDAL ALFONSO. Datos registrales. T 22683 , F 112, S 8, H M 405749, I/A 16(30.07.21).

04 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Consejero: ARANDA AMILIBIA ENRIQUE. Presidente: ARANDA AMILIBIA ENRIQUE. Con.Delegado: ARANDAAMILIBIA ENRIQUE. Datos registrales. T 22683 , F 112, S 8, H M 405749, I/A 15 (27.11.20).

09 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Modificaciones estatutarias. 9. Organos de laSociedad. Datos registrales. T 22683 , F 112, S 8, H M 405749, I/A 14 ( 2.10.19).

05 de Marzo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN HIDALGO JUAN CARLOS. Nombramientos. Consejero: GARCIA LOPEZ ANTONIOJOSE. Datos registrales. T 22683 , F 111, S 8, H M 405749, I/A 13 (26.02.19).

09 de Septiembre de 2016
Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datosregistrales. T 22683 , F 111, S 8, H M 405749, I/A 12 (31.08.16).

17 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: LARREA LOPEZ-TAPIA INES. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ-MIRANDA VIDALALFONSO. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22683 , F 111, S 8, H M 405749, I/A 11 ( 7.08.15).

11 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: PALMER ARROM ANDRES. Consejero: LOPEZ SALOMON PETRA;UNANUE LOPEZ JOSEANTONIO;UNANUE LOPEZ JOSE IGNACIO. Presidente: UNANUE LOPEZ JOSE ANTONIO. Con.Delegado: UNANUE LOPEZ JOSEANTONIO. Secretario: UNANUE LOPEZ JOSE IGNACIO. Nombramientos. SecreNoConsj: PALMER ARROM ANDRES. Consejero:ARANDA AMILIBIA ENRIQUE;LARREA LOPEZ-TAPIA INES;MARTIN HIDALGO JUAN CARLOS. Presidente: ARANDA AMILIBIAENRIQUE. Con.Delegado: ARANDA AMILIBIA ENRIQUE. Datos registrales. T 22683 , F 110, S 8, H M 405749, I/A 10 ( 4.07.14).

25 de Febrero de 2014
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: MADRID GIL CLAUDIA. Nombramientos. VsecrNoConsj: PALMER ARROM ANDRES. Datosregistrales. T 22683 , F 110, S 8, H M 405749, I/A 9 (18.02.14).

19 de Agosto de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: UNANUE PICO JOSE ANTONIO. Presidente: UNANUE PICO JOSE ANTONIO. Con.Delegado:UNANUE PICO JOSE ANTONIO. Secretario: LOPEZ SALOMON PETRA. Nombramientos. Consejero: UNANUE LOPEZ JOSEIGNACIO. Presidente: UNANUE LOPEZ JOSE ANTONIO. Con.Delegado: UNANUE LOPEZ JOSE ANTONIO. Secretario: UNANUELOPEZ JOSE IGNACIO. Otros conceptos: SE MODIFICA EL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales.T 22683 , F 109, S 8, H M 405749, I/A 8 ( 8.08.13).

17 de Agosto de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22683 , F 109, S 8, H M 405749, I/A 7 ( 7.08.12).

18 de Mayo de 2011
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SANCHEZ-JARA GARRALDA GONZALO. Nombramientos. VsecrNoConsj: MADRID GILCLAUDIA. Datos registrales. T 22683 , F 108, S 8, H M 405749, I/A 6 ( 6.05.11).

27 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: EZCURRA PEREZ FRANCISCO GABRIEL;EZCURRA ZUFIA MIGUEL FRANCISCO;EZCURRAZUFIA MARIA ANTONIA. Presidente: EZCURRA PEREZ FRANCISCO GABRIEL. Secretario: EZCURRA ZUFIA MIGUELFRANCISCO. Con.Delegado: EZCURRA PEREZ FRANCISCO GABRIEL. Nombramientos. Consejero: UNANUE PICO JOSEANTONIO;LOPEZ SALOMON PETRA;UNANUE LOPEZ JOSE ANTONIO. Presidente: UNANUE PICO JOSE ANTONIO.Con.Delegado: UNANUE PICO JOSE ANTONIO. Secretario: LOPEZ SALOMON PETRA. Datos registrales. T 22683 , F 108, S 8, HM 405749, I/A 5 (17.05.10).

18 de Septiembre de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22683 , F 108, S 8, H M 405749, I/A 4 ( 2.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n