Buscador CIF Logo

Actos BORME Holguinfran Sicav Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Holguinfran Sicav Sa

Actos BORME Holguinfran Sicav Sa - A82780636

Tenemos registrados 7 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Holguinfran Sicav Sa con CIF A82780636

馃敊 Perfil de Holguinfran Sicav Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Holguinfran Sicav Sa

09 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Secretario: MARTINEZ-ORTIZ REY ALVARO. Ent. Gestora: A&G FONDOS SGIIC SA. Consejero: UNCETA DELA CRUZ JUAN;VILLAMOR ZAMBRANO JOSE MANUEL;SOLDEVILLA DIEGO RAFAEL. Presidente: SOLDEVILLA DIEGO RAFAEL.EntidDeposit: SANTANDER INVESTMENT SA. Nombramientos. Liquidador: MARTINEZ-ORTIZ REY ALVARO. Disoluci贸n.Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 15947 , F 10, S 8, H M 269635, I/A 19 (26.04.17).

13 de Noviembre de 2015
Cambio de domicilio social. C/ JOAQUIN COSTA 26 (MADRID). Datos registrales. T 15947 , F 10, S 8, H M 269635, I/A 17 (5.11.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SANZ SANZ TOMAS. Presidente: SANZ SANZ TOMAS. Nombramientos. Consejero: SOLDEVILLADIEGO RAFAEL. Presidente: SOLDEVILLA DIEGO RAFAEL. Consejero: SOLDEVILLA DIEGO RAFAEL. Presidente: SOLDEVILLADIEGO RAFAEL. Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Otros conceptos: RATIFICADO ELNOMBRAMIENTO DEL CONSEJERO Y PRESIDENTE D. RAFAEL SOLDEVILLA DIEGO, NOMBRADO POR COOPTACION ENREUNION DEL CONSEJO DE 27 DE MARZO DE 2015, POR EL FALLECIMIENTO DEL ANTERIOR PRESIDENTE D. TOMAS SANZSANZ. Datos registrales. T 15947 , F 10, S 8, H M 269635, I/A 18 ( 5.11.15).

26 de Febrero de 2013
Modificaciones estatutarias. 13. R茅gimen sobre convocatoria, constituci贸n, asistencia, representaci贸n y celebraci贸n de la Junta..P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.ayg.es. Datos registrales. T 15947 , F 9, S 8, H M269635, I/A 16 (18.02.13).

01 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: GARRIDO LAFITEZ JUAN CARLOS;CENDRA ARMIJO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 15947 ,F 9, S 8, H M 269635, I/A 15 (23.08.11).

03 de Agosto de 2011
Reelecciones. Secretario: MARTINEZ-ORTIZ REY ALVARO. Consejero: UNCETA DE LA CRUZ JUAN;VILLAMOR ZAMBRANOJOSE MANUEL. Presidente: SANZ SANZ TOMAS. Datos registrales. T 15947 , F 8, S 8, H M 269635, I/A 14 (20.07.11).

26 de Julio de 2010
Ceses/Dimisiones. Auditor: ESFERA 4 AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 15947 , F 8, S 8, H M 269635, I/A 13 (14.07.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n