Actos BORME de Homero Costa Sl
25 de Marzo de 2019Revocaciones. ADM.UNICO: PATRICK RENE GEORGES MEUNIER. Datos registrales. T 26398 , F 122, S 8, H B 102264, I/A 19(18.03.19).
09 de Octubre de 2018Revocaciones. APODERAD.SOL: MUT TERRES CAMALO CALIXTO. Datos registrales. T 26398 , F 122, S 8, H B 102264, I/A 18 (1.10.18).
16 de Octubre de 2017Revocaciones. APODERAD.SOL: DE VAL LOPEZ LUIS. ADM.UNICO: DE VAL LOPEZ LUIS. Nombramientos. ADM.UNICO:PATRICK RENE GEORGES MEUNIER. Datos registrales. T 26398 , F 122, S 8, H B 102264, I/A 16 ( 5.10.17).
Nombramientos. APODERAD.SOL: MUT TERRES CAMALO CALIXTO. Datos registrales. T 26398 , F 122, S 8, H B 102264, I/A 17( 5.10.17).
11 de Septiembre de 2013Revocaciones. ADMINISTR.: MINGUEZ RICART MARIA TERESA. Nombramientos. ADM.UNICO: DE VAL LOPEZ LUIS. Datosregistrales. T 26398 , F 121, S 8, H B 102264, I/A 15 ( 3.09.13).
26 de Agosto de 2013Nombramientos. APODERAD.SOL: DE VAL LOPEZ LUIS. Datos registrales. T 26398 , F 121, S 8, H B 102264, I/A 14 (16.08.13).
25 de Febrero de 2010Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: DE VAL MINGUEZ AITANA. Datos registrales. T 26398 , F 121, S 8, H B 102264, I/A 13(12.02.10).