Buscador CIF Logo

Actos BORME Hommax Sistemas Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Hommax Sistemas Sa

Actos BORME Hommax Sistemas Sa - A46145066

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Hommax Sistemas Sa con CIF A46145066

馃敊 Perfil de Hommax Sistemas Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Hommax Sistemas Sa

26 de Enero de 2023
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: FX 2010 HOLDING SOCIEDAD LIMITADA. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 60.110,00 Euros. Resultante Suscrito: 540.990,00 Euros. Datos registrales. T 10275, L 7556, F 223, S 8, H V 26733, I/A36 (19.01.23).

24 de Noviembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: TORNER PEREZ OCTAVIO JOSE. Vicepresid.: TORNER PEREZ OCTAVIO JOSE. Otrosconceptos: Fija en CINCO, el n煤mero de miembros del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 10275, L 7556, F 223, S 8,H V 26733, I/A 35 (17.11.22).

05 de Julio de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERRERA NAVARRO FERNANDO. Datos registrales. T 10275, L 7556, F 222, S 8, H V 26733, I/A34 (28.06.22).

07 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: CEGESA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 10275, L 7556, F 222, S 8, H V 26733,I/A 33 (29.11.21).

16 de Junio de 2021
Revocaciones. Apoderado: TORNER PEREZ JOSE;TORNER PEREZ OCTAVIO JOSE. Datos registrales. T 10275, L 7556, F 222,S 8, H V 26733, I/A 32 ( 9.06.21).

23 de Junio de 2020
Modificaciones estatutarias. MODIFICADA LA REDACCION DEL ARTICULO 15潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y PORCONSIGUIENTE MODIFICADO EL SISTEMA DE RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.. Datos registrales. T10275, L 7556, F 222, S 8, H V 26733, I/A 31 (16.06.20).

12 de Junio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: MAESTRE AZCON JOSE FERNANDO;SEBASTIAN JUAN FRANCISCO;MAESTRE AZCONALBERTO;MAESTRE AZCON SERGIO;RODRIGUEZ LUIS SERGIO;MAESTRE AZCON ANTONIO;TORNER PEREZ OCTAVIOJOSE. Vicepresid.: SEBASTIAN JUAN FRANCISCO. Secretario: RODRIGUEZ LUIS SERGIO. Vicesecret.: MAESTRE AZCONSERGIO. Cons.Del.Sol: MAESTRE AZCON SERGIO;MAESTRE AZCON ANTONIO. Presidente: MAESTRE AZCON JOSE

18 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: TRONCHONI FERRER DIEGO. Datos registrales. T 10275, L 7556, F 220, S 8, H V 26733, I/A 29(11.02.20).

30 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Auditor: CEGESA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 10275, L 7556, F 220, S 8, H V26733, I/A 28 (23.11.18).

24 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apoderado: BOLUDA RODRIGUEZ RAFAEL. Apo.Sol.: BOLUDA RODRIGUEZ RAFAEL;ABAD MELGAR JOSEJAVIER. Datos registrales. T 10275, L 7556, F 220, S 8, H V 26733, I/A 27 (17.05.18).

29 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO. Presidente: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO.Nombramientos. Presidente: MAESTRE AZCON JOSE FERNANDO. Pres.Honorif: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO.Modificaciones estatutarias. A帽adir el Art铆culo 15-BIS a los estatutos sociales. Otros conceptos: Reducci贸n del n煤mero demiembros del Consejo de Administraci贸n a SIETE. Datos registrales. T 4531, L 1842, F 164, S 8, H V 26733, I/A 26 (22.06.17).

02 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Auditor: ACR BGV AUDITORES SL. Datos registrales. T 4531, L 1842, F 164, S 8, H V 26733, I/A 25 (25.11.15).

21 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO;MAESTRE AZCON JOSE FERNANDO;ABAD MELGARJOSE JAVIER;SEBASTIAN JUAN FRANCISCO;MAESTRE AZCON ALBERTO;MAESTRE AZCON SERGIO;MAESTRE AZCONANTONIO;TORNER PEREZ OCTAVIO JOSE. Presidente: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO. Vicepresid.: MAESTRE AZCONJOSE FERNANDO. Secretario: ABAD MELGAR JOSE JAVIER. Cons.Del.Sol: MAESTRE AZCON ANTONIO;SEBASTIAN JUANFRANCISCO. Nombramientos. Consejero: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO;MAESTRE AZCON JOSEFERNANDO;SEBASTIAN JUAN FRANCISCO;MAESTRE AZCON ALBERTO;MAESTRE AZCON SERGIO;RODRIGUEZ LUISSERGIO;MAESTRE AZCON ANTONIO;TORNER PEREZ OCTAVIO JOSE. Presidente: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO.Vicepresid.: SEBASTIAN JUAN FRANCISCO. Secretario: RODRIGUEZ LUIS SERGIO. Vicesecret.: MAESTRE AZCON SERGIO.Cons.Del.Sol: MAESTRE AZCON SERGIO;MAESTRE AZCON ANTONIO. Modificaciones estatutarias. se modifica art. 15Estatutos, en cuanto al sistema de retribucion del organo de administracion. . Datos registrales. T 4531, L 1842, F 164, S 8, H V26733, I/A 24 (14.07.15).

03 de Marzo de 2014
Modificaci贸n de poderes. Apoderado: TORNER PEREZ OCTAVIO JOSE. Datos registrales. T 4531, L 1842, F 164, S 8, H V26733, I/A 23 (24.02.14).

09 de Agosto de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO;MAESTRE AZCON JOSE FERNANDO;ABAD MELGARJOSE JAVIER;SEBASTIAN JUAN FRANCISCO;MAESTRE AZCON ALBERTO;MAESTRE AZCON SERGIO;MAESTRE AZCONANTONIO;TORNER PEREZ OCTAVIO JOSE. Presidente: MAESTRE MARTINEZ JOSE FERNANDO. Vicepresid.: MAESTRE AZCON

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n