Actos BORME de Hormigones Asfalticos Andaluces Sa
01 de Septiembre de 2023Nombramientos. Auditor: AUDITORES ANDALUCES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1611 , F 218, S 8, H GR 1951, I/A86 (24.08.23).
07 de Enero de 2022Nombramientos. Apoderado: QUESADA CALLEJON MANUEL. Datos registrales. T 1611 , F 212, S 8, H GR 1951, I/A 82(30.12.21).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA SANCHEZ RAMON JESUS. Datos registrales. T 1611 , F 213, S 8, H GR 1951, I/A 83(30.12.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ QUESADA JULIO. Apo.Man.Soli: PEREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL;GOMEZ PE脩A EMILIA.Apo.Sol.: QUESADA CALLEJON MANUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ PE脩A EMILIA MARIA;MARTIN JERONIMOMARIA MILAGROS. Apo.Sol.: ROBLES GONZALEZ DIEGO JESUS. Datos registrales. T 1611 , F 214, S 8, H GR 1951, I/A 84(30.12.21).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ QUESADA JULIO. Datos registrales. T 1611 , F 215, S 8, H GR 1951, I/A 85 (30.12.21).
23 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Presidente: MANRIQUE CARRASCO DANIEL FRANCISCO. Consejero: COBO VILLALTA JUAN JULIAN.Nombramientos. Presidente: MARTINEZ QUESADA JULIO. Cons.Del.Sol: MANRIQUE CARRASCO DANIELFRANCISCO;MARTINEZ QUESADA JULIO. Consejero: COBO NOGUER JAVIER. Reelecciones. Consejero: MANRIQUECARRASCO DANIEL FRANCISCO;MARTINEZ QUESADA JULIO;GUERRERO COBO JOSE MARIA. Secretario: GUERRERO COBOJOSE MARIA. Datos registrales. T 1611 , F 212, S 8, H GR 1951, I/A 81 (16.02.21).
19 de Octubre de 2020Reelecciones. Auditor: AUDITORES ANDALUCES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1611 , F 212, S 8, H GR 1951, I/A80 ( 9.10.20).
03 de Noviembre de 2017Reelecciones. Auditor: AUDITORES ANDALUCES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1611 , F 212, S 8, H GR 1951, I/A79 (26.10.17).
24 de Mayo de 2017Revocaciones. Apoderado: GILABERT MARIN JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: GILABERT MARIN JOSE;CORREDOR ARDOYJOAQUIN;JIMENEZ MU脩OZ FRANCISCO JAVIER;RIVAS MARTINEZ FERNANDO. Datos registrales. T 1611 , F 211, S 8, H GR1951, I/A 78 (17.05.17).
24 de Febrero de 2017Reelecciones. Consejero: MANRIQUE CARRASCO DANIEL FRANCISCO;MARTINEZ QUESADA JULIO;COBO VILLALTA JUANJULIAN;GUERRERO COBO JOSE MARIA. Presidente: MANRIQUE CARRASCO DANIEL FRANCISCO. Secretario: GUERREROCOBO JOSE MARIA. Datos registrales. T 1431 , F 225, S 8, H GR 1951, I/A 77 (20.02.17).
13 de Febrero de 2017Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: TRYS 2001 SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1431 , F 146, S 8, H GR1951, I/A 76 ( 6.02.17).
14 de Mayo de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ QUESADA JULIO;MARTINEZ QUESADA JULIO. Apo.Sol.: MARTINEZ QUESADA JULIO.Apo.Manc.: MARTINEZ QUESADA JULIO. Apo.Sol.: PEREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL. Apo.Manc.: PEREZ RODRIGUEZ JOSEMANUEL. Apo.Sol.: RUIZ ESPINOSA FRANCISCO. Apo.Manc.: RUIZ ESPINOSA FRANCISCO. Apo.Sol.: MARTIN DE SANTOSJOSE LUIS;MARIN CAMARA MARIA ELENA. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ RIOS FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.:MARTINEZ QUESADA JULIO. Apo.Man.Soli: PEREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL;GOMEZ PE脩A EMILIA. Apo.Sol.: QUESADACALLEJON MANUEL. Datos registrales. T 1431 , F 145, S 8, H GR 1951, I/A 74 ( 8.05.14).
03 de Febrero de 2014Revocaciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Nombramientos. Auditor: AUDITORES ANDALUCES SOCIEDAD LIMITADA.Datos registrales. T 1431 , F 145, S 8, H GR 1951, I/A 73 (27.01.14).
25 de Junio de 2013Otros conceptos: Se CREA una SUCURSAL en MARRUECOS. Domicilio: NUMERO 37 RUEMOHAMED ELQORRI RESIDCHAIMAA BUR 2-3 (KENITRA). Denominaci贸n: HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES SA SUCURSAL ENMARRUECOS.Representante: DON MANUEL QUESADA CALLEJON. Datos registrales. T 1431 , F 144, S 8, H GR 1951, I/A 72(18.06.13).
26 de Febrero de 2013Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DNA AUDITORES SOCIEDAD CIVIL. Nombramientos. Auditor: GRANTTHORNTON SLP. Datos registrales. T 1431 , F 144, S 8, H GR 1951, I/A 71 (19.02.13).
08 de Octubre de 2012Fe de erratas: Se rectifica el acto Revocaci贸n de poderes del envio 155 del a帽o 2011, en cuanto al error padecido al incluir en dichapublicaci贸n la revocaci贸n del poder de DON DANIEL FRANCISCO MANRIQUE CARRASCO, que no se revoc贸. Datos registrales. T1039 , F 119, S 8, H GR 1951, I/A 67 ( 4.08.11).
10 de Abril de 2012Ceses/Dimisiones. Presidente: GORDON SANCHIZ ALVARO. Consejero: JIMENEZ FERNANDEZ CESAR;MANRIQUE CARRASCODANIEL;MARTINEZ QUESADA JULIO. Secretario: JIMENEZ FERNANDEZ CESAR. Consejero: CONSTRUCCIONES CIECCISL;GORDON SANCHIZ ALVARO. Revocaciones. Apo.Manc.: GORDON SANCHIZ ALVARO. Apo.Sol.: GORDON SANCHIZALVARO. Nombramientos. Consejero: MANRIQUE CARRASCO DANIEL FRANCISCO;MARTINEZ QUESADA JULIO;COBOVILLALTA JUAN JULIAN;GUERRERO COBO JOSE MARIA. Presidente: MANRIQUE CARRASCO DANIEL FRANCISCO. Secretario:GUERRERO COBO JOSE MARIA. Datos registrales. T 1431 , F 144, S 8, H GR 1951, I/A 70 (28.03.12).
23 de Noviembre de 2011Modificaciones estatutarias. Se modifica el ARTICULO 10, transmisi贸n acciones por actos intervivos a favor de los extra帽os..Semodifica el ARTICULO 11, derecho preferencia en transmisi贸n de participaciones..Se modifica el ARTICULO 20, relativo a lasmayor铆as cualificadas para la aprobaci贸n de los acuerdos.. Datos registrales. T 1431 , F 143, S 8, H GR 1951, I/A 69 (14.11.11).
02 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: COLINA ROBLEDO CARLOS;COLINA ROBLEDO CARLOS. Apo.Sol.: COLINA ROBLEDO CARLOS.Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ RIOS FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 1039 , F 120, S 8, H GR 1951, I/A 68(21.10.11).
16 de Agosto de 2011Revocaciones. Apoderado: GUARDIOLA ALCARAZ JOSE MANUEL. Apo.Man.Soli: PEREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL. Apo.Sol.:COLINA ROBLEDO CARLOS. Apoderado: RAMOS PAJARES LEONCIO. Apo.Man.Soli: RUIZ ESPINOSA FRANCISCO. Apo.Sol.:ORTIZ LOPEZ ENRIQUE;ORTIZ APARICIO JESUS;COLINA ROBLEDO CARLOS. Apo.Manc.: COLINA ROBLEDO CARLOS;PEREZRODRIGUEZ JOSE MANUEL;COLINA ROBLEDO CARLOS;COLINA ROBLEDO CARLOS;RUIZ ESPINOSA FRANCISCO. Apo.Sol.:RUBIO PEIRO FRANCISCO. Apoderado: RUIZ ESPINOSA FRANCISCO;COLINA ROBLEDO CARLOS;COLINA ROBLEDOCARLOS;COLINA ROBLEDO CARLOS;COLINA ROBLEDO CARLOS;MANRIQUE CARRASCO DANIEL FRANCISCO;COLINAROBLEDO CARLOS;MARTINEZ MILLAN FRANCISCO. Nombramientos. Apo.Sol.: GORDON SANCHIZ ALVARO;COLINAROBLEDO CARLOS. Apo.Manc.: COLINA ROBLEDO CARLOS. Apo.Sol.: MARTINEZ QUESADA JULIO;RUIZ ESPINOSAFRANCISCO. Apo.Manc.: MARTINEZ QUESADA JULIO;PEREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL;MARTINEZ QUESADA JULIO.Apo.Sol.: MARTIN DE SANTOS JOSE LUIS. Apo.Manc.: MANRIQUE CARRASCO DANIEL;MANRIQUE CARRASCODANIEL;MANRIQUE CARRASCO DANIEL;GORDON SANCHIZ ALVARO;MARTINEZ QUESADA JULIO. Apo.Sol.: PEREZRODRIGUEZ JOSE MANUEL. Apo.Manc.: RUIZ ESPINOSA FRANCISCO;COLINA ROBLEDO CARLOS. Datos registrales. T 1039 ,F 119, S 8, H GR 1951, I/A 67 ( 4.08.11).
12 de Agosto de 2011Fe de erratas: Se rectifica el acto Nombramiento de 贸rgano adm. del envio 70 del a帽o 2011, en cuanto al error padecido al no publicarcon el cargo de PRESIDENTE delConsejo a DON ALVARO GORDON SANCHIZ. Datos registrales. T 1039 , F 118, S 8, H GR 1951,I/A 66 ( 8.04.11).
18 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ MARCOS ESPERABE DE ARTEAGA PILAR;COLINA ROBLEDO CARLOS;GORDONSANCHIZ ALVARO. Presidente: GORDON SANCHIZ ALVARO. Consejero: HERGOSAMAR SOCIEDAD LIMITADA. Secretario:HERGOSAMAR SOCIEDAD LIMITADA. Revocaciones. Apo.Sol.: GORDON SANCHIZ ALVARO;SANCHEZ MARCOS ESPERABEDE ARTEAGA PILAR;SANCHEZ MARCOS ESPERABE ARTEAGA BEATRIZ. Nombramientos. Apoderado: MANRIQUECARRASCO DANIEL FRANCISCO. Consejero: GORDON SANCHIS ALVARO;JIMENEZ FERNANDEZ CESAR;MANRIQUECARRASCO DANIEL;MARTINEZ QUESADA JULIO. Secretario: JIMENEZ FERNANDEZ CESAR. Consejero: CONSTRUCCIONESCIECCI SL;GORDON SANCHIZ ALVARO. Datos registrales. T 1039 , F 118, S 8, H GR 1951, I/A 66 ( 8.04.11).
28 de Febrero de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.029.300,00 Euros. Desembolsado: 2.029.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.979.300,00 Euros.Resultante Desembolsado: 3.979.300,00 Euros. Datos registrales. T 1039 , F 118, S 8, H GR 1951, I/A 65 (18.02.11).
30 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: HERMANOS L.A. HIRIART ASOCIADOS SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1039 , F 117,S 8, H GR 1951, I/A 64 (22.11.10).
30 de Agosto de 2010Reelecciones. Auditor: DNA AUDITORES SC. Datos registrales. T 1039 , F 117, S 8, H GR 1951, I/A 63 (20.08.10).
26 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: DNA AUDITORES SC. Datos registrales. T 1039 , F 117, S 8, H GR 1951, I/A 62 (17.11.09).
05 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ MARCOS ESPERABE ARTEAGA BEATRIZ. Secretario: SANCHEZ MARCOS ESPERABEARTEAGA BEATRIZ. Consejero: LOPEZ-ARANGUREN MARCOS JUAN IGNACIO. Nombramientos. Consejero: HERGOSAMARSOCIEDAD LIMITADA;HERMANOS L.A. HIRIART ASOCIADOS SOCIEDAD LIMITADA. Secretario: HERGOSAMAR SOCIEDADLIMITADA. Reelecciones. Consejero: GORDON SANCHIZ ALVARO. Presidente: GORDON SANCHIZ ALVARO. Datos registrales.T 1039 , F 116, S 8, H GR 1951, I/A 60 (24.09.09).
Modificaciones estatutarias. Art. 31. Se modifica el sistema de remuneraci贸n de los consejeros que consistir谩 en una cantidad fijadeterminada para cada ejercicio por la Junta General. Datos registrales. T 1039 , F 117, S 8, H GR 1951, I/A 61 (24.09.09).
19 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: MOZO DEL RIO ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: COLINA ROBLEDO CARLOS. Datosregistrales. T 1039 , F 116, S 8, H GR 1951, I/A 59 ( 7.05.09).
14 de Mayo de 2009Revocaciones. Apoderado: MOZO DEL RIO ENRIQUE. Datos registrales. T 1039 , F 116, S 8, H GR 1951, I/A 58 ( 6.05.09).
17 de Abril de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: COLINA ROBLEDO CARLOS. Modificaci贸n de poderes. Apo.Man.Soli: PEREZ RODRIGUEZ JOSEMANUEL;RUIZ ESPINOSA FRANCISCO. Datos registrales. T 1039 , F 115, S 8, H GR 1951, I/A 56 ( 6.04.09).
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ MARCOS SANCHEZ JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: GORDON SANCHIZALVARO;SANCHEZ MARCOS ESPERABE ARTEAGA BEATRIZ;SANCHEZ MARCOS ESPERABE DE ARTEAGA PILAR. Datosregistrales. T 1039 , F 115, S 8, H GR 1951, I/A 57 ( 6.04.09).