Buscador CIF Logo

Actos BORME Hormigones Caleta Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Hormigones Caleta Sa

Actos BORME Hormigones Caleta Sa - A03066933

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Alicante para Hormigones Caleta Sa con CIF A03066933

馃敊 Perfil de Hormigones Caleta Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Alicante

Actos BORME de Hormigones Caleta Sa

27 de Agosto de 2021
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3565 , F 73, S 8, H A 20131, I/A 32 (20.08.21).

24 de Agosto de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: GAVILLAC SL;GAVILA FERRER ANA MARIA;GAYA BUIGUES JOSE VICENTE;PERETO CARDONAVICENTE. Presidente: PERETO CARDONA VICENTE. Consejero: ESTRUCH OLASO MIGUEL. Secretario: ESTRUCH OLASOMIGUEL. Nombramientos. Consejero: PERETO MAS VICENTE JOSE;MAS PONS SALVADOR JOSE;GAVILA FERRER ANAMARIA;LLACER GAVILA FRANCISCO;ESTRUCH OLASO MIGUEL. Presidente: LLACER GAVILA FRANCISCO. Secretario:ESTRUCH OLASO MIGUEL. Datos registrales. T 3565 , F 73, S 8, H A 20131, I/A 31 (16.08.21).

16 de Marzo de 2020
Fe de erratas: La fecha de nombramiento del sujeto nombrado por la inscripci贸n 29陋, es la de 09/04/2019 y no la que por error constapublicada 08/04/2019. Datos registrales. T 3565 , F 71, S 8, H A 20131, I/A 29 (16.04.19).

13 de Junio de 2019
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3565 , F 72, S 8, H A 20131, I/A 30 ( 5.06.19).

26 de Abril de 2019
Revocaciones. Apoderado: LLACER GAVILA FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: LLACER GAVILA FRANCISCO. Datosregistrales. T 3565 , F 71, S 8, H A 20131, I/A 29 (16.04.19).

15 de Julio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: PERETO CARDONA VICENTE;LLACER GAVILA FRANCISCO;GAYA BUIGUES JOSEVICENTE;ESTRUCH OLASO MIGUEL. Presidente: PERETO CARDONA VICENTE. Secretario: ESTRUCH OLASO MIGUEL.Consejero: GAVILA FERRER ANA MARIA. Nombramientos. Consejero: GAVILLAC SL;GAVILA FERRER ANA MARIA;GAYABUIGUES JOSE VICENTE;PERETO CARDONA VICENTE. Presidente: PERETO CARDONA VICENTE. Consejero: ESTRUCHOLASO MIGUEL. Secretario: ESTRUCH OLASO MIGUEL. Datos registrales. T 3565 , F 70, S 8, H A 20131, I/A 27 ( 7.07.16).

Revocaciones. Apoderado: DENIA ARBIOL ESTEBAN. Nombramientos. Apoderado: LLACER GAVILA FRANCISCO. Datosregistrales. T 3565 , F 70, S 8, H A 20131, I/A 28 ( 8.07.16).

13 de Julio de 2016
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3565 , F 70, S 8, H A 20131, I/A 26 ( 5.07.16).

12 de Agosto de 2014
Nombramientos. Consejero: GAVILA FERRER ANA MARIA. Datos registrales. T 3565 , F 70, S 8, H A 20131, I/A 25 ( 1.08.14).

29 de Noviembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: PLA GAVILA ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: GAVILA FERRER ANA MARIA. Datosregistrales. T 3565 , F 70, S 8, H A 20131, I/A 24 (21.11.13).

03 de Junio de 2013
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3565 , F 70, S 8, H A 20131, I/A 23 (24.05.13).

30 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GAYA BUIGUES JOSE VICENTE. Datos registrales. T 3565 , F 69, S 8, H A 20131, I/A 22(20.11.12).

20 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Secretario: ESTRUCH OLASO MIGUEL. Datos registrales. T 2481 , F 177, S 8, H A 20131, I/A 20 (16.11.11).

03 de Septiembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: DENIA ARBIOL ESTEBAN. Datos registrales. T 3565 , F 69, S 8, H A 20131, I/A 21 (22.08.12).

28 de Noviembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: RACO PASTOR SL;GARCIA GUIBERT JUAN MANUEL. Presidente: GARCIA GUIBERT JUANMANUEL. Consejero: GAVILA FERRER ANA MARIA;SCHOCHER ZALASIWIETZ BERND HERBERT;OLASCOAGA ZUBIAGA MARIAGRACIA;ANEMONE 3 SL;MCS GESTORA SL. Secretario: RACO PASTOR SL. Con.Delegado: ANEMONE 3 SL. Consejero:GAVILLAC SL. Nombramientos. Consejero: PERETO CARDONA VICENTE;LLACER GAVILA FRANCISCO;PLA GAVILAENRIQUE;GAYA BUIGUES JOSE VICENTE;ESTRUCH OLASO MIGUEL. Presidente: PERETO CARDONA VICENTE. Con.Delegado:GAYA BUIGUES JOSE VICENTE. Datos registrales. T 2481 , F 177, S 8, H A 20131, I/A 20 (16.11.11).

26 de Noviembre de 2010
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 45.201,00 Euros. Desembolsado: 45.201,00 Euros. Resultante Suscrito: 655.201,00 Euros.Resultante Desembolsado: 655.201,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: HORMIGONES MONDUBER SA.HORMIGONES LA CALA SA. HORMIGONES XUQUER SA. Datos registrales. T 2481 , F 176, S 8, H A 20131, I/A 19 (16.11.10).

13 de Julio de 2010
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2481 , F 176, S 8, H A 20131, I/A 18 ( 1.07.10).

08 de Junio de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: LLACER BLANQUER FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: GAVILLAC SL. Datosregistrales. T 2481 , F 176, S 8, H A 20131, I/A 17 (27.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n