Actos BORME de Hormigones Rosalejo Sl
31 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: YUBERO LOPEZ FELIX JESUS. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 129, S 8, H MA 16543, I/A 36(23.08.22).
30 de Noviembre de 2020Modificaci贸n de poderes. Apoderado: HOYO VILLACA脩AS JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 129, S 8, H MA16543, I/A 35 (18.11.20).
26 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: AURORA GONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 128, S 8, H MA 16543,I/A 34 (14.10.20).
02 de Junio de 2020Revocaciones. Apoderado: ORTIZ RIVADO ELIAS. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 128, S 8, H MA 16543, I/A 33 (25.05.20).
17 de Agosto de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: BELLIDO SOTO MARIA AUXILIADORA;ACEDO MIRANDA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 4561,L 3470, F 128, S 8, H MA 16543, I/A 32 ( 2.08.17).
03 de Abril de 2017Revocaciones. Apoderado: VARONA FIDALGO DIEGO. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 128, S 8, H MA 16543, I/A 31(21.03.17).
25 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANCHEZ MANZANO LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: SANDO MATERIALES YSUMINISTROS SL. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 127, S 8, H MA 16543, I/A 30 (15.11.13).
21 de Marzo de 2013Nombramientos. Apoderado: YUBERO LOPEZ FELIX JESUS. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 127, S 8, H MA 16543, I/A 29(11.03.13).
12 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apoderado: BOZA GONZALEZ MANUEL C. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 127, S 8, H MA 16543, I/A 28(29.11.12).
02 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apoderado: GALAN GARCIA-ROJO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 127, S 8, H MA 16543,I/A 27 ( 9.10.12).
19 de Junio de 2012Revocaciones. Apoderado: VILLODRES PADILLA JOSE;VILLODRES PADILLA JOSE. Apo.Manc.: VILLODRES PADILLA JOSE.Apoderado: VILLODRES PADILLA JOSE. Apo.Manc.: VILLODRES PADILLA JOSE. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 126, S 8, HMA 16543, I/A 26 ( 5.06.12).
03 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: VARONA FIDALGO DIEGO. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 126, S 8, H MA 16543, I/A 25(13.04.12).
30 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ PRADOS FEDERICO. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 126, S 8, H MA 16543, I/A 24(15.11.11).
25 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apoderado: PILO GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 126, S 8, H MA 16543, I/A 23(12.11.10).
02 de Marzo de 2009Nombramientos. Apoderado: VIGARA URBANO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 126, S 8, H MA 16543, I/A21 (17.02.09).
Nombramientos. Apoderado: ORTIZ RIVADO ELIAS. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 126, S 8, H MA 16543, I/A 22 (17.02.09).
19 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: PILO GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 125, S 8, H MA 16543, I/A 18 (6.02.09).
Nombramientos. Apoderado: GALAN GARCIA-ROJO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 126, S 8, H MA 16543,I/A 19 ( 6.02.09).
Nombramientos. Apoderado: ALCARIAS VIZCAINO RAUL. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 126, S 8, H MA 16543, I/A 20 (6.02.09).
10 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ PRADOS FEDERICO. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 125, S 8, H MA 16543, I/A 16(26.01.09).
Nombramientos. Apoderado: HOYO VILLACA脩AS JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 4561, L 3470, F 125, S 8, H MA 16543,I/A 17 (26.01.09).