Actos BORME de Hornija Eolica Sl
03 de Enero de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: FREESTONE JILL THERESA;CAMERON ANNA GRAHAM;GARI MUNSURI FRANCISCO DEBORJA;GROBBELAAR BETTINA GEB EICH;STABLES PAUL MICHAEL;SARKER AJOY;IP KAM LING;SOPA PEDRO LEALALEXANDRA CRISTINA;URQUHART IAN JAMES;POOJA MIHIR JOGLEKAR;GAVIN MARSHALL PETER;GOMES SANTOS PENARODRIGO MANUEL;OLEA ARIAS JAVIER;GUIMARAES VAZ PINTO MARTIM ANDRESEN;FORMOSA ANDREAS;DE ALMEIDABERNARDO ANA CRISTINA;CURRIE ALAN THOMAS;DE ECA DIAS RITA MARIA;ANTUNES DA SILVA TIAGO ANDRE.Nombramientos. Apoderado: FREESTONE JILL THERESA;CAMERON ANNA GRAHAM;ELLIS JOANNA;GROBBELAAR BETTINAGEB EICH;STABLES PAUL MICHAEL;SARKER AJOY;IP KAM LING;SOPA PEDRO LEAL ALEXANDRA CRISTINA;URQUHART IANJAMES;ANTUNES DA SILVA TIAGO ANDRE;GOMES SANTOS PENA RODRIGO MANUEL;GOMEZ BUENO MARIA AZAHAR;SONGSERGIO JEYON;BARLOCCO CAMILLA;FORMOSA ANDREAS;DE ALMEIDA BERNARDO ANA CRISTINA;GAVIN MARSHALLPETER;LETRAS PALMA HUGO MIGUEL;BRAGE TUÑON ISABEL;MARTINS BRUNO PAIXAO;MOREIRA FERRAZ DE GOUVEIRAJORGE NUNO FILIPE;PEDRA SIMON JOSEPH;HEATH STEVEN JOHN;OLEA ARIAS JAVIER;CURRIE ALAN. Datos registrales. T41008 , F 58, S 8, H M 549106, I/A 49 (27.12.22).
23 de Noviembre de 2022Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 41008 , F 58, S 8, H M 549106,I/A 48 (16.11.22).
05 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: FREESTONE JILL THERESA;CAMERON ANNA GRAHAM;GARI MUNSURI FRANCISCO DEBORJA;GROBBELAAR BETTINA GEB EICH;STABLES PAUL MICHAEL;SARKER AJOY;IP KAM LING;SOPA PEDRO LEALALEXANDRA CRISTINA;URQUHART IAN JAMES;POOJA MIHIR JOGLEKAR;GAVIN MARSHALL PETER;GOMES SANTOS PENARODRIGO MANUEL;OLEA ARIAS JAVIER;GUIMARAES VAZ PINTO MARTIM ANDRESEN;FORMOSA ANDREAS;DE ALMEIDABERNARDO ANA CRISTINA;CURRIE ALAN THOMAS;DE ECA DIAS RITA MARIA;ANTUNES DA SILVA TIAGO ANDRE. Datosregistrales. T 41008 , F 56, S 8, H M 549106, I/A 47 (28.06.22).
19 de Mayo de 2022Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 41008 ,F 56, S 8, H M 549106, I/A 46 (11.05.22).
03 de Mayo de 2022Revocaciones. Apoderado: PEINADOR GARCIA RAMON. Apo.Sol.: SANZ CASAS ALBERTO. Apoderado: GONZALEZ-VALLINASPATO RAFAEL;VEGA GUTIERREZ DAVID;ESCOBAR BURON MOISES;ESCOBAR BURON MOISES. Apo.Sol.: VEGA GUTIERREZDAVID;ESCOBAR BURON MOISES;ALVAREZ CORRAL RAFAEL;GONZALEZ VALLINAS PATO MANUEL. Apo.Manc.: ESCOBARBURON MOISES. Apo.Sol.: GONZALEZ VALLINAS PATO MANUEL;GONZALEZ-VALLINAS PATO RAFAEL. Datos registrales. T41008 , F 54, S 8, H M 549106, I/A 42 (25.04.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA GUIJARRO MARIA PILAR;RUFFIN VICENTE JAVIER;GAVILA CASTELLO BORJA;CLAVIJOAGREDA MAR. Datos registrales. T 41008 , F 55, S 8, H M 549106, I/A 43 (25.04.22).
Nombramientos. Adm. Solid.: JONES MARK RICHARD;ANDRES MONTE PABLO;DA SILVA RUI JORGE MAIA. Modificacionesestatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración:Administradores mancomunados a Administradores solidarios. Dimisiones de los administradores mancomunados, D. RafaelGonzález-Vallinas Pato, D. Manuel González-Vallinas Pato, D. Ramón Peinador García y D. David Vega Gutiérrez,. Cambio dedomicilio social. C/ MARIA DE MOLINA 4 6ª (MADRID). Datos registrales. T 41008 , F 55, S 8, H M 549106, I/A 44 (25.04.22).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: BETA PARTICIPACIONES IBERICA SL. Datos registrales. T41008 , F 56, S 8, H M 549106, I/A 45 (25.04.22).
30 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 41008 , F 54, S 8, H M 549106, I/A 41 (23.12.21).
01 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: VEGA GUTIERREZ DAVID;GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL;GONZALEZ-VALLINAS PATORAFAELPresidente: GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL. Cons.Del.Man: GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL;GONZALEZ-VALLINAS PATO RAFAEL;VEGA GUTIERREZ DAVIDConsejero: GONZALEZ VALLINAS PATO MANUEL;PEINADOR GARCIARAMON. Secretario: VEGA GUTIERREZ DAVID. Vicesecret.: PEINADOR GARCIA RAMON. Nombramientos. Adm. Unico:GONZALEZ-VALLINAS PATO RAFAEL;GONZALEZ VALLINAS PATO MANUEL;VEGA GUTIERREZ DAVID;PEINADOR GARCIARAMON. Modificaciones estatutarias. Refundición de estatutos. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración:Consejo de administración a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 41008 , F 52, S 8, H M 549106, I/A 39 (25.01.21).
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL. Apo.Manc.: PEINADOR GARCIA RAMON;GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL. Apoderado: GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL. Datos registrales. T 41008 , F 54, S 8, H M 549106,I/A 40 (25.01.21).
18 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 41008 , F 51, S 8, H M 549106, I/A 38 (11.01.21).
16 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ VALLINAS PATO MANUEL;GONZALEZ-VALLINAS PATO RAFAEL. Datos registrales. T41008 , F 51, S 8, H M 549106, I/A 37 ( 6.11.20).
11 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ VALLINAS PATO MANUEL;ESCOBAR BURON MOISES;PEINADOR GARCIA RAMON.Datos registrales. T 41008 , F 50, S 8, H M 549106, I/A 35 ( 3.11.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ-VALLINAS PATO RAFAEL. Datos registrales. T 41008 , F 50, S 8, H M 549106, I/A 36 (3.11.20).
10 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ VALLINAS PATO MANUEL. Datos registrales. T 36206 , F 225, S 8, H M 549106, I/A 34(30.10.20).
03 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ-VALLINAS PATO RAFAEL;VEGA GUTIERREZ DAVID. Datos registrales. T 36206 , F 224,S 8, H M 549106, I/A 31 (26.10.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: ESCOBAR BURON MOISES. Datos registrales. T 36206 , F 224, S 8, H M 549106, I/A 32 (26.10.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ CORRAL RAFAEL. Datos registrales. T 36206 , F 225, S 8, H M 549106, I/A 33 (26.10.20).
14 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: BLANCO BOLINAGA SANTOS. Datos registrales. T 36206 , F 224, S 8, H M 549106, I/A 30 ( 7.07.20).
06 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: ESCOBAR BURON MOISES. Datos registrales. T 36206 , F 223, S 8, H M 549106, I/A 29 (28.02.20).
07 de Febrero de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: DIEZ RUIZ IÑIGO. Datos registrales. T 36206 , F 222, S 8, H M 549106, I/A 26 (31.01.20).
Nombramientos. Apoderado: ESCOBAR BURON MOISES. Datos registrales. T 36206 , F 222, S 8, H M 549106, I/A 27 (31.01.20).
Nombramientos. Apoderado: BLANCO BOLINAGA SANTOS. Datos registrales. T 36206 , F 223, S 8, H M 549106, I/A 28(31.01.20).
14 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 36206 , F 222, S 8, H M 549106, I/A 25 ( 7.01.20).
16 de Diciembre de 2019Declaración de unipersonalidad. Socio único: INVERSIONES EMPRESARIALES VAPAT SL. Datos registrales. T 36206 , F 222,S 8, H M 549106, I/A 24 ( 5.12.19).
12 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: POMARES BOTANA ROBERTO. Consejero: MANARA WALTER. Vicepresid.: MANARAWALTER. Consejero: BRAWLEY JED MATTHEW. VsecrNoConsj: PEINADOR GARCIA RAMON. Nombramientos. Consejero:GONZALEZ VALLINAS PATO MANUEL;PEINADOR GARCIA RAMON. Secretario: VEGA GUTIERREZ DAVID. Vicesecret.:PEINADOR GARCIA RAMON. Datos registrales. T 36206 , F 221, S 8, H M 549106, I/A 23 ( 3.12.19).
11 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MATUS LUIS ALEJANDRO. Nombramientos. Consejero: BRAWLEY JED MATTHEW. Datosregistrales. T 36206 , F 221, S 8, H M 549106, I/A 22 ( 2.12.19).
22 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 36206 , F 220, S 8, H M 549106, I/A 21 (15.01.19).
19 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ-VALLINAS DELGADO RAFAEL. Presidente: GONZALEZ-VALLINAS DELGADORAFAEL. Consejero: PEINADOR GARCIA RAMON. Con.Delegado: GONZALEZ-VALLINAS DELGADO RAFAEL. VsecrNoConsj:GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL. Nombramientos. VsecrNoConsj: PEINADOR GARCIA RAMON. Consejero: GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL;GONZALEZ-VALLINAS PATO RAFAEL. Presidente: GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL. Cons.Del.Man:GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL;GONZALEZ-VALLINAS PATO RAFAEL;VEGA GUTIERREZ DAVID Modificacionesestatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 36206 , F 220, S 8, H M549106, I/A 20 (12.03.18).
18 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 36206 , F 219, S 8, H M 549106, I/A 19 (10.01.18).
19 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apoderado: PEINADOR GARCIA RAMON. Datos registrales. T 36206 , F 219, S 8, H M 549106, I/A 18 ( 5.12.17).
11 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL. Datos registrales. T 36206 , F 219, S 8, H M 549106, I/A 17(31.08.17).
01 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ-VALLINAS PATO RAFAEL. Datos registrales. T 30512 , F 28, S 8, H M 549106, I/A 15(23.08.17).
Nombramientos. Apoderado: VEGA GUTIERREZ DAVID. Datos registrales. T 30512 , F 28, S 8, H M 549106, I/A 16 (24.08.17).
26 de Julio de 2017Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 30512 , F 27, S 8, H M 549106, I/A 14 (18.07.17).
31 de Enero de 2017Otros conceptos: Se declara que el auditor nombrado ha sido sustituido por "AUREN AUDITORES SP, SLP" como consecuencia dela escritura de fusión y segregación que causó la inscripción 1ª de la hoja 624.626. Datos registrales. T 30512 , F 27, S 8, H M549106, I/A 11M (16.01.17).
23 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: SETO JANE. Nombramientos. Consejero: MATUS LUIS ALEJANDRO. Datos registrales. T 30512, F 27, S 8, H M 549106, I/A 13 (12.05.16).
21 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: KLAUS HAEUSSERMANN VOLKER. Vicepresid.: KLAUS HAEUSSERMANN VOLKER.Nombramientos. Vicepresid.: MANARA WALTER. Consejero: SETO JANE. Datos registrales. T 30512 , F 27, S 8, H M 549106, I/A12 (13.01.16).
11 de Junio de 2014Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES VLL SL. Datos registrales. T 30512 , F 26, S 8, H M 549106, I/A 11 ( 3.06.14).
04 de Septiembre de 2013Revocaciones. Apoderado: PAZOS DONATO JOSE LUIS. Datos registrales. T 30512 , F 26, S 8, H M 549106, I/A 10 (27.08.13).
17 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: DE SA BRAAMCAMP SOBRAL SOTTOMAYOR BERNARDO. Vicepresid.: DE SA BRAAMCAMPSOBRAL SOTTOMAYOR BERNARDO. Nombramientos. Consejero: MANARA WALTER. Vicepresid.: KLAUS HAEUSSERMANNVOLKER. Datos registrales. T 30512 , F 26, S 8, H M 549106, I/A 9 ( 8.05.13).
15 de Enero de 2013Nombramientos. Apoderado: PEINADOR GARCIA RAMON. Datos registrales. T 30512 , F 23, S 8, H M 549106, I/A 5 ( 4.01.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANZ CASAS ALBERTO;DIEZ RUIZ IÑIGO. Datos registrales. T 30512 , F 24, S 8, H M 549106, I/A 6 (4.01.13).
Nombramientos. Apoderado: PAZOS DONATO JOSE LUIS. Datos registrales. T 30512 , F 25, S 8, H M 549106, I/A 7 ( 4.01.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: PEINADOR GARCIA RAMON;GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL. Datos registrales. T 30512 , F26, S 8, H M 549106, I/A 8 ( 8.01.13).
14 de Enero de 2013Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL. Datos registrales. T 30512 , F 22, S 8, H M 549106, I/A 4 (3.01.13).
09 de Enero de 2013Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL. Apo.Manc.: PEINADOR GARCIA RAMON;GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL. Datos registrales. T 30512 , F 22, S 8, H M 549106, I/A 3 (27.12.12).
11 de Diciembre de 2012Cambio de domicilio social. C/ ARAPILES 13 PISO 13 (MADRID). Datos registrales. T 30512 , F 22, S 8, H M 549106, I/A 2(29.11.12).
22 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: FERNANDEZ TRANCHO JUAN CARLOS. Nombramientos. VsecrNoConsj: GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL. Datos registrales. T 1390 , F 124, S 8, H VA 19318, I/A 12 (12.03.12).
16 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL. Datos registrales. T 1390 , F 124, S 8, H VA 19318, I/A 10 (7.09.11).
Nombramientos. Apo.Manc.: PEINADOR GARCIA RAMON;GONZALEZ-VALLINAS PATO DANIEL. Datos registrales. T 1390 , F124, S 8, H VA 19318, I/A 11 ( 7.09.11).
11 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ TRANCHO JUAN CARLOS. Secretario: FERNANDEZ TRANCHO JUAN CARLOS.Con.Delegado: GONZALEZ-VALLINAS DELGADO RAFAEL. Nombramientos. SecreNoConsj: POMARES BOTANA ROBERTO.VsecrNoConsj: FERNANDEZ TRANCHO JUAN CARLOS. Consejero: VEGA GUTIERREZ DAVID;DE SA BRAAMCAMP SOBRALSOTTOMAYOR BERNARDO;KLAUS HAEUSSERMANN VOLKER. Vicepresid.: DE SA BRAAMCAMP SOBRAL SOTTOMAYORBERNARDO. Con.Delegado: GONZALEZ-VALLINAS DELGADO RAFAEL. Modificaciones estatutarias. Artículo 6º.-TRANSMISION DE PARTICIPACIONES. I.- TRANSMISION VOLUNTARIA POR ACTO "INTER VIVOS". Cada uno de los sociostendráun derecho preferente en el supuesto de que otro socio decida transmitir su participación directa o indirectamente en la sociedad.Dicho derecho preferente operará del Artículo 8º.- Corresponderá a los socios constituidos en Junta General decidir por la mayoríalegal o estatutariamenteestablecida en los asuntos que sean competencia de ésta. Cada participación da derecho a un voto. Losacuerdos que se sometan a la aprobación de la Junta General de Socios se Artículo 10º- La convocatoria por el Organo deAdministración, tanto para las Juntas Generales ordinarias como para las extraordinarias, se realizará por el órgano de administraciónmediante comunicación individual a cada socio remitida por correo certificado con acuse de recibo, dirigida al socio Artículo 12º.- LasJuntas Generales se celebrarán en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio. Actuarán como Presidente y Secretariode la Junta General los que lo sean del Consejo de Administración y, en su defecto, los designados por los socios concurrentes alcomienzo de la Articulo 14º.- La Sociedad estará regida y administrada por un Consejo de Administración compuesto por cincomiembros..--------- Artículo 16º.- El Consejo de Administración se reunirá al menos una vez al año para la formulación de las cuentasanuales de cada Sociedad, y siempre que sea solicitado por cualquiera de sus miembros. Las reuniones del Consejo seránconvocadas por el Presidente mediante comunicación por escrito Artículo 19º.- El Consejo de Administración designará de su seno unConsejero Delegado, en cuyo favor se delegarán todas las facultades del Consejo de Administración, legal y estatutariamentedelegables, salvo aquellas relacionadas con acuerdos para cuya adopción el Consejo de Administración Artículo 26º.- Todos lossocios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sinperjuicio de los derechos y acciones que la ley reconoce.. Datos registrales. T 1261 , F 31, S 8, H VA 19318, I/A 8 ( 2.03.11).
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 1390 , F 124, S 8, H VA 19318, I/A 9 ( 2.03.11).
14 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: GAMESA INVERSIONES ENERGETICAS RENOVABLES SCR DE R. Secretario: GAMESAINVERSIONES ENERGETICAS RENOVABLES SCR DE R. Nombramientos. Secretario: FERNANDEZ TRANCHO JUAN CARLOS.Consejero: PEINADOR GARCIA RAMON. Datos registrales. T 1261 , F 31, S 8, H VA 19318, I/A 6 ( 3.02.11).
Declaración de unipersonalidad. Socio único: INVERSIONES EMPRESARIALES VAPAT SL. Datos registrales. T 1261 , F 31, S8, H VA 19318, I/A 7 ( 3.02.11).
19 de Mayo de 2010Ampliación de capital. Capital: 1.867.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.667.000,00 Euros. Datos registrales. T 1261 , F 29, S 8,H VA 19318, I/A 3 (10.05.10).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: INVERSIONES EMPRESARIALES VAPAT SL. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ-VALLINAS DELGADO RAFAEL. Presidente: GONZALEZ-VALLINAS DELGADO RAFAEL. Consejero: GAMESA INVERSIONESENERGETICAS RENOVABLES SCR DE R. Secretario: GAMESA INVERSIONES ENERGETICAS RENOVABLES SCR DE R.Consejero: FERNANDEZ TRANCHO JUAN CARLOS. Con.Delegado: GONZALEZ-VALLINAS DELGADO RAFAEL. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Datos registrales. T 1261 , F
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 1261 , F 30, S 8, H VA 19318, I/A 5 (10.05.10).