Buscador CIF Logo

Actos BORME Hortofruticola Costa De Almeria Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Hortofruticola Costa De Almeria Sl

Actos BORME Hortofruticola Costa De Almeria Sl - B04257028

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Almeria para Hortofruticola Costa De Almeria Sl con CIF B04257028

馃敊 Perfil de Hortofruticola Costa De Almeria Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Almeria

Actos BORME de Hortofruticola Costa De Almeria Sl

04 de Septiembre de 2023
Nombramientos. Auditor: VILCHEZ CASAS JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1291 , F 11, S 8, H AL 31313, I/A 25 (25.08.23).

19 de Abril de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: CA脩ADAS COBO JOSE LUIS. Datos registrales. T 1291 , F 11, S 8, H AL 31313, I/A 24 ( 5.04.23).

03 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ MARTINEZ JOSE. Vicesecret.: LOPEZ MARTINEZ JOSE. Cons.Del.Man: LOPEZ MARTINEZJOSE. Nombramientos. Consejero: LOPEZ OJEDA MANUEL. Vicesecret.: LOPEZ OJEDA MANUEL. Cons.Del.Man: LOPEZ OJEDAMANUEL. Datos registrales. T 1291 , F 8, S 8, H AL 31313, I/A 15 (22.05.14).

08 de Abril de 2014
Nombramientos. Apoderado: VELAR MARTIN LUIS. Datos registrales. T 1291 , F 8, S 8, H AL 31313, I/A 14 (31.03.14).

04 de Febrero de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: POMARES FRIAS JOSE;ZAPATA POMARES MIGUEL;GARCIA RODRIGUEZ EVA MARIA. Datosregistrales. T 1291 , F 7, S 8, H AL 31313, I/A 13 (25.01.13).

18 de Septiembre de 2012
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1291 , F 7, S 8, H AL 31313, I/A 12 ( 6.09.12).

27 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: VARGAS FERNANDEZ ENRIQUE. Cons.Del.Man: VARGAS FERNANDEZ ENRIQUE.Nombramientos. Consejero: ENRIQUE VARGAS E HIJOS SL. Cons.Del.Man: ENRIQUE VARGAS E HIJOS SL;GALDEANOESCUDERO JUAN FRANCISCO. Reelecciones. Consejero: VARGAS MALDONADO JUAN ENRIQUE;GARCIA GONZALEZLUIS;LOPEZ MARTINEZ JOSE. Vicesecret.: LOPEZ MARTINEZ JOSE. Cons.Del.Man: LOPEZ MARTINEZ JOSE. Presidente:VARGAS MALDONADO JUAN ENRIQUE. Cons.Del.Man: VARGAS MALDONADO JUAN ENRIQUE. Consejero: ZAPATA MIRANDAMIGUEL. Vicepresid.: ZAPATA MIRANDA MIGUEL. Cons.Del.Man: ZAPATA MIRANDA MIGUEL. Secretario: GARCIA GONZALEZLUIS. Cons.Del.Man: GARCIA GONZALEZ LUIS;POMARES LOPEZ JOSE ANTONIO. Consejero: GALDEANO ESCUDERO JUANFRANCISCO;POMARES LOPEZ JOSE ANTONIO. Cons.Del.Man: GALDEANO CORTES LUIS. Consejero: CA脩ADAS GARCIA LUIS.Cons.Del.Man: CA脩ADAS GARCIA LUIS. Consejero: GALDEANO CORTES LUIS. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de losestatutos: 2. Objeto.- La sociedad tiene por objeto social: Conservar, normalizar, transformar y transportar, distribuir y comercializar,tanto en origen como endestino productos hortofrut铆colas. La compra, venta y explotaci贸n en cualesquiera de sus formas de fincasrusticas y. Ampliacion del objeto social. La sociedad tiene por objeto social: Conservar, normalizar, transformar ytransportar,distribuir y comercializar, tanto en origen como en destino productos hortofrut铆colas. La compra, venta y explotaci贸n en cualesquieradesus formas de fincas rusticas y urbanas. La comercializaci贸n al por mayor y. Datos registrales. T 1291 , F 7, S 8, H AL 31313, I/A11 (12.01.12).

20 de Julio de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 15.025,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.258.085,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culode los estatutos: 6. Capital.- El capital sociales de cuatro millones doscientos cincuenta y ocho mil ochenta y cinco euros, dividido ensetecientas ocho mil quinientas participaicones sociales, n煤meros uno al setecientos ocho mil quinientos, ambos inclusives de 6,01euros de valor. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: AGRUPA-ROQUETAS SL. Datos registrales. T 1291 , F 5, S 8, HAL 31313, I/A 10 ( 7.07.11).

14 de Diciembre de 2010
Nombramientos. Auditor: AUDICONSA AUDITORES SL. Datos registrales. T 1291 , F 5, S 8, H AL 31313, I/A 9 (30.11.10).

23 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: ZAPATA POMARES MIGUEL;GALDEANO ROMERO FRANCISCO LUIS;CA脩ADAS COBO JOSELUIS;VARGAS GARBIN ENRIQUE EDUARDO;GARCIA RODRIGUEZ EVA MARIA;POMARES FRIAS JOSE. Datos registrales. T1291 , F 5, S 8, H AL 31313, I/A 8 (10.09.10).

21 de Octubre de 2009
Nombramientos. Presidente: VARGAS MALDONADO JUAN ENRIQUE. Vicepresid.: ZAPATA MIRANDA MIGUEL. Datosregistrales. T 1291 , F 5, S 8, H AL 31313, I/A 7 ( 9.10.09).

02 de Octubre de 2009
Nombramientos. Apoderado: GALDEANO ROMERO FRANCISCO LUIS. Datos registrales. T 1291 , F 4, S 8, H AL 31313, I/A 5(17.09.09).

Nombramientos. Apoderado: VARGAS GARBIN ENRIQUE EDUARDO. Datos registrales. T 1291 , F 4, S 8, H AL 31313, I/A 6(17.09.09).

17 de Junio de 2009
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: VARGAS FERNANDEZ ROGELIO. Cons.Del.Man: VARGAS FERNANDEZ ROGELIO. Consejero:VARGAS FERNANDEZ ROGELIO. Nombramientos. Consejero: VARGAS MALDONADO JUAN ENRIQUE. Vicepresid.: VARGASMALDONADO JUAN ENRIQUE. Cons.Del.Man: VARGAS MALDONADO JUAN ENRIQUE. Datos registrales. T 1291 , F 3, S 8, H AL31313, I/A 4 ( 4.06.09).

08 de Enero de 2009
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MARTINEZ PELEGRIN. Datos registrales. T 1291 , F 3, S 8, H AL 31313, I/A 2 (23.12.08).

Nombramientos. Apoderado: VARGAS MALDONADO JUAN ENRIQUE. Datos registrales. T 1291 , F 3, S 8, H AL 31313, I/A 3(23.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n