Buscador CIF Logo

Actos BORME Hospital Moncloa Grupo Hla Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Hospital Moncloa Grupo Hla Sa

Actos BORME Hospital Moncloa Grupo Hla Sa - A80386451

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Hospital Moncloa Grupo Hla Sa con CIF A80386451

馃敊 Perfil de Hospital Moncloa Grupo Hla Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Hospital Moncloa Grupo Hla Sa

31 de Octubre de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;DELGADO SORIAMARIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;RODRIGUEZ-VILLA MATONSANDRES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;GARCIA CALLE LAURA;RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO;HERNANDEZMORENO-VENTAS RAUL. Datos registrales. T 40642 , F 213, S 8, H M 67922, I/A 66 (24.10.23).

20 de Octubre de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 40642 , F 213, S 8, H M 67922, I/A 64 (13.10.23).

Ceses/Dimisiones. Presidente: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Vicepresid.: ORTIZ QUINTANA LUIS. Nombramientos.Presidente: ORTIZ QUINTANA LUIS. Vicepresid.: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Datos registrales. T 40642 , F 213, S 8, H M67922, I/A 65 (13.10.23).

29 de Agosto de 2023
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INVESTIGACION Y CIRUGIA ORTOPEDICA DR GALINDO SL. Datos registrales.T 40642 , F 209, S 8, H M 67922, I/A 63 (22.08.23).

16 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Nombramientos.Apo.Man.Soli: TORRES FERNANDEZ VALERIANO FRANCISCO. Apo.Manc.: IVORRA MIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZDE URBINA ENRIQUE;RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO;CABALLERO CABALLERO MARIANO;LOPEZ JERICO FRANCISCOJAVIER;VICENTE RULL JOSE RAMON. Datos registrales. T 40642 , F 206, S 8, H M 67922, I/A 62 ( 8.05.23).

15 de Septiembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T40642 , F 206, S 8, H M 67922, I/A 61 ( 8.09.22).

27 de Abril de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Apoderado: SORIA FERNANDEZ DE CORBODAMANUEL. Apo.Man.Soli: SORIA FERNANDEZ DE CORBODA MANUEL;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Datosregistrales. T 40642 , F 206, S 8, H M 67922, I/A 60 (20.04.22).

13 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Datos registrales. T 40642 , F 205, S 8, H M 67922,I/A 59 ( 6.04.22).

18 de Noviembre de 2021
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n total de los estatutos sociales. Cambio de objeto social. La sociedad tendr谩 por objeto:a) La organizaci贸n, direcci贸n, gesti贸n e intermediaci贸n para la prestaci贸n de servicios de asistencia cl铆nica general, tratamientosm茅dico-quir煤rgicos de todo tipo de enfermedades humanas, actividades socio-sanitarias, de residencias geri谩tricas, etc. Datosregistrales. T 40642 , F 201, S 8, H M 67922, I/A 58 (11.11.21).

27 de Abril de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO. Apo.Manc.: DE PORRES ORTIZ DE URBINAENRIQUE;CABALLERO CABALLERO MARIANO;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 28017 , F 105, S 8, HM 67922, I/A 57 (20.04.21).

19 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: RIVERA GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 28017 , F 104, S 8, H M 67922, I/A 56 (12.08.20).

23 de Octubre de 2019
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28017 , F 104, S 8, H M 67922, I/A 55 (16.10.19).

07 de Agosto de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES. Apo.Man.Soli:ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Apo.Manc.: CABALLERO CABALLERO MARIANO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SORIAFERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;CABALLEROCABALLERO MARIANO;DELGADO SORIA MARIO. Datos registrales. T 28017 , F 103, S 8, H M 67922, I/A 54 (31.07.19).

31 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: MAYERO FRANCO LUIS;ORTIZ QUINTANA LUIS. Vicepresid.: ORTIZ QUINTANA LUIS. Consejero:RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES. Secretario: RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES. Consejero: IVORRA MIRALLESFRANCISCO;MEDINA BLANCO GREGORIO;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;GARCIA-LEGAZ RUIZ BENITO;ORCESATRUSTEGUI IGNACIO;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;VICENTE RULL JOSE RAMON;ALCALDE GOMEZ MARIADOLORES. Presidente: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Co.De.Ma.So: VICENTE RULL JOSE RAMON;DE PORRES ORTIZ DEURBINA ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: ORTIZ QUINTANA LUIS;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;IVORRAMIRALLES FRANCISCO;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;MEDINA BLANCO GREGORIO;DE PORRES ORTIZ DEURBINA ENRIQUE;GARCIA-LEGAZ RUIZ BENITO;ORCE SATRUSTEGUI IGNACIO;MAYERO FRANCO LUIS MANUEL;VICENTERULL JOSE RAMON;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Presidente: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Vicepresid.: ORTIZQUINTANA LUIS. Secretario: RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES. Co.De.Ma.So: VICENTE RULL JOSE RAMON;DE PORRESORTIZ DE URBINA ENRIQUE. Datos registrales. T 28017 , F 101, S 8, H M 67922, I/A 53 (24.07.19).

08 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28017 , F 100, S 8, H M 67922, I/A52 (30.10.18).

28 de Diciembre de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28017 , F 100, S 8, H M 67922, I/A51 (19.12.17).

23 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: TIRADO GUALLART JESUS. Datos registrales. T 28017 , F 100, S 8, H M 67922, I/A 50 (15.11.17).

18 de Agosto de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: NAVARRO MERINO LUIS. Datos registrales. T 28017 , F 100, S 8, H M 67922, I/A 49 ( 4.08.17).

28 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUISADO Y DEL TORO JOSE CARLOS. Datos registrales. T 28017 , F 100, S 8, H M 67922, I/A 48(20.02.17).

13 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28017 , F 99, S 8, H M 67922, I/A47 ( 5.01.17).

25 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: RIVERA GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 28017 , F 99, S 8, H M 67922, I/A 46 (17.11.16).

26 de Julio de 2016
Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE. Consejero: FERNANDEZ RAMOS JUAN JOSE.Co.De.Ma.So: FERNANDEZ RAMOS JUAN JOSE. Presidente: VICENTE RULL JOSE RAMON. Revocaciones. Apoderado:FERNANDEZ RAMOS JUAN JOSE. Nombramientos. Presidente: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Co.De.Ma.So: VICENTE RULLJOSE RAMON;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE. Datos registrales. T 28017 , F 97, S 8, H M 67922, I/A 45 (15.07.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n