Actos BORME de Hospital Moncloa Grupo Hla Sa
31 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;DELGADO SORIAMARIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;RODRIGUEZ-VILLA MATONSANDRES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;GARCIA CALLE LAURA;RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO;HERNANDEZMORENO-VENTAS RAUL. Datos registrales. T 40642 , F 213, S 8, H M 67922, I/A 66 (24.10.23).
20 de Octubre de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 40642 , F 213, S 8, H M 67922, I/A 64 (13.10.23).
Ceses/Dimisiones. Presidente: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Vicepresid.: ORTIZ QUINTANA LUIS. Nombramientos.Presidente: ORTIZ QUINTANA LUIS. Vicepresid.: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Datos registrales. T 40642 , F 213, S 8, H M67922, I/A 65 (13.10.23).
29 de Agosto de 2023Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INVESTIGACION Y CIRUGIA ORTOPEDICA DR GALINDO SL. Datos registrales.T 40642 , F 209, S 8, H M 67922, I/A 63 (22.08.23).
16 de Mayo de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Nombramientos.Apo.Man.Soli: TORRES FERNANDEZ VALERIANO FRANCISCO. Apo.Manc.: IVORRA MIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZDE URBINA ENRIQUE;RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO;CABALLERO CABALLERO MARIANO;LOPEZ JERICO FRANCISCOJAVIER;VICENTE RULL JOSE RAMON. Datos registrales. T 40642 , F 206, S 8, H M 67922, I/A 62 ( 8.05.23).
15 de Septiembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T40642 , F 206, S 8, H M 67922, I/A 61 ( 8.09.22).
27 de Abril de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Apoderado: SORIA FERNANDEZ DE CORBODAMANUEL. Apo.Man.Soli: SORIA FERNANDEZ DE CORBODA MANUEL;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Datosregistrales. T 40642 , F 206, S 8, H M 67922, I/A 60 (20.04.22).
13 de Abril de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL. Datos registrales. T 40642 , F 205, S 8, H M 67922,I/A 59 ( 6.04.22).
18 de Noviembre de 2021Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n total de los estatutos sociales. Cambio de objeto social. La sociedad tendr谩 por objeto:a) La organizaci贸n, direcci贸n, gesti贸n e intermediaci贸n para la prestaci贸n de servicios de asistencia cl铆nica general, tratamientosm茅dico-quir煤rgicos de todo tipo de enfermedades humanas, actividades socio-sanitarias, de residencias geri谩tricas, etc. Datosregistrales. T 40642 , F 201, S 8, H M 67922, I/A 58 (11.11.21).
27 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO. Apo.Manc.: DE PORRES ORTIZ DE URBINAENRIQUE;CABALLERO CABALLERO MARIANO;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 28017 , F 105, S 8, HM 67922, I/A 57 (20.04.21).
19 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: RIVERA GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 28017 , F 104, S 8, H M 67922, I/A 56 (12.08.20).
23 de Octubre de 2019Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28017 , F 104, S 8, H M 67922, I/A 55 (16.10.19).
07 de Agosto de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES. Apo.Man.Soli:ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Apo.Manc.: CABALLERO CABALLERO MARIANO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SORIAFERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;CABALLEROCABALLERO MARIANO;DELGADO SORIA MARIO. Datos registrales. T 28017 , F 103, S 8, H M 67922, I/A 54 (31.07.19).
31 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MAYERO FRANCO LUIS;ORTIZ QUINTANA LUIS. Vicepresid.: ORTIZ QUINTANA LUIS. Consejero:RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES. Secretario: RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES. Consejero: IVORRA MIRALLESFRANCISCO;MEDINA BLANCO GREGORIO;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;GARCIA-LEGAZ RUIZ BENITO;ORCESATRUSTEGUI IGNACIO;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;VICENTE RULL JOSE RAMON;ALCALDE GOMEZ MARIADOLORES. Presidente: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Co.De.Ma.So: VICENTE RULL JOSE RAMON;DE PORRES ORTIZ DEURBINA ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: ORTIZ QUINTANA LUIS;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;IVORRAMIRALLES FRANCISCO;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;MEDINA BLANCO GREGORIO;DE PORRES ORTIZ DEURBINA ENRIQUE;GARCIA-LEGAZ RUIZ BENITO;ORCE SATRUSTEGUI IGNACIO;MAYERO FRANCO LUIS MANUEL;VICENTERULL JOSE RAMON;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Presidente: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Vicepresid.: ORTIZQUINTANA LUIS. Secretario: RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES. Co.De.Ma.So: VICENTE RULL JOSE RAMON;DE PORRESORTIZ DE URBINA ENRIQUE. Datos registrales. T 28017 , F 101, S 8, H M 67922, I/A 53 (24.07.19).
08 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28017 , F 100, S 8, H M 67922, I/A52 (30.10.18).
28 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28017 , F 100, S 8, H M 67922, I/A51 (19.12.17).
23 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: TIRADO GUALLART JESUS. Datos registrales. T 28017 , F 100, S 8, H M 67922, I/A 50 (15.11.17).
18 de Agosto de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: NAVARRO MERINO LUIS. Datos registrales. T 28017 , F 100, S 8, H M 67922, I/A 49 ( 4.08.17).
28 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: GUISADO Y DEL TORO JOSE CARLOS. Datos registrales. T 28017 , F 100, S 8, H M 67922, I/A 48(20.02.17).
13 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28017 , F 99, S 8, H M 67922, I/A47 ( 5.01.17).
25 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: RIVERA GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 28017 , F 99, S 8, H M 67922, I/A 46 (17.11.16).
26 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE. Consejero: FERNANDEZ RAMOS JUAN JOSE.Co.De.Ma.So: FERNANDEZ RAMOS JUAN JOSE. Presidente: VICENTE RULL JOSE RAMON. Revocaciones. Apoderado:FERNANDEZ RAMOS JUAN JOSE. Nombramientos. Presidente: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Co.De.Ma.So: VICENTE RULLJOSE RAMON;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE. Datos registrales. T 28017 , F 97, S 8, H M 67922, I/A 45 (15.07.16).