Actos BORME de Hospital Polusa Sa
26 de Mayo de 2022Reducción de capital. Importe reducción: 39.216,04 Euros. Resultante Suscrito: 2.070.636,95 Euros. Datos registrales. T 541 , F89, S 8, H LU 841, I/A 83 (18.05.22).
Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.hospitalpolusa.es. Datos registrales. T 541 , F 90, S 8, HLU 841, I/A 84 (18.05.22).
28 de Enero de 2022Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 541 , F 89, S 8, H LU 841, I/A 82 (13.01.22).
04 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apoderado: ATANES PEREZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 541 , F 89, S 8, H LU 841, I/A 81(25.10.21).
27 de Septiembre de 2021Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: ICM AUDITORES SL;SANCHEZ LOPEZ MANUEL VICTOR. Aud.Supl.: LEIROCASTRO ALBERTO. Reelecciones. Auditor: TRUE AND FAIR GALICIA SL. Datos registrales. T 541 , F 88, S 8, H LU 841, I/A 80(17.09.21).
08 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ HERNANDEZ PABLO MANUEL;ROMERO MONLEON CRISTINA. Datos registrales. T541 , F 88, S 8, H LU 841, I/A 79 (27.08.21).
12 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GALLART GASPAR PABLO. Nombramientos. Adm. Mancom.: HERNANDEZ FERRER SONIA.Datos registrales. T 541 , F 88, S 8, H LU 841, I/A 78 ( 5.08.21).
28 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: LOPEZ VILA TRINIDAD;ATANES PEREZ FRANCISCO JAVIER;ZAFRILLA MARTINEZDAVID;HASSANI KISHAN NIRMALA. Datos registrales. T 541 , F 86, S 8, H LU 841, I/A 77 (17.06.21).
19 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: ATANES PEREZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 526 , F 143, S 8, H LU 841, I/A 75(11.05.21).
Nombramientos. Apoderado: AUCEJO DIAZ ALFONSO RAMON. Datos registrales. T 526 , F 143, S 8, H LU 841, I/A 76 (11.05.21).
20 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: ATANES PEREZ FRANCISCO JAVIER;HASSANI KISHAN NIRMALA;ZAFRILLA MARTINEZDAVID;LOPEZ VILA TRINIDAD. Datos registrales. T 526 , F 142, S 8, H LU 841, I/A 74 ( 9.04.21).
08 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ALBA FERNANDEZ MANUEL;HIMAFEL SA;PARDO RODRIGUEZ MARIA LOURDES;ADMINSA;LATORRE GONZALEZ LUIS;LATORRE CASAL CRISTINA;SECURE CAPITAL SOLUTIONS 2000 SL. Presidente: SECURECAPITAL SOLUTIONS 2000 SL. Secretario: HERNANDEZ HERNANDEZ PABLO MANUEL. Con.Delegado: SECURE CAPITALSOLUTIONS 2000 SL. Nombramientos. Adm. Mancom.: TARAZONA GINES ELISA;GALLART GASPAR PABLO. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados. Datos registrales.T 526 , F 141, S 8, H LU 841, I/A 72 (26.03.21).
Cambio de domicilio social. C/ DOCTOR IGLESIAS OTERO-SAN LAZARO DEL PUENTE S/N (LUGO). Datos registrales. T 526 ,F 141, S 8, H LU 841, I/A 73 (26.03.21).
09 de Febrero de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: TARAZONA GINES ELISA;GALLART GASPAR PABLO. Datos registrales. T 526 , F 138, S 8, H LU 841,I/A 68 (27.01.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ HERNANDEZ PABLO MANUEL;ROMERO MONLEON CRISTINA. Datos registrales. T526 , F 140, S 8, H LU 841, I/A 69 (27.01.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: TARAZONA GINES ELISA;GALLART GASPAR PABLO;HERNANDEZ HERNANDEZ PABLOMANUEL;SANCHIS PLAUS SALVADOR;ROMERO MONLEON CRISTINA. Datos registrales. T 526 , F 140, S 8, H LU 841, I/A 70(27.01.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHIS PLAUS SALVADOR;MORENO MARCHAN PATRICIA;AZORIN NAVARRO ANA MARIA. Datosregistrales. T 526 , F 141, S 8, H LU 841, I/A 71 (27.01.21).
14 de Enero de 2021Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9º.- LA JUNTA GENERAL. 1. El funcionamiento de la Junta General, tanto ordinaria comoextraordinaria, se regirá en cuanto a plazos, constitución, votaciones y demás requisitos, a las normas y procedimientos que señala elvigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado a. Datos registrales. T 526 , F 138, S 8, H LU 841, I/A 67 (
13 de Enero de 2021Ceses/Dimisiones. Presidente: ALBA FERNANDEZ MANUEL. Vicepresid.: HIMAFEL SA. Secretario: PARDO RODRIGUEZ MARIALOURDES. Cons.Del.Sol: HIMAFEL SA. Consejero: LENCE TORRES SL. Nombramientos. Consejero: SECURE CAPITALSOLUTIONS 2000 SL. Presidente: SECURE CAPITAL SOLUTIONS 2000 SL. Secretario: HERNANDEZ HERNANDEZ PABLOMANUEL. Con.Delegado: SECURE CAPITAL SOLUTIONS 2000 SL. Datos registrales. T 526 , F 137, S 8, H LU 841, I/A 66(31.12.20).
07 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: ATANES PEREZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 468 , F 215, S 8, H LU 841, I/A 64(25.10.19).
Revocaciones. Apoderado: JORGE LOPEZ JUSTO. Ampliacion del objeto social. . Constituye el objeto social el ejercicio, a travésde las personas físicas que reúnan la titulación adecuada en cada caso, de cualquier actividad relacionada con la prestación deservicios de hospitalización y asistencia médico quirúrgica en todas sus especialidades y en su más amplio sentido. A. Cambio dedomicilio social. C/ DOCTOR IGLESIAS OTERO-SAN LAZARO DEL PUENTE S/N (LUGO). Datos registrales. T 526 , F 136, S 8,H LU 841, I/A 65 (25.10.19).
29 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: JORGE LOPEZ JUSTO. Cons.Del.Sol: JORGE LOPEZ JUSTO. Datos registrales. T 468 , F 215, S8, H LU 841, I/A 62 (20.08.19).
22 de Agosto de 2019Reelecciones. Auditor: TRUE AND FAIR GALICIA SL. Datos registrales. T 468 , F 215, S 8, H LU 841, I/A 61 ( 8.08.19).
17 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: ATANES PEREZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 468 , F 214, S 8, H LU 841, I/A 60 (6.06.19).
23 de Agosto de 2018Reelecciones. Auditor: TRUE AND FAIR GALICIA SL. Datos registrales. T 468 , F 214, S 8, H LU 841, I/A 59 (13.08.18).
11 de Agosto de 2017Reelecciones. Auditor: TRUE AND FAIR GALICIA SL. Datos registrales. T 468 , F 213, S 8, H LU 841, I/A 58 ( 2.08.17).