Actos BORME de Hospital Quiron Campo De Gibraltar Sl
20 de Febrero de 2020Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 28741 , F 97, S 8, H M 505213, I/A 17 (13.02.20).
17 de Julio de 2019Cambio de domicilio social. C/ ZURBARAN 28 (MADRID). Datos registrales. T 28741 , F 97, S 8, H M 505213, I/A 16 (10.07.19).
18 de Diciembre de 2018Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: FAL-CONDEBOURRELLIER JAVIER;CIRIA SUAREZ HECTOR;SERRANO MOYA MARIA DEL PILAR;GONZALEZ ACEBES JUANCARLOS;CORTES CANALES TEO. Secretario: FAL-CONDE BOURRELLIER JAVIER. Presidente: GONZALEZ ACEBES JUANCARLOS. Vicesecret.: HERNANDEZ LERIA CRISTINA. Nombramientos. Adm. Unico: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL.Modificaciones estatutarias. REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- . Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Cambio de objeto social. El desarrollo de las siguientesactividades, directa o indirectamente, mediante la participaci贸n en cualquiera otras sociedades o empresas de objeto id茅ntico oan谩logo: (i) La presentaci贸n de toda clase de servicios sanitarios, tanto de consulta como de diagn贸stico y tratamiento, as铆 como laprestac. Datos registrales. T 2229 , F 130, S 8, H CA 51120, I/A 5 (10.12.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ-DALP JIMENEZ MANUEL. Apoderado: FAL-CONDE BOURRELLIER JAVIER. Datosregistrales. T 2293 , F 146, S 8, H CA 51120, I/A 6 (10.12.18).
Nombramientos. Apoderado: ROMERO BERMEJO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 2293 , F 146, S 8, H CA 51120, I/A 7(10.12.18).
30 de Mayo de 2018Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2229 , F 130, S 8,H CA 51120, I/A 4 (23.05.18).
03 de Agosto de 2017Revocaciones. Apoderado: GAMEZ SANCHEZ DANIEL;ROMERO JIMENEZ OSCAR. Apo.Manc.: SANCHEZ-DALP JIMENEZMANUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SALGADO HERRERA JOSE;LOPEZ DE LA OSA ISMAEL;SERRANO MOYA MARIA DELPILAR;SANCHEZ LIMON ALEXIA. Datos registrales. T 2229 , F 127, S 8, H CA 51120, I/A 3 (27.07.17).
10 de Marzo de 2017Cambio de domicilio social. ZONA ED ARTTYSUR AV. DE LOS EMPRESARIOS N潞 19 PARQ (BARRIOS (LOS)). Datosregistrales. T 2229 , F 127, S 8, H CA 51120, I/A 2 ( 2.03.17).
23 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28741 , F 88, S 8, H M 505213, I/A 13 (13.01.17).
Revocaciones. Apoderado: BERRA DE UNAMUNO RAMON;DE SOLA EARLE CARLOS MIGUEL;GALA RUIZ AFRICA;USONJAEGER PATRICIA ELISABETH. Apo.Sol.: GONZALEZ SEXMA PABLO. Apo.Manc.: GONZALEZ SEXMA PABLO. Datosregistrales. T 28741 , F 88, S 8, H M 505213, I/A 14 (13.01.17).
20 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: FAL-CONDE BOURRELLIER JAVIER;COBREROS MARTINEZ FRANCISCO MIGUEL. Secretario:FAL-CONDE BOURRELLIER JAVIER. Consejero: CORDON MURO MARIA ESTHER;RUBIO LAPORTA JOSE RAMON;SERRANOMOYA MARIA DEL PILAR. Presidente: CORDON MURO MARIA ESTHER. Nombramientos. Consejero: CIRIA SUAREZHECTOR;GONZALEZ ACEBES JUAN CARLOS. Presidente: GONZALEZ ACEBES JUAN CARLOS. Consejero: SERRANO MOYAMARIA DEL PILAR;FAL-CONDE BOURRELLIER JAVIER. Secretario: FAL-CONDE BOURRELLIER JAVIER. Consejero: CORTESCANALES TEO. Datos registrales. T 28741 , F 87, S 8, H M 505213, I/A 11 (13.01.17).
Nombramientos. Vicesecret.: HERNANDEZ LERIA CRISTINA. Datos registrales. T 28741 , F 88, S 8, H M 505213, I/A 12(13.01.17).
19 de Diciembre de 2016Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28741 , F 87, S 8, H M 505213, I/A 10 ( 9.12.16).