Actos BORME de Hospital Rey Don Jaime Sociedad Limitada
24 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 11133, L 8411, F 89, S 8, H V72496, I/A 41 (17.11.23).
07 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: CABRERIZO EXTREMERA ABEL. Datos registrales. T 11133, L 8411, F 89, S 8, H V 72496, I/A 39(28.02.23).
17 de Febrero de 2023Nombramientos. Apoderado: LOPEZ MARTINEZ ANA MARIA. Datos registrales. T 11133, L 8411, F 88, S 8, H V 72496, I/A 38(10.02.23).
10 de Febrero de 2023Nombramientos. Apoderado: ONCINS FANNING MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 11133, L 8411, F 87, S 8, H V 72496, I/A37 ( 3.02.23).
08 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ ABASOLO MARIA LUISA. Datos registrales. T 11133, L 8411, F 87, S 8, H V 72496, I/A 35(31.10.22).
07 de Octubre de 2022Nombramientos. Apoderado: ACASO LLAMAS SILVIA. Datos registrales. T 11133, L 8411, F 86, S 8, H V 72496, I/A 34 (30.09.22).
08 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: MARZAL COQUILLAT AMPARO. Nombramientos. Apoderado: MARZAL COQUILLAT AMPARO.Datos registrales. T 6657, L 3961, F 149, S 8, H V 72496, I/A 33 ( 1.03.22).
14 de Enero de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 149, S 8, H V72496, I/A 32 ( 7.01.22).
02 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ BERNABE JESUS. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 149, S 8, H V 72496, I/A 31(25.10.21).
08 de Octubre de 2021Nombramientos. Apoderado: GARCIA OLTRA FRANCISCO JULIAN. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 148, S 8, H V 72496, I/A30 ( 1.10.21).
20 de Agosto de 2021Revocaciones. Apoderado: GIL SORRIBES PEDRO. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 148, S 8, H V 72496, I/A 29 (13.08.21).
24 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CABRERIZO EXTREMERA ABEL;MARQUEZ SIEVERS OSCAR. Datos registrales. T 6657, L 3961, F147, S 8, H V 72496, I/A 28 (17.06.21).
03 de Febrero de 2021Revocaciones. Apoderado: MONTENEGRO GRAU JOAQUIN RAFAEL. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 147, S 8, H V 72496,I/A 27 (27.01.21).
13 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 146, S 8, H V72496, I/A 26 ( 5.11.20).
06 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: VERDU LLORCA VICTORIA. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 144, S 8, H V 72496, I/A 25(29.09.20).
06 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: VERDU LLORCA VICTORIA. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 143, S 8, H V 72496, I/A 24(30.07.20).
12 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: MATA GARCIA DEL VALLE ICIAR. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 143, S 8, H V 72496, I/A 23 (5.02.20).
20 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: CALERO MANZANERO RAQUEL. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 142, S 8, H V 72496, I/A 22(13.12.19).
01 de Octubre de 2019Fe de erratas: Del acto de Cambio de representante se toma raz贸n mediante la Nota Marginal 4 de la inscripci贸n 1陋 y as铆 se haceconstar para su publicaci贸n en el Bolet铆n 183 de fecha 24/09/19 y referencia 04005582019. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 97, S
24 de Septiembre de 2019Otros conceptos: DON JOSE LUIS PARDO IZQUIERDO NIF 73077036X ha sido sustituido por DON PEDRO CANDIDO RICO
10 de Mayo de 2019Nombramientos. Apoderado: VITHAS SANIDAD SL. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 105, S 8, H V 72496, I/A 21 ( 3.05.19).
25 de Abril de 2019Revocaciones. Apoderado: NOZAL AYUSO JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 104, S 8, H V 72496, I/A 19(16.04.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ ABASOLO MARIA LUISA. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 104, S 8, H V 72496, I/A 20(16.04.19).
30 de Enero de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ BERNABE JESUS. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 103, S 8, H V 72496, I/A 18(23.01.19).
15 de Enero de 2018Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.Datos registrales. T 6657, L 3961, F 103, S 8, H V 72496, I/A 17 ( 8.01.18).
28 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: NOZAL AYUSO JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 102, S 8, H V 72496, I/A 16(21.09.17).
16 de Marzo de 2017Otros conceptos: Se cesa a DON MANUEL GINER QUILIS y se nombra a DON JOSE LUIS PARDO IZQUIERDO, DNI 73.077.036-X, como persona f铆sica representante de la sociedad NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A. en el cargo deAdministrador de la sociedad HOSPITAL REY DON JAIME SL. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 96, S 8, H V 72496, I/A 1 M (9.03.17).
02 de Agosto de 2016Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 102, S 8, H V 72496, I/A 15 (26.07.16).
30 de Marzo de 2015Nombramientos. Apoderado: MARZAL COQUILLAT AMPARO. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 101, S 8, H V 72496, I/A 14(23.03.15).
18 de Diciembre de 2013Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 101, S 8, H V 72496, I/A 13 (11.12.13).
07 de Octubre de 2013Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: GESNISA CASTELLON SL. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 101, S 8, H V72496, I/A 12 (30.09.13).
08 de Septiembre de 2009Nombramientos. Apoderado: MONTENEGRO GRAU JOAQUIN RAFAEL. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 100, S 8, H V72496, I/A 10 (28.08.09).
Revocaciones. Apoderado: BAYO MAICAS SIXTO;GOMEZ-ZURDO SANCHO ALEJANDRO. Datos registrales. T 6657, L 3961, F101, S 8, H V 72496, I/A 11 (28.08.09).
30 de Junio de 2009Nombramientos. Apoderado: GIL SORRIBES PEDRO. Datos registrales. T 6657, L 3961, F 100, S 8, H V 72496, I/A 9 (19.06.09).