Actos BORME de Hospital Virgen De La Paloma Sa
15 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apoderado: ARNOTT FERNANDEZ-ZUBIZARRETA MANUEL;AMILIBIA PICAZO JUAN JOSE;NARVAEZ JAREÑOIGNACIO;CUEVAS ALAÑA LUZ. Nombramientos. Apoderado: ARNOTT FERNANDEZ-ZUBIZARRETA MANUEL;NARVAEZJAREÑO IGNACIO;CUEVAS ALAÑA LUZ;ALBIOL GUTIERREZ IGOR DAVID. Datos registrales. T 43613 , F 51, S 8, H M 105953,I/A 50 ( 9.12.23).
24 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: ARNOTT FERNANDEZ-ZUBIZARRETA MANUEL;AMILIBIA PICAZO JUAN JOSE;NARVAEZ JAREÑOIGNACIO;CUEVAS ALAÑA LUZ. Datos registrales. T 43613 , F 50, S 8, H M 105953, I/A 49 (17.06.22).
06 de Junio de 2022Declaración de unipersonalidad. Socio único: HOSPITAL VIAMED SANTA ELENA SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico:BALLESTEROS AGUADO VALENTIN. Nombramientos. Adm. Unico: VIAMED SALUD SL. Representan: CASTRO DE ARAUJOGONCALVES PAULO ALEXANDRE. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Cambio de domicilio social. AVDADE LA VEGA 15 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 43613 , F 50, S 8, H M 105953, I/A 48 (30.05.22).
13 de Diciembre de 2021Reelecciones. Adm. Unico: BALLESTEROS AGUADO VALENTIN. Datos registrales. T 6506 , F 117, S 8, H M 105953, I/A 47 (2.12.21).
29 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ ALCALDE ROSA MARIA;CALVO GONZALEZ JOSE MARIA;CRAVEN BARTLE COLLDANIEL ANTHONY. Datos registrales. T 6506 , F 117, S 8, H M 105953, I/A 46 (22.09.21).
24 de Febrero de 2020Reelecciones. Auditor: CABEDO GREGORI RODRIGO. Aud.Supl.: MARIMON CONSULTORS I AUDITORS SLP. Cambio dedomicilio social. C/ DEL CONDE DE LA CIMERA 4 (MADRID). Datos registrales. T 6506 , F 117, S 8, H M 105953, I/A 45(17.02.20).
07 de Marzo de 2017Nombramientos. Auditor: CABEDO GREGORI RODRIGO. Aud.Supl.: MARIMON CONSULTORS I AUDITORS SLP. Datosregistrales. T 6506 , F 117, S 8, H M 105953, I/A 44 (27.02.17).
17 de Enero de 2017Reelecciones. Adm. Unico: BALLESTEROS AGUADO VALENTIN. Datos registrales. T 6506 , F 116, S 8, H M 105953, I/A 43 (9.01.17).
14 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: DOMINGUEZ FERNANDEZ JOSE JUAN;CALVO GONZALEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T6506 , F 116, S 8, H M 105953, I/A 42 ( 5.12.16).
25 de Julio de 2014Nombramientos. Auditor: CABEDO GREGORI RODRIGO. Aud.Supl.: MARIMON CONSULTORS I AUDITORS SLP. Datosregistrales. T 6506 , F 116, S 8, H M 105953, I/A 41 (16.07.14).
22 de Febrero de 2012Reelecciones. Adm. Unico: BALLESTEROS AGUADO VALENTIN. Datos registrales. T 6506 , F 116, S 8, H M 105953, I/A 40(13.02.12).
17 de Enero de 2011Nombramientos. Auditor: MORENO RODRIGUEZ ANTONIO. Aud.Supl.: BARRIOS SANCHEZ JULIAN. Datos registrales. T 6506 ,F 116, S 8, H M 105953, I/A 39 ( 4.01.11).
07 de Junio de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: MATEOS GARCIA ANTONIO;CALVO GONZALEZ JOSE MARIA;CRAVEN BARTLE COLL DANIELANTHONY. Datos registrales. T 6506 , F 115, S 8, H M 105953, I/A 37 (25.05.10).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ ALCALDE ROSA MARIA;CALVO GONZALEZ JOSE MARIA;CRAVEN BARTLE COLLDANIEL ANTHONY. Datos registrales. T 6506 , F 115, S 8, H M 105953, I/A 38 (25.05.10).