Actos BORME de Hotel Puerta De Sahagun Sa
17 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Presidente: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Con.Delegado: CRESPOAGUILOCHE JULIO. Secretario: CRESPO VILLALOBOS MARTA. Nombramientos. Consejero: LOPEZ VEGA ANIBAL-ANTONIO.Presidente: CRESPO VILLALOBOS MARTA. Secretario: CRESPO VILLALOBOS ANA ISABEL. Con.Delegado: CRESPOVILLALOBOS MARTA. Datos registrales. T 962 , F 187, S 8, H LE 13138, I/A 18 (11.12.19).
03 de Enero de 2018Nombramientos. Apoderado: CRESPO VILLALOBOS MARTA. Datos registrales. T 962 , F 149, S 8, H LE 13138, I/A 17 (26.12.17).
25 de Mayo de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: IZQUIERDO FERNANDEZ JESUS;HERRERO VEGA JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli:IZQUIERDO FERNANDEZ JESUS;DE ALAIZ MARTINEZ JULIO CESAR. Datos registrales. T 962 , F 148, S 8, H LE 13138, I/A 16(19.05.17).
22 de Marzo de 2017Nombramientos. Consejero: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Presidente: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Secretario: CRESPOVILLALOBOS MARTA. Consejero: CRESPO VILLALOBOS MARTA;CRESPO VILLALOBOS ANA ISABEL. Con.Delegado: CRESPOAGUILOCHE JULIO. Otros conceptos: Se constata el c贸digo C.N.A.E. de la actividad principal del objeto social, que es el: 5510.Datos registrales. T 962 , F 148, S 8, H LE 13138, I/A 15 (14.03.17).
23 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: IZQUIERDO FERNANDEZ JESUS;HERRERO VEGA JAVIER. Datos registrales. T 962 , F 148, S8, H LE 13138, I/A 14 (15.11.16).
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: CRESPO AGUILOCHE JULIO;CRESPO VILLALOBOS MARTA;CRESPOVILLALOBOS ANA ISABEL. Presidente: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Con.Delegado: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Secretario:CRESPO VILLALOBOS MARTA. Datos registrales. T 962 , F 21, S 8, H LE 13138, I/A 7 A (15.11.16).
19 de Julio de 2016Revocaciones. Auditor: LOMAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 962 , F 23, S 8, H LE 13138, I/A 13 (12.07.16).
15 de Enero de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.246.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:
05 de Diciembre de 2012Nombramientos. Con.Delegado: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Datos registrales. T 962 , F 21, S 8, H LE 13138, I/A 10 (27.11.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CRESPO VILLALOBOS MARTA. Apo.Manc.: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Datos registrales. T962 , F 21, S 8, H LE 13138, I/A 11 (27.11.12).
29 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Presidente: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Con.Delegado: CRESPOAGUILOCHE JULIO. Consejero: PEREDA NAVARRO CARLOS;RAMOS MARTINEZ LUIS. Secretario: RAMOS MARTINEZ LUIS.Nombramientos. Consejero: CRESPO AGUILOCHE JULIO;CRESPO VILLALOBOS MARTA;CRESPO VILLALOBOS ANA ISABEL.
Nombramientos. Presidente: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Secretario: CRESPO VILLALOBOS MARTA. Datos registrales. T 962 ,F 21, S 8, H LE 13138, I/A 8 (20.12.11).
Nombramientos. Auditor: LOMAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 962 , F 21, S 8, H LE 13138, I/A 9 (20.12.11).