Buscador CIF Logo

Actos BORME Hotelera Padron Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Hotelera Padron Sa

Actos BORME Hotelera Padron Sa - A29705019

Tenemos registrados 38 Actos BORME del Registro Mercantil de Malaga para Hotelera Padron Sa con CIF A29705019

馃敊 Perfil de Hotelera Padron Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Malaga

Actos BORME de Hotelera Padron Sa

05 de Octubre de 2023
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CLAVITA SA. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 7, S 8, H MA 20412, I/A 85(26.09.23).

12 de Junio de 2023
Ceses/Dimisiones. Secretario: LOPEZ-IBOR ALI脩O ALFONSO. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 7, S 8, H MA 20412, I/A 84 (1.06.23).

08 de Junio de 2023
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 575/2002. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 5/12/2022. Auto de declaraci贸n decumplimiento de convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE ESTEPONA.Juez: SILVIA FERNANDEZ FERNANDEZ. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 7, S 8, H MA 20412, I/A 83 ( 1.06.23).

Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Acr: GURREA CHALE AURELIO;SANCHEZ MEDINA JOSE RAFAEL;GILLIOZ ANDRE;PRIETOLUNA JUAN. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 7, S 8, H MA 20412, I/A 84 ( 1.06.23).

24 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: BETHKE AXEL. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 7, S 8, H MA 20412, I/A 82 (13.10.22).

03 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: PURSCHE LARS. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 7, S 8, H MA 20412, I/A 81 (26.07.22).

29 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 6, S 8, H MA 20412, I/A 80(21.12.21).

08 de Abril de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: BETHKE AXEL;HIDALGO ROJAS PEDRO JESUS;CALDERIN GARCIA OCTAVIO. Datos registrales.T 5739, L 4646, F 6, S 8, H MA 20412, I/A 79 (25.03.21).

18 de Septiembre de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 14.070.514,05 Euros. Resultante Suscrito: 1.563.390,45 Euros. Datos registrales. T 5739,L 4646, F 6, S 8, H MA 20412, I/A 78 ( 5.09.19).

18 de Julio de 2019
Reelecciones. Adm. Unico: CLAVITA SA. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 6, S 8, H MA 20412, I/A 77 ( 9.07.19).

22 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apo.Manc.: BOOTSMA EMILE;KLEBER WERNER NIKOLAUS;PASTOR HERNANDEZ-PINZON JOSEMANUEL;HIDALGO ROJAS PEDRO JESUS. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 5, S 8, H MA 20412, I/A 76 (15.11.18).

09 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: BETHKE AXEL;KLEBER WERNER NIKOLAUS;PASTOR HERNANDEZ PINZON JOSEMANUEL;HIDALGO ROJAS PEDRO JESUS. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 5, S 8, H MA 20412, I/A 75 (27.09.18).

12 de Junio de 2018
Revocaciones. Apo.Manc.: KLEBER WERNER NIKOLAUS;CAL DIAS LOPES ISIDORO CARLA ALEXANDRA;PASTORHERNANDEZ PINZON JOSE MANUEL;HIDALGO ROJAS PEDRO JESUS. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 184, S 8, H MA20412, I/A 69 ( 4.06.18).

Nombramientos. Apo.Manc.: BOOTSMA EMILE;KLEBER WERNER NIKOLAUS;PASTOR HERNANDEZ-PINZON JOSEMANUEL;HIDALGO ROJAS PEDRO JESUS. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 184, S 8, H MA 20412, I/A 70 ( 4.06.18).

Revocaciones. Apoderado: PRIETO LUNA JUAN. Datos registrales. T 5729, L 4636, F 5, S 8, H MA 20412, I/A 71 ( 4.06.18).

Revocaciones. Apo.Manc.: KATZAMEYER HEINZ. Datos registrales. T 5729, L 4636, F 5, S 8, H MA 20412, I/A 72 ( 4.06.18).

Revocaciones. Apo.Manc.: SCHROTH HOLGER. Datos registrales. T 5729, L 4636, F 5, S 8, H MA 20412, I/A 73 ( 4.06.18).

Revocaciones. Apo.Manc.: PRIETO LUNA JUAN;PRIETO LUNA JUAN. Datos registrales. T 5729, L 4636, F 5, S 8, H MA 20412,I/A 74 ( 4.06.18).

26 de Febrero de 2018
Nombramientos. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 184, S 8, H MA 20412,I/A 67 (13.02.18).

05 de Mayo de 2017
Nombramientos. Pre.Com.Sup.: SORIANO BARRANQUERO JOSE MANUEL. M.Com.Sup.Co: SORIANO BARRANQUERO JOSEMANUEL;GURREA CHALE AURELIO;GILLIOZ ANDRE;SANCHEZ MEDINA JOSE;TRACOM SA. Secr.Com.Sup: GURREA CHALEAURELIO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Comisi贸n de Supervisi贸n y Control.Datos registrales. T 5039, L 3946, F 184, S 8, H MA 20412, I/A 66 (24.04.17).

29 de Diciembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: PRIETO LUNA JUAN. Apo.Manc.: CAL DIAS LOPES ISIDORO CARLA ALEXANDRA;PRIETO LUNAJUAN;CAL DIAS LOPES ISIDORO CARLA ALEXANDRA;PRIETO LUNA JUAN;PASTOR HERNANDEZ PINZON JOSEMANUEL;BETRO SORO VICTOR. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 183, S 8, H MA 20412, I/A 65 (20.12.16).

28 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Miem.Com.Acr: GILLIOZ ANDRE;GURREA CHALE AURELIO;SANCHEZ MEDINA JOSE RAFAEL;PRIETO LUNAJUAN. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 575/2002. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 24/03/2004. Sentencia deaprobaci贸n del convenio. Juzgado: num. 1 DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION N潞 1 DE ESTEPONA. Juez: MARTA GARCIAGARCIA. Resoluciones: APROBACION CONVENIO DE ACREEDORES. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 181, S 8, H MA 20412,I/A 64 (20.09.16).

26 de Julio de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: KLEBER WERNER NIKOLAUS;CAL DIAS LOPES ISIDORO CARLA ALEXANDRA;PASTORHERNANDEZ PINZON JOSE MANUEL;HIDALGO ROJAS PEDRO JESUS. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 181, S 8, H MA20412, I/A 63 (14.07.16).

24 de Febrero de 2016
Reelecciones. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 181, S 8, H MA 20412, I/A62 (15.02.16).

07 de Agosto de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: POLI JEAN MARC AUGUSTIN FRANCOIS;PRIETO LUNA JUAN;PASTOR HERNANDEZ PINZON JOSEMANUEL;BETRO SORO VICTOR. Nombramientos. Apo.Manc.: CAL DIAS LOPES ISIDORO CARLA ALEXANDRA;PRIETO LUNAJUAN;CAL DIAS LOPES ISIDORO CARLA ALEXANDRA;PRIETO LUNA JUAN;PASTOR HERNANDEZ PINZON JOSEMANUEL;BETRO SORO VICTOR. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 181, S 8, H MA 20412, I/A 61 (30.07.15).

19 de Diciembre de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: POLI JEAN MARC AUGUSTIN FRANCOIS;PRIETO LUNA JUAN. Nombramientos. Apo.Manc.: POLIJEAN MARC AUGUSTIN FRANCOIS;PRIETO LUNA JUAN;PASTOR HERNANDEZ PINZON JOSE MANUEL;BETRO SORO VICTOR.Datos registrales. T 5039, L 3946, F 181, S 8, H MA 20412, I/A 60 (10.12.14).

14 de Julio de 2014
Nombramientos. Apoderado: PRIETO LUNA JUAN. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 180, S 8, H MA 20412, I/A 58 ( 1.07.14).

Reelecciones. Adm. Unico: CLAVITA SA. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 180, S 8, H MA 20412, I/A 59 ( 1.07.14).

17 de Febrero de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: HOLLWEG RUDIGER CARL;PRIETO LUNA JUAN;PALOS CSABA;HOLLWEG RUDIGER CARL;PRIETOLUNA JUAN. Nombramientos. Apo.Manc.: POLI JEAN MARC AUGUSTIN FRANCOIS;PRIETO LUNA JUAN. Datos registrales. T5039, L 3946, F 180, S 8, H MA 20412, I/A 57 (10.02.14).

18 de Diciembre de 2012
Reelecciones. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 180, S 8, H MA 20412, I/A56 (10.12.12).

16 de Agosto de 2012
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 7.816.952,24 Euros. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 180, S 8, H MA20412, I/A 55 ( 2.08.12).

02 de Agosto de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: HOLLWEG RUDIGER CARL;PRIETO LUNA JUAN;PALOS CSABA. Datos registrales. T 3965, L2876, F 9, S 8, H MA 20412, I/A 52 (20.07.10).

Nombramientos. Apo.Manc.: HOLLWEG RUDIGER CARL;PRIETO LUNA JUAN;KATZAMEYER HEINZ. Datos registrales. T 3965,L 2876, F 9, S 8, H MA 20412, I/A 53 (20.07.10).

Revocaciones. Apo.Manc.: HOLLWEG RUDIGER CARL;BOURQUIN GOMEZ SOFIA;PRIETO LUNA JUAN;PALOSCSABA;KATZAMEYER HEINZ;HOLLWEG RUDIGER CARL;PRIETO LUNA JUAN. Datos registrales. T 3965, L 2876, F 9, S 8, H MA20412, I/A 54 (20.07.10).

01 de Julio de 2010
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 3.908.476,13 Euros. Datos registrales. T 3965, L 2876, F 9, S 8, H MA20412, I/A 51 (17.06.10).

15 de Diciembre de 2009
Reelecciones. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SA. Datos registrales. T 3965, L 2876, F 9, S 8, H MA 20412, I/A 50 (2.12.09).

07 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CLAVITA SA. Nombramientos. Adm. Unico: CLAVITA SA. Datos registrales. T 3965, L 2876, F8, S 8, H MA 20412, I/A 49 (23.11.09).

16 de Febrero de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: GEVERS SVEN ULRICH;PRIETO LUNA JUAN;PALOS CSABA;KATZAMEYER HEINZ;GEVERS SVENULRICH;PRIETO LUNA JUAN. Nombramientos. Apo.Manc.: HOLLWEG RUDIGER CARL;BOURQUIN GOMEZ SOFIA;PRIETOLUNA JUAN;PALOS CSABA;KATZAMEYER HEINZ;HOLLWEG RUDIGER CARL;PRIETO LUNA JUAN. Datos registrales. T 3965, L2876, F 8, S 8, H MA 20412, I/A 48 ( 4.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n