Actos BORME de Hotelera Padron Sa
05 de Octubre de 2023Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CLAVITA SA. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 7, S 8, H MA 20412, I/A 85(26.09.23).
12 de Junio de 2023Ceses/Dimisiones. Secretario: LOPEZ-IBOR ALI脩O ALFONSO. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 7, S 8, H MA 20412, I/A 84 (1.06.23).
08 de Junio de 2023Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 575/2002. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 5/12/2022. Auto de declaraci贸n decumplimiento de convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE ESTEPONA.Juez: SILVIA FERNANDEZ FERNANDEZ. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 7, S 8, H MA 20412, I/A 83 ( 1.06.23).
Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Acr: GURREA CHALE AURELIO;SANCHEZ MEDINA JOSE RAFAEL;GILLIOZ ANDRE;PRIETOLUNA JUAN. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 7, S 8, H MA 20412, I/A 84 ( 1.06.23).
24 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: BETHKE AXEL. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 7, S 8, H MA 20412, I/A 82 (13.10.22).
03 de Agosto de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: PURSCHE LARS. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 7, S 8, H MA 20412, I/A 81 (26.07.22).
29 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 6, S 8, H MA 20412, I/A 80(21.12.21).
08 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: BETHKE AXEL;HIDALGO ROJAS PEDRO JESUS;CALDERIN GARCIA OCTAVIO. Datos registrales.T 5739, L 4646, F 6, S 8, H MA 20412, I/A 79 (25.03.21).
18 de Septiembre de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 14.070.514,05 Euros. Resultante Suscrito: 1.563.390,45 Euros. Datos registrales. T 5739,L 4646, F 6, S 8, H MA 20412, I/A 78 ( 5.09.19).
18 de Julio de 2019Reelecciones. Adm. Unico: CLAVITA SA. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 6, S 8, H MA 20412, I/A 77 ( 9.07.19).
22 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: BOOTSMA EMILE;KLEBER WERNER NIKOLAUS;PASTOR HERNANDEZ-PINZON JOSEMANUEL;HIDALGO ROJAS PEDRO JESUS. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 5, S 8, H MA 20412, I/A 76 (15.11.18).
09 de Octubre de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: BETHKE AXEL;KLEBER WERNER NIKOLAUS;PASTOR HERNANDEZ PINZON JOSEMANUEL;HIDALGO ROJAS PEDRO JESUS. Datos registrales. T 5739, L 4646, F 5, S 8, H MA 20412, I/A 75 (27.09.18).
12 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: KLEBER WERNER NIKOLAUS;CAL DIAS LOPES ISIDORO CARLA ALEXANDRA;PASTORHERNANDEZ PINZON JOSE MANUEL;HIDALGO ROJAS PEDRO JESUS. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 184, S 8, H MA20412, I/A 69 ( 4.06.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: BOOTSMA EMILE;KLEBER WERNER NIKOLAUS;PASTOR HERNANDEZ-PINZON JOSEMANUEL;HIDALGO ROJAS PEDRO JESUS. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 184, S 8, H MA 20412, I/A 70 ( 4.06.18).
Revocaciones. Apoderado: PRIETO LUNA JUAN. Datos registrales. T 5729, L 4636, F 5, S 8, H MA 20412, I/A 71 ( 4.06.18).
Revocaciones. Apo.Manc.: KATZAMEYER HEINZ. Datos registrales. T 5729, L 4636, F 5, S 8, H MA 20412, I/A 72 ( 4.06.18).
Revocaciones. Apo.Manc.: SCHROTH HOLGER. Datos registrales. T 5729, L 4636, F 5, S 8, H MA 20412, I/A 73 ( 4.06.18).
Revocaciones. Apo.Manc.: PRIETO LUNA JUAN;PRIETO LUNA JUAN. Datos registrales. T 5729, L 4636, F 5, S 8, H MA 20412,I/A 74 ( 4.06.18).
26 de Febrero de 2018Nombramientos. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 184, S 8, H MA 20412,I/A 67 (13.02.18).
05 de Mayo de 2017Nombramientos. Pre.Com.Sup.: SORIANO BARRANQUERO JOSE MANUEL. M.Com.Sup.Co: SORIANO BARRANQUERO JOSEMANUEL;GURREA CHALE AURELIO;GILLIOZ ANDRE;SANCHEZ MEDINA JOSE;TRACOM SA. Secr.Com.Sup: GURREA CHALEAURELIO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Comisi贸n de Supervisi贸n y Control.Datos registrales. T 5039, L 3946, F 184, S 8, H MA 20412, I/A 66 (24.04.17).
29 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apoderado: PRIETO LUNA JUAN. Apo.Manc.: CAL DIAS LOPES ISIDORO CARLA ALEXANDRA;PRIETO LUNAJUAN;CAL DIAS LOPES ISIDORO CARLA ALEXANDRA;PRIETO LUNA JUAN;PASTOR HERNANDEZ PINZON JOSEMANUEL;BETRO SORO VICTOR. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 183, S 8, H MA 20412, I/A 65 (20.12.16).
28 de Septiembre de 2016Nombramientos. Miem.Com.Acr: GILLIOZ ANDRE;GURREA CHALE AURELIO;SANCHEZ MEDINA JOSE RAFAEL;PRIETO LUNAJUAN. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 575/2002. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 24/03/2004. Sentencia deaprobaci贸n del convenio. Juzgado: num. 1 DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION N潞 1 DE ESTEPONA. Juez: MARTA GARCIAGARCIA. Resoluciones: APROBACION CONVENIO DE ACREEDORES. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 181, S 8, H MA 20412,I/A 64 (20.09.16).
26 de Julio de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: KLEBER WERNER NIKOLAUS;CAL DIAS LOPES ISIDORO CARLA ALEXANDRA;PASTORHERNANDEZ PINZON JOSE MANUEL;HIDALGO ROJAS PEDRO JESUS. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 181, S 8, H MA20412, I/A 63 (14.07.16).
24 de Febrero de 2016Reelecciones. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 181, S 8, H MA 20412, I/A62 (15.02.16).
07 de Agosto de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: POLI JEAN MARC AUGUSTIN FRANCOIS;PRIETO LUNA JUAN;PASTOR HERNANDEZ PINZON JOSEMANUEL;BETRO SORO VICTOR. Nombramientos. Apo.Manc.: CAL DIAS LOPES ISIDORO CARLA ALEXANDRA;PRIETO LUNAJUAN;CAL DIAS LOPES ISIDORO CARLA ALEXANDRA;PRIETO LUNA JUAN;PASTOR HERNANDEZ PINZON JOSEMANUEL;BETRO SORO VICTOR. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 181, S 8, H MA 20412, I/A 61 (30.07.15).
19 de Diciembre de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: POLI JEAN MARC AUGUSTIN FRANCOIS;PRIETO LUNA JUAN. Nombramientos. Apo.Manc.: POLIJEAN MARC AUGUSTIN FRANCOIS;PRIETO LUNA JUAN;PASTOR HERNANDEZ PINZON JOSE MANUEL;BETRO SORO VICTOR.Datos registrales. T 5039, L 3946, F 181, S 8, H MA 20412, I/A 60 (10.12.14).
14 de Julio de 2014Nombramientos. Apoderado: PRIETO LUNA JUAN. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 180, S 8, H MA 20412, I/A 58 ( 1.07.14).
Reelecciones. Adm. Unico: CLAVITA SA. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 180, S 8, H MA 20412, I/A 59 ( 1.07.14).
17 de Febrero de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: HOLLWEG RUDIGER CARL;PRIETO LUNA JUAN;PALOS CSABA;HOLLWEG RUDIGER CARL;PRIETOLUNA JUAN. Nombramientos. Apo.Manc.: POLI JEAN MARC AUGUSTIN FRANCOIS;PRIETO LUNA JUAN. Datos registrales. T5039, L 3946, F 180, S 8, H MA 20412, I/A 57 (10.02.14).
18 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 180, S 8, H MA 20412, I/A56 (10.12.12).
16 de Agosto de 2012Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 7.816.952,24 Euros. Datos registrales. T 5039, L 3946, F 180, S 8, H MA20412, I/A 55 ( 2.08.12).
02 de Agosto de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: HOLLWEG RUDIGER CARL;PRIETO LUNA JUAN;PALOS CSABA. Datos registrales. T 3965, L2876, F 9, S 8, H MA 20412, I/A 52 (20.07.10).
Nombramientos. Apo.Manc.: HOLLWEG RUDIGER CARL;PRIETO LUNA JUAN;KATZAMEYER HEINZ. Datos registrales. T 3965,L 2876, F 9, S 8, H MA 20412, I/A 53 (20.07.10).
Revocaciones. Apo.Manc.: HOLLWEG RUDIGER CARL;BOURQUIN GOMEZ SOFIA;PRIETO LUNA JUAN;PALOSCSABA;KATZAMEYER HEINZ;HOLLWEG RUDIGER CARL;PRIETO LUNA JUAN. Datos registrales. T 3965, L 2876, F 9, S 8, H MA20412, I/A 54 (20.07.10).
01 de Julio de 2010Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 3.908.476,13 Euros. Datos registrales. T 3965, L 2876, F 9, S 8, H MA20412, I/A 51 (17.06.10).
15 de Diciembre de 2009Reelecciones. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SA. Datos registrales. T 3965, L 2876, F 9, S 8, H MA 20412, I/A 50 (2.12.09).
07 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CLAVITA SA. Nombramientos. Adm. Unico: CLAVITA SA. Datos registrales. T 3965, L 2876, F8, S 8, H MA 20412, I/A 49 (23.11.09).
16 de Febrero de 2009Revocaciones. Apo.Manc.: GEVERS SVEN ULRICH;PRIETO LUNA JUAN;PALOS CSABA;KATZAMEYER HEINZ;GEVERS SVENULRICH;PRIETO LUNA JUAN. Nombramientos. Apo.Manc.: HOLLWEG RUDIGER CARL;BOURQUIN GOMEZ SOFIA;PRIETOLUNA JUAN;PALOS CSABA;KATZAMEYER HEINZ;HOLLWEG RUDIGER CARL;PRIETO LUNA JUAN. Datos registrales. T 3965, L2876, F 8, S 8, H MA 20412, I/A 48 ( 4.02.09).