Actos BORME de Hotelera Sevillana Sa
31 de Octubre de 2023Reelecciones. Adm. Mancom.: CALVENTE VAZQUEZ MARIA PAZ;YBARRA SAINZ DE LA MAZA MARCIAL. Datos registrales. T4429 , F 68, S 8, H SE 16553, I/A 41 (24.10.23).
16 de Junio de 2022Otros conceptos: Por Sentencia de 20/06/2018, del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla -secci贸n 1陋-, se DECLARA LANULIDAD DEL ACUERDO ADOPTADO EN LA JUNTA GENERAL DE FECHA 31/07/2014 RELATIVO AL DEPOSITO DE CUENTASDEL EJERCICIO 2013, que queda anulado. Datos registrales. T 4429 , F 68, S 8, H SE 16553, I/A 40 ( 7.06.22).
Otros conceptos: CANCELACION DE LA ANOTACION PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE NULIDAD DE ACUERDOS SOCIALESA QUE SE REFIERE LA ANOTACION LETRA B, en virtud de DECRETO de fecha 09/05/2022 dictado en el Proc. Pieza MedidasCautelares 1004.01/2015 en el Tribunal de Instancia Mercantil Sevilla -secci贸n primera- Datos registrales. T 4429 , F 68, S 8, H SE16553, I/A D ( 8.06.22).
16 de Septiembre de 2021Reelecciones. Auditor: CABEZA Y PARRA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 4429 , F 68, S 8, HSE 16553, I/A 39 ( 8.09.21).
17 de Mayo de 2021Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Cambio de objeto social. La sociedad tendr谩 como objetosocial la actividad hotelera, de explotaci贸n de apartamentos tur铆sticos y viviendas de uso tur铆stico, la cual podr谩 desarrollarse tanto enedificios propios como arrendados o mediante la gesti贸n de edificios, inmuebles o establecimientos ajenos. Datos registrales. T 4429, F 67, S 8, H SE 16553, I/A 38 ( 7.05.21).
15 de Octubre de 2019Otros conceptos: CANCELACION DE LA ANOTACION PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE IMPUGNACION DE ACUERDOSSOCIALES A QUE SE REFIERE LA ANOTACION LETRA A.-Juzgado de lo Mercantil n潞 1 de Sevilla. Datos registrales. T 4429 , F67, S 8, H SE 16553, I/A C ( 8.10.19).
15 de Enero de 2019Nombramientos. Auditor: CABEZA Y PARRA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 4429 , F 66, S 8,H SE 16553, I/A 37 ( 4.01.19).
15 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: YBARRA MENDARO JUAN;MONTERO GONZALEZ CRISTINA;CALVENTE VAZQUEZMARIA;CALVENTE VAZQUEZ ALONSO;YBARRA SAINZ DE LA MAZA MARCIAL. Presidente: YBARRA MENDARO JUAN.Vicepresid.: CALVENTE VAZQUEZ MARIA. Cons.Del.Man: CALVENTE VAZQUEZ MARIA;YBARRA SAINZ DE LA MAZA MARCIAL.Nombramientos. Adm. Mancom.: CALVENTE VAZQUEZ MARIA PAZ;YBARRA SAINZ DE LA MAZA MARCIAL. Modificacionesestatutarias. 1. Modificaci贸n total de estatutos que comprende del 1潞 al 58潞.-. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 4429 , F 64, S 8, H SE 16553, I/A36 ( 5.01.18).
12 de Septiembre de 2016Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 4429 , F 64, S 8, H SE 16553, I/A 35 (22.08.16).
18 de Febrero de 2016Nombramientos. Auditor: CABEZA Y PARRA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 4429 , F 63, S 8,H SE 16553, I/A 34 ( 9.02.16).
24 de Diciembre de 2015Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 4429 , F 63, S 8, H SE 16553, I/A 33 (11.12.15).
21 de Septiembre de 2015Otros conceptos: ANOTACION PREVENTIVA DEMANDA DE IMPUGNACION ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA , DE 31 dejulio de 2014 A QUE SE REFIEREN LAS ANTERIORES INSCRIPCIONES 30& Y 32&. Datos registrales. T 4429 , F 63, S 8, H SE16553, I/A B (10.09.15).
05 de Junio de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 4,56 Euros. Desembolsado: 4,56 Euros. Resultante Suscrito: 271.000,92 Euros. ResultanteDesembolsado: 271.000,92 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 70.049,14 Euros. Desembolsado: 70.049,14 Euros. ResultanteSuscrito: 341.050,06 Euros. Resultante Desembolsado: 341.050,06 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos:MODIFICADO EL ARTICULO 6潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- . Art铆culo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 6潞 DELOS ESTATUTOS SOCIALES.- . Datos registrales. T 768 , F 139, S 8, H SE 16553, I/A 32 (27.05.15).
17 de Abril de 2015Nombramientos. Auditor: MAF AUDITORES SLP. Datos registrales. T 768 , F 139, S 8, H SE 16553, I/A 31 (24.03.15).
20 de Noviembre de 2014Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 768 , F 138, S 8, H SE 16553, I/A 30 (12.11.14).
10 de Septiembre de 2014Otros conceptos: demanda impugnacion acuerdo de cese de do帽a Mercedes Montero Gonzalez, adoptado en junta de 26 de junio de2013.- Datos registrales. T 768 , F 137, S 8, H SE 16553, I/A A (22.08.14).
14 de Abril de 2014Nombramientos. Auditor: PARRA CASADO JOSE. Datos registrales. T 768 , F 137, S 8, H SE 16553, I/A 28 (28.03.14).
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RAMOS AGUILAR GONZALO. Nombramientos. SecreNoConsj: SANCHEZ SABUGAL MARIADE LOS ANGELES. Datos registrales. T 768 , F 137, S 8, H SE 16553, I/A 29 ( 1.04.14).
28 de Noviembre de 2013Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 768 , F 137, S 8, H SE 16553, I/A 27 (20.11.13).
21 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTERO GONZALEZ INMACULADA;MONTERO GONZALEZ MERCEDES. Pres.Com.Ej.:CALVENTE VAZQUEZ MARIA. Sec.Com.Ej.: YBARRA SAINZ DE LA MAZA MARCIAL. Miem.Com.Ej.: YBARRA SAINZ DE LA MAZAMARCIAL;CALVENTE VAZQUEZ MARIA. Vicepresid.: MONTERO GONZALEZ MERCEDES. Revocaciones. Apoderado:INMACULADA MONTERO GONZALEZ;MONTERO GONZALEZ MARIA INMACULADA. Nombramientos. Vicepresid.: CALVENTEVAZQUEZ MARIA. Cons.Del.Man: CALVENTE VAZQUEZ MARIA;YBARRA SAINZ DE LA MAZA MARCIAL. Datos registrales. T 768, F 136, S 8, H SE 16553, I/A 26 (12.11.13).
20 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: MONTERO GONZALEZ MERCEDES. Datos registrales. T 768 , F 136, S 8, H SE 16553, I/A 25 (7.08.13).
08 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTERO MONTERO MANUEL MARIA;MONTERO GONZALEZ CRISTINA;VAZQUEZ LOPEZFRANCISCA;MONTERO GONZALEZ INMACULADA;CALVENTE VAZQUEZ MARIA;YBARRA MENDARO JUAN;MONTEROGONZALEZ MERCEDES;BASALLOTE GARCIA JUAN. Con.Delegado: BASALLOTE GARCIA JUAN. Presidente: YBARRAMENDARO JUAN. Consejero: CALVENTE VAZQUEZ ALONSO. Vicepresid.: MONTERO GONZALEZ MERCEDES. Nombramientos.SecreNoConsj: RAMOS AGUILAR GONZALO. Consejero: YBARRA MENDARO JUAN;MONTERO GONZALEZMERCEDES;MONTERO GONZALEZ INMACULADA;MONTERO GONZALEZ CRISTINA;CALVENTE VAZQUEZ MARIA;CALVENTEVAZQUEZ ALONSO;YBARRA SAINZ DE LA MAZA MARCIAL. Presidente: YBARRA MENDARO JUAN. Vicepresid.: MONTEROGONZALEZ MERCEDES. Miem.Com.Ej.: YBARRA SAINZ DE LA MAZA MARCIAL;MONTERO GONZALEZ MERCEDES;CALVENTEVAZQUEZ MARIA Modificaciones estatutarias. 32. Administraci贸n y Representacion.-.Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Comit茅 ejecutivo. Datos registrales. T 768 , F 135, S 8, H SE 16553, I/A 23 (20.02.13).
Nombramientos. Pres.Com.Ej.: CALVENTE VAZQUEZ MARIA. Apo.Manc.: CALVENTE VAZQUEZ MARIA. Sec.Com.Ej.: YBARRASAINZ DE LA MAZA MARCIAL. Apo.Manc.: YBARRA SAINZ DE LA MAZA MARCIAL;MONTERO GONZALEZ MERCEDES. Datosregistrales. T 768 , F 135, S 8, H SE 16553, I/A 24 (25.02.13).
15 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: MONTERO MONTERO MERCEDES. Consejero: MONTERO MONTERO MERCEDES. Vicesecret.:MONTERO GONZALEZ MERCEDES. Nombramientos. Consejero: CALVENTE VAZQUEZ ALONSO. Vicepresid.: MONTEROGONZALEZ MERCEDES. Datos registrales. T 768 , F 134, S 8, H SE 16553, I/A 22 ( 5.03.12).
18 de Noviembre de 2009Reelecciones. SecreNoConsj: RAMOS AGUILAR GONZALO. Consejero: MONTERO MONTERO MANUEL MARIA;MONTEROGONZALEZ CRISTINA;VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCA;MONTERO GONZALEZ INMACULADA;CALVENTE VAZQUEZMARIA;MONTERO MONTERO MERCEDES;YBARRA MENDARO JUAN;MONTERO GONZALEZ MERCEDES. Vicesecret.:MONTERO GONZALEZ MERCEDES. Consejero: BASALLOTE GARCIA JUAN. Con.Delegado: BASALLOTE GARCIA JUAN.Presidente: YBARRA MENDARO JUAN. Vicepresid.: MONTERO MONTERO MERCEDES. Datos registrales. T 768 , F 133, S 8, HSE 16553, I/A 21 ( 6.11.09).
29 de Octubre de 2009Fe de erratas: Por error se hizo constar que Don Juan Ybarra Mendaro fue designado por acuerdo del Consejo de Administraci贸n dela sociedad "HOTELERA SEVILLANA, S.A." de fecha 30 de junio de 2.004 como Vicepresidente del mismo, cuando en realidad fuedesignado Presidente.-Por error se hizo constar que Do帽a Mercedes Montero Montero fue designada por acuerdo del Consejo deAdministraci贸n de la sociedad "HOTELERA SEVILLANA, S.A." de fecha 30 de junio de 2.004 como Presidente del mismo, cuandoenrealidad fue designada Vicepresidente.- Datos registrales. T 768 , F 130, S 8, H SE 16553, I/A 19 (20.09.05).