Buscador CIF Logo

Actos BORME Hoteles Participados Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Hoteles Participados Sl

Actos BORME Hoteles Participados Sl - B83781229

Tenemos registrados 7 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Hoteles Participados Sl con CIF B83781229

馃敊 Perfil de Hoteles Participados Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Hoteles Participados Sl

04 de Febrero de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: EZQUIAGA DOMINGUEZ IGNACIO RAMON. Presidente: EZQUIAGA DOMINGUEZ IGNACIORAMON. Consejero: CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL. Vicepresid.: CORPORACION EMPRESARIALY FINANCIERA DE GALICIA SL. Consejero: MELDON INVERSIONES 2008 SL. SecreNoConsj: RIVILLA CALLE BLANCA.VsecrNoConsj: TOUBES TORRES PALOMA. Representan: GARCIA-VILCHES MARIN RAMON;MACIAS HERNANDEZ VICTOR.Nombramientos. Liquidador: GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA SL. Representan: NU脩EZ GARCIA JOSE RAMON.Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 29786 , F 152, S 8, H M 338986, I/A 13 (24.01.14).

23 de Septiembre de 2013
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: VILA ABELLAN GARCIA MARIA ISABEL. Revocaciones. Apoderado: RAMOS FERNANDEZCARLOS. Nombramientos. VsecrNoConsj: TOUBES TORRES PALOMA. Datos registrales. T 29786 , F 150, S 8, H M 338986, I/A11 (16.09.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RAMOS FERNANDEZ CARLOS. Nombramientos. Consejero: MELDON INVERSIONES 2008 SL.Representan: MACIAS HERNANDEZ VICTOR. Datos registrales. T 29786 , F 151, S 8, H M 338986, I/A 12 (16.09.13).

16 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Representan: MARINO ARZUA CARLOS. Nombramientos. Representan: GARCIA-VILCHES MARIN RAMON.Datos registrales. T 29786 , F 150, S 8, H M 338986, I/A 10 ( 5.11.12).

17 de Octubre de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 13.352.038,00 Euros. Resultante Suscrito: 58.519.892,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital.-. Datos registrales. T 29786 , F 149, S 8, H M 338986, I/A 9 ( 1.10.12).

03 de Mayo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: VAZQUEZ SACRISTAN MARIA VICTORIA. Vicepresid.: VAZQUEZ SACRISTAN MARIA VICTORIA.Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ SACRISTAN MARIA VICTORIA. Nombramientos. Representan: MARINO ARZUA CARLOS.Apoderado: MARINO ARZUA CARLOS. Consejero: CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL. Vicepresid.:CORPORACION EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE GALICIA SL. Datos registrales. T 19340 , F 121, S 8, H M 338986, I/A 8(19.04.12).

02 de Julio de 2010
Nombramientos. VsecrNoConsj: VILA ABELLAN GARCIA MARIA ISABEL. Datos registrales. T 19340 , F 121, S 8, H M 338986, I/A7 (22.06.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n