Buscador CIF Logo

Actos BORME Housers Global Properties Pfp Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Housers Global Properties Pfp Sl

Actos BORME Housers Global Properties Pfp Sl - B87269999

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Housers Global Properties Pfp Sl con CIF B87269999

馃敊 Perfil de Housers Global Properties Pfp Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Housers Global Properties Pfp Sl

24 de Febrero de 2023
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 40 de los Estatutos sociales.. Cambio de denominaci贸n social. HOUSERSGLOBAL PROPERTIES SL. Datos registrales. T 34344 , F 224, S 8, H M 603354, I/A 27 (17.02.23).

20 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO;LOPEZ SAN MARTIN LAURA;MARTIN GIL NATALIA. Datosregistrales. T 34344 , F 222, S 8, H M 603354, I/A 25 (12.05.22).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: TARAZONA TUDELA FEDERICO. Datos registrales. T 34344 , F 223, S 8, H M 603354, I/A 26(12.05.22).

15 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: LUNA CORRAL ALVARO;BALCAZAR TORRADO JUAN ANTONIO;RAMIREZ JEREZ JAVIER.Nombramientos. Apo.Sol.: LUNA CORRAL ALVARO;BALCAZAR TORRADO JUAN ANTONIO;RAMIREZ JEREZ JAVIER. Datosregistrales. T 34344 , F 220, S 8, H M 603354, I/A 24 ( 7.12.21).

17 de Noviembre de 2020
Cambio de domicilio social. C/ DULCE CHACON 55 18陋 - TORRE CHAMARTIN (MADRID). Datos registrales. T 34344 , F 220, S8, H M 603354, I/A 23 (10.11.20).

09 de Julio de 2020
Revocaciones. Apoderado: IGLESIAS PUJANA RAUL. Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ JEREZ JAVIER. Datosregistrales. T 34344 , F 219, S 8, H M 603354, I/A 22 ( 2.07.20).

05 de Agosto de 2019
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: IGLESIAS PUJANA RAUL. Consejero: NU脩EZ PERDIGONES JUAN LUIS;BOMANIINVERSIONES SL. Vicepresid.: BOMANI INVERSIONES SL. Representan: MEGIAS COMIN MIGUEL. Nombramientos.SecreNoConsj: CRESPO RODRIGUEZ RAMON. Consejero: BOMANI INVERSIONES SL;IASESORIA FLC SL. Vicepresid.: BOMANIINVERSIONES SL. Representan: MEGIAS COMIN MIGUEL;GONZALEZ LOPEZ DOMINGO JAVIER. Datos registrales. T 34344 , F218, S 8, H M 603354, I/A 21 (29.07.19).

21 de Enero de 2019
Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 112 (MADRID). Datos registrales. T 34344 , F 217, S 8, H M 603354, I/A19 (14.01.19).

20 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: BALCAZAR TORRADO JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 34344 , F 216, S 8, H M 603354, I/A 18(12.12.18).

20 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: BRUSOLA VALLS ANTONIO. Presidente: BRUSOLA VALLS ANTONIO. Consejero: MARTINEZCANUT JAVIER. Revocaciones. Apoderado: BRUSOLA VALLS ANTONIO;BRUSOLA VALLS ANTONIO;BRUSOLA VALLSANTONIO. Nombramientos. Consejero: NU脩EZ PERDIGONES JUAN LUIS;BOMANI INVERSIONES SL. Presidente: LUNACORRAL ALVARO. Vicepresid.: BOMANI INVERSIONES SL. Representan: MEGIAS COMIN MIGUEL. Datos registrales. T 34344 ,F 216, S 8, H M 603354, I/A 17 (12.07.18).

02 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: FINTECH-HOUSERS SL. Representan: PEREZ SANCHEZ JESUS. Datos registrales. T 34344 , F216, S 8, H M 603354, I/A 16 (21.03.18).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n