Actos BORME de Howden Iberia Sa
21 de Diciembre de 2023Modificaciones estatutarias. modificaci贸n del art铆culo 25 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 40829 , F 22, S 8, H M243014, I/A 100 (14.12.23).
20 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: SOUSA FERREIRA ALBERTO VIEIRA NUNES DA CRUZ. Datos registrales. T 40829 , F 21, S 8, HM 243014, I/A 99 (13.11.23).
10 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROBLA ROZAS OLGA;BARROS ALFAYA PALOMA. Datos registrales. T 40829 , F 20, S 8, H M243014, I/A 97 ( 2.11.23).
Nombramientos. Apoderado: LAGE DOS SANTOS MONICA. Datos registrales. T 40829 , F 21, S 8, H M 243014, I/A 98 ( 2.11.23).
08 de Noviembre de 2023Cambio de domicilio social. PASEO DE RECOLETOS 37 - 4潞 PISO (MADRID). Datos registrales. T 40829 , F 20, S 8, H M243014, I/A 96 (31.10.23).
23 de Agosto de 2023Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: HOWDEN ARTAI SA. Datos registrales. T 40829 , F 17, S 8, H M 243014, I/A 95(16.08.23).
03 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: HERRERO LEON SANTIAGO. Presidente: HERRERO LEON SANTIAGO. Vicepresid.: GONZALEZPEREZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Presidente: GONZALEZ PEREZ JOSE MANUEL. Vicepresid.: MARIN MORENOSALVADOR. Datos registrales. T 40829 , F 15, S 8, H M 243014, I/A 90 (27.07.23).
19 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ BRIZUELA NORMA LILIANA. Datos registrales. T 40829 , F 14, S 8, H M 243014, I/A 89(12.06.23).
05 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: CASTELO MARIN MARIA LUISA;REAL DE ASUA AGUIRREZABAL EDUARDO. Datos registrales. T40829 , F 14, S 8, H M 243014, I/A 88 (29.05.23).
30 de Enero de 2023Nombramientos. Apoderado: ALMOGUERA DE ASIS RAMON. Datos registrales. T 40829 , F 13, S 8, H M 243014, I/A 87(23.01.23).
28 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apoderado: LAGE DOS SANTOS MONICA. Datos registrales. T 40829 , F 13, S 8, H M 243014, I/A 86 (21.09.22).
26 de Septiembre de 2022Ceses/Dimisiones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 40829 , F 13, S8, H M 243014, I/A 85 (19.09.22).
06 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAIZ DE BUSTAMANTE PEREZ MARIA JOSE;PEARSON MORENO EVA MARIA;CASTELLONBUENO MIGUEL ANGEL;SANCHEZ LAZARO MARIA JESUS;SOLER BALASCH GLORIA;PALMA ALCANTARILLA LORENA. Datosregistrales. T 40829 , F 12, S 8, H M 243014, I/A 84 (29.06.22).
10 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: MATARRANZ CARPIZO ANA;URIA MATILLA ASIER;SOTO LOPEZ FLOR. Datos registrales. T40829 , F 11, S 8, H M 243014, I/A 83 ( 3.06.22).
06 de Junio de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAIZ DE BUSTAMANTE PEREZ MARIA JOSE;PEARSON MORENO EVA MARIA;CASTELLONBUENO MIGUEL ANGEL;SANCHEZ LAZARO MARIA JESUS;SOLER BALASCH GLORIA;PALMA ALCANTARILLA LORENA. Datosregistrales. T 40829 , F 11, S 8, H M 243014, I/A 82 (30.05.22).
01 de Junio de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: SAIZ DE BUSTAMANTE PEREZ MARIA JOSE;PALMA ALCANTARILLA LORENA. Apoderado:BERNABE ANDRES ROSA ANA. Apo.Man.Soli: CASTELLON BUENO MIGUEL ANGEL. Apoderado: SANCHEZ LAZARO MARIAJESUS. Apo.Man.Soli: BERNABE ANDRES ROSA ANA;CASTELLON BUENO MIGUEL ANGEL;GONZALEZ DERRIALFONSO;SOLER BALASCH GLORIA. Datos registrales. T 40829 , F 10, S 8, H M 243014, I/A 81 (25.05.22).
22 de Julio de 2021Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 725.691,65 Euros. Desembolsado: 725.691,65 Euros. Resultante Suscrito: 815.451,00 Euros.Resultante Desembolsado: 815.451,00 Euros. Datos registrales. T 40829 , F 10, S 8, H M 243014, I/A 80 (15.07.21).
16 de Julio de 2021Reelecciones. Consejero: GONZALEZ PEREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 40829 , F 9, S 8, H M 243014, I/A 79 (9.07.21).
05 de Julio de 2021Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SEGUMOR CORREDURIA DE SEGUROS SL. Datos registrales. T 40829 , F 9, S8, H M 243014, I/A 78 (28.06.21).
17 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: SOLER BALASCH GLORIA. Datos registrales. T 40829 , F 8, S 8, H M 243014, I/A 77 (10.06.21).
12 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: DE QUIROS FERNANDEZ I脩IGO BERNALDO. Datos registrales. T 40829 , F 7, S 8, H M 243014, I/A76 ( 5.05.21).
21 de Enero de 2021Nombramientos. Apoderado: ALARCON MEDINA JAVIER. Datos registrales. T 40829 , F 7, S 8, H M 243014, I/A 75 (14.01.21).
18 de Septiembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: HYPERION INSURANCE GROUP LIMITED. Representan: MU脩OZ ROJAS ENTRECANALES LUISIGNACIO. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 16潞, 19潞, 27潞, 28潞 Y REENUMERACION DE TODOSLOS ARTICULOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 40829 , F 1, S 8, H M 243014, I/A 74 (11.09.20).
24 de Agosto de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33552 , F 79, S 8, H M 243014, I/A 73 (17.08.20).
11 de Agosto de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: REAL DE ASUA AGUIRREZABAL EDUARDO;JUAN PEIRO ALEIXANDRE;GARCIA LUNA JOSE-ALVARO;MENDIALDUA LEZON IGNACIO. Datos registrales. T 33552 , F 79, S 8, H M 243014, I/A 72 ( 4.08.20).
30 de Enero de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: BERNABE ANDRES ROSA ANA. Datos registrales. T 33552 , F 77, S 8, H M 243014, I/A 68(23.01.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ LAZARO MARIA JESUS. Datos registrales. T 33552 , F 77, S 8, H M 243014, I/A 69(23.01.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTELLON BUENO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 33552 , F 78, S 8, H M 243014, I/A 70(23.01.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ DERRI ALFONSO. Datos registrales. T 33552 , F 78, S 8, H M 243014, I/A 71(23.01.20).
01 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: ALARCON MEDINA JAVIER. Datos registrales. T 33552 , F 76, S 8, H M 243014, I/A 67 (24.06.19).
12 de Marzo de 2019Nombramientos. Consejero: REAL DE ASUA AGUIRREZABAL EDUARDO. Datos registrales. T 33552 , F 76, S 8, H M 243014, I/A66 ( 5.03.19).
05 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ LAZARO MARIA JESUS. Datos registrales. T 33552 , F 75, S 8, H M 243014, I/A 63(25.02.19).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ LAZARO MARIA JESUS. Datos registrales. T 33552 , F 75, S 8, H M 243014, I/A 64(25.02.19).
Nombramientos. Apoderado: ALMOGUERA DE ASIS RAMON. Datos registrales. T 33552 , F 75, S 8, H M 243014, I/A 65(25.02.19).
21 de Febrero de 2019Revocaciones. Apoderado: CHARLO GOMEZ ALFONSO. Datos registrales. T 33552 , F 74, S 8, H M 243014, I/A 62 (14.02.19).
19 de Febrero de 2019Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 26潞 de los estatutos sociales. . Datos registrales. T 33552 , F 74, S 8, H M243014, I/A 61 (12.02.19).
16 de Noviembre de 2018Reelecciones. Consejero: HERRERO LEON SANTIAGO;MARIN MORENO SALVADOR. Modificaciones estatutarias. Modificadoel art铆culo 26潞 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 33552 , F 73, S 8, H M 243014, I/A 59 ( 8.11.18).
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GONZALEZ PEREZ JOSE MANUEL. Nombramientos. VsecrNoConsj: ALMOGUERA DE ASISRAMON. Con.Delegado: MARIN MORENO SALVADOR. Datos registrales. T 33552 , F 74, S 8, H M 243014, I/A 60 ( 8.11.18).
08 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTELLON BUENO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 33552 , F 73, S 8, H M 243014, I/A 58( 1.06.18).
07 de Junio de 2018Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: HOWDEN DRIVE SA. Datos registrales. T 33552 , F 69, S 8, H M 243014, I/A 56(31.05.18).
Nombramientos. Apoderado: MATAMOROS PANERO MARIA ELENA. Datos registrales. T 33552 , F 72, S 8, H M 243014, I/A 57(31.05.18).
16 de Noviembre de 2017Reelecciones. Representan: MU脩OZ ROJAS ENTRECANALES LUIS IGNACIO. Consejero: HYPERION INSURANCE GROUPLIMITED. Datos registrales. T 33552 , F 69, S 8, H M 243014, I/A 55 ( 8.11.17).
30 de Octubre de 2017Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: HOWDEN LATIN AMERICA HOLDINGS SL. Datos registrales. T 33552 , F 68, S 8,H M 243014, I/A 54 (20.10.17).
11 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: MARIN ROMERO SALVADOR. Datos registrales. T 33552 , F 67, S 8, H M 243014, I/A 52 ( 3.04.17).
Nombramientos. Apoderado: CHARLO GOMEZ ALFONSO. Datos registrales. T 33552 , F 68, S 8, H M 243014, I/A 53 ( 3.04.17).
10 de Abril de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Consejero: GONZALEZ PEREZ JOSE MANUEL. Vicepresid.: GONZALEZ PEREZ JOSEMANUEL. Con.Delegado: GONZALEZ PEREZ JOSE MANUEL. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 26潞 DELOS ESTATUTOS SOCIALES, EN LO RELATIVO A LA REMUNERACION DE LOS ADMINISTRADORES. Datos registrales. T33552 , F 67, S 8, H M 243014, I/A 51 (31.03.17).
02 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: BERNABE ANDRES ROSA ANA. Datos registrales. T 33552 , F 66, S 8, H M 243014, I/A 50(25.10.16).
21 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: CASTELO MARIN MARIA LUISA. Datos registrales. T 33552 , F 66, S 8, H M 243014, I/A 49(14.09.16).
22 de Agosto de 2016Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: UBK CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA. Datos registrales. T33552 , F 63, S 8, H M 243014, I/A 48 (10.08.16).
11 de Julio de 2016Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ FERNANDEZ CESAR. Datos registrales. T 33552 , F 62, S 8, H M 243014, I/A 47(30.06.16).
19 de Mayo de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ FERNANDEZ CESAR. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ FERNANDEZ CESAR.Datos registrales. T 33552 , F 61, S 8, H M 243014, I/A 46 (10.05.16).
09 de Mayo de 2016Modificaciones estatutarias. 26. Organo de administraci贸n.. Datos registrales. T 33552 , F 61, S 8, H M 243014, I/A 45 (28.04.16).
31 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: CARVAJAL ARGUELLES JUAN;SATRUSTEGUI PEREZ DE VILLAAMIL SANTIAGO. Datosregistrales. T 33552 , F 60, S 8, H M 243014, I/A 44 (11.03.16).
18 de Agosto de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: HENRIQUEZ DE LUNA LOSADA EDUARDO. Datos registrales. T 33552 , F 60, S 8, H M 243014, I/A43 (10.08.15).
17 de Junio de 2015Modificaciones estatutarias. Dejado sin contenido el art铆culo 8 y modificados el 9, 10, 11, 13, 15, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 32 y 33 delos estatutos sociales.. Datos registrales. T 22851 , F 191, S 8, H M 243014, I/A 42 ( 9.06.15).
02 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Representan: HENRIQUEZ DE LUNA LOSADA EDUARDO. Nombramientos. Representan: MU脩OZ ROJASENTRECANALES LUIS IGNACIO. Datos registrales. T 22851 , F 191, S 8, H M 243014, I/A 41 (23.02.15).
18 de Diciembre de 2014Reelecciones. Consejero: SATRUSTEGUI PEREZ DE VILLAAMIL SANTIAGO;CARVAJAL ARGUELLES JUAN;MARIN MORENOSALVADOR. Datos registrales. T 22851 , F 189, S 8, H M 243014, I/A 38 (10.12.14).
Revocaciones. Apoderado: HENRIQUEZ DE LUNA LOSADA EDUARDO. Datos registrales. T 22851 , F 190, S 8, H M 243014, I/A39 (10.12.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ FERNANDEZ CESAR. Datos registrales. T 22851 , F 190, S 8, H M 243014, I/A 40(10.12.14).
29 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ-LLADO PRADO MARIA. Datos registrales. T 22851 , F 189, S 8, H M 243014, I/A 37(19.09.14).
26 de Junio de 2014Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Reelecciones. Consejero: HERRERO LEON SANTIAGO. Presidente: HERRERO LEONSANTIAGO. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datosregistrales. T 22851 , F 189, S 8, H M 243014, I/A 36 (18.06.14).
28 de Marzo de 2014Ceses/Dimisiones. Secretario: ESCARDO ZALDO MARIA. Nombramientos. Secretario: ALMOGUERA GARCIA JESUS. Datosregistrales. T 22851 , F 188, S 8, H M 243014, I/A 35 (20.03.14).
24 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLARUBIA DE FRANCISCO FERNANDO. Datos registrales. T 22851 , F 188, S 8, H M 243014,I/A 34 (14.06.13).
12 de Noviembre de 2012Reelecciones. Consejero: HYPERION INSURANCE GROUP LIMITED. Datos registrales. T 22851 , F 188, S 8, H M 243014, I/A 33(30.10.12).
29 de Marzo de 2012Reelecciones. Consejero: GONZALEZ PEREZ JOSE MANUEL;VILLARUBIA DE FRANCISCO FERNANDO. Vicepresid.: GONZALEZPEREZ JOSE MANUEL. Con.Delegado: GONZALEZ PEREZ JOSE MANUEL. Secretario: ESCARDO ZALDO MARIA. Datosregistrales. T 22851 , F 187, S 8, H M 243014, I/A 31 (16.03.12).
Nombramientos. Apo.Manc.: HENRIQUEZ DE LUNA LOSADA EDUARDO;SAIZ DE BUSTAMANTE PEREZ MARIA JOSE;PALMAALCANTARILLA LORENA. Datos registrales. T 22851 , F 188, S 8, H M 243014, I/A 32 (16.03.12).
03 de Agosto de 2011Cambio de domicilio social. C/ MONTALBAN NUMERO 7 (MADRID). Datos registrales. T 22851 , F 187, S 8, H M 243014, I/A 30(22.07.11).
13 de Septiembre de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 988.584,90 Euros. Resultante Suscrito: 89.759,35 Euros. Datos registrales. T 22851 , F186, S 8, H M 243014, I/A 29 ( 1.09.10).
06 de Abril de 2010Reelecciones. Consejero: DIAZ-LLADO PRADO MARIA. Datos registrales. T 22851 , F 186, S 8, H M 243014, I/A 28 (23.03.10).
14 de Enero de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 525.243,95 Euros. Desembolsado: 525.243,95 Euros. Resultante Suscrito: 1.078.344,25 Euros.Resultante Desembolsado: 1.078.344,25 Euros. Datos registrales. T 22851 , F 185, S 8, H M 243014, I/A 27 ( 4.01.10).
22 de Julio de 2009Ceses/Dimisiones. Presidente: HOWDEN DAVID PHILIP. Consejero: HOWDEN DAVID PHILIP. Nombramientos. Consejero:SATRUSTEGUI PEREZ DE VILLAAMIL SANTIAGO;CARVAJAL ARGUELLES JUAN;MARIN MORENO SALVADOR. Datosregistrales. T 22851 , F 184, S 8, H M 243014, I/A 25 (10.07.09).
Nombramientos. Presidente: HERRERO LEON SANTIAGO. Datos registrales. T 22851 , F 185, S 8, H M 243014, I/A 26 (10.07.09).
20 de Mayo de 2009Revocaciones. Apoderado: SAIZ DE BUSTAMANTE MARIA JOSE. Datos registrales. T 22851 , F 183, S 8, H M 243014, I/A 23 (5.05.09).
Nombramientos. Apoderado: HENRIQUEZ DE LONA LOSADA EDUARDO. Datos registrales. T 22851 , F 184, S 8, H M 243014,I/A 24 ( 5.05.09).
13 de Mayo de 2009Nombramientos. Consejero: HERRERO LEON SANTIAGO. Datos registrales. T 22851 , F 183, S 8, H M 243014, I/A 22 ( 4.05.09).