Actos BORME de Hra Pharma Iberia Sl
17 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: DE MIR LLUCH LUIS. Datos registrales. T 39737 , F 27, S 8, H M 486418, I/A 30 ( 9.10.23).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ LOPEZ MONICA. Datos registrales. T 39737 , F 29, S 8, H M 486418, I/A 31 ( 9.10.23).
Nombramientos. Apoderado: DIEZ GARCIA JAVIER. Datos registrales. T 39737 , F 30, S 8, H M 486418, I/A 32 ( 9.10.23).
19 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: BARATA CORREIA MARIA INES EMAUZ. Datos registrales. T 39737 , F 27, S 8, H M 486418, I/A 29(12.09.23).
13 de Septiembre de 2023Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 163 2 - ESPACIO UTOPICUS (MADRID). Datos registrales. T 39737 , F27, S 8, H M 486418, I/A 28 ( 6.09.23).
04 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BARATA CORREIA MARIA INES EMAUZ. Nombramientos. Adm. Solid.: ESCAMILLA GIRBAUMARIA. Datos registrales. T 39737 , F 26, S 8, H M 486418, I/A 27 (28.08.23).
15 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ALLAN DAVID GEOFFREY;HILTON MARTYN STUART. Nombramientos. Adm. Solid.: BARATACORREIA MARIA INES EMAUZ;PILIA MASSIMO. Datos registrales. T 39737 , F 26, S 8, H M 486418, I/A 26 ( 8.03.23).
24 de Febrero de 2023Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 39737 , F 26, S 8, H M 486418, I/A 25 (17.02.23).
30 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: BADOS RUIZ MARIA JOSE. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 23陋 la publicaci贸n delpoder mancomunado de BADOS RUIZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 39737 , F 25, S 8, H M 486418, I/A 23 (21.01.22).
21 de Febrero de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39737 , F 26, S 8, H M 486418, I/A 24 (14.02.22).
28 de Enero de 2022Revocaciones. Apoderado: BADOS RUIZ MARIA JOSE;GAINER ERIN ELISABETH;BADOS RUIZ MARIA JOSE. Datos registrales.T 39737 , F 25, S 8, H M 486418, I/A 23 (21.01.22).
20 de Diciembre de 2021Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: LABORATOIRE HRA PHARMA. Datos registrales. T 39737 , F 25, S 8, H M486418, I/A 22 (13.12.21).
08 de Abril de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39737 , F 25, S 8, H M 486418, I/A 21 (30.03.21).
19 de Noviembre de 2020Otros conceptos: Rectificado el contenido del poder otorgado a do帽a Mar铆a In茅s Emauz Barata Correia, que caus贸 la inscripci贸n 16de la hoja social. Datos registrales. T 39737 , F 23, S 8, H M 486418, I/A 20 (12.11.20).
25 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: WRIGHT DAVID JOHN. Nombramientos. Adm. Solid.: HILTON MARTYN STUART. Datosregistrales. T 39737 , F 23, S 8, H M 486418, I/A 19 (18.02.20).
21 de Febrero de 2020Revocaciones. Apoderado: NORIEGA MONTIEL JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 39737 , F 23, S 8, H M 486418, I/A 18(14.02.20).
19 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: LACOURREGE SOPHIE CELINE. Datos registrales. T 39737 , F 22, S 8, H M 486418, I/A 17 (12.02.20).
27 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: BARATA CORREIA MARIA INES EMAUZ. Datos registrales. T 39737 , F 21, S 8, H M 486418, I/A 16(20.11.19).
06 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: PROL PEREZ FRANCISCO GABRIEL;BEN VAZQUEZ ANA;HERNANDEZ GONZALEZ MARIA. Fe deerratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 14 la publicaci贸n del nombramiento como apoderados de do帽a Mar铆a Hern谩ndezGonz谩lez, do帽a Ana Ben V谩zquez y don Francisco Gabriel Prol P茅rez. Datos registrales. T 26997 , F 19, S 8, H M 486418, I/A 14(14.10.19).
22 de Octubre de 2019Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 26997 , F 19, S 8, H M 486418, I/A 15 (15.10.19).
21 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: GAINER ERIN ELISABETH;VUILLET FRANCOIS PIERRE LOUIS. Presidente: GAINER ERINELISABETH. Consejero: GUILLARD HELENE;MASSART LUC. Con.Delegado: GAINER ERIN ELISABETH. Cons.Del.Sol: VUILLETFRANCOIS PIERRE LOUIS;MASSART LUC. Secretario: PROL PEREZ FRANCISCO GRABIEL. Nombramientos. Adm. Solid.:ALLAN DAVID GEOFFREY;WRIGHT DAVID JOHN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 26997 , F 19, S 8, H M 486418, I/A 14 (14.10.19).
25 de Septiembre de 2015Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 143 (MADRID). Datos registrales. T 26997 , F 18, S 8, H M 486418, I/A13 (18.09.15).
18 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: NORIEGA MONTIEL JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 26997 , F 18, S 8, H M 486418, I/A 12(10.12.13).
26 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apoderado: BADOS RUIZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 26997 , F 17, S 8, H M 486418, I/A 11 (19.11.13).