Actos BORME de Humana Spain Sl
12 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: LOPEZ MUÑOZ JOSE-IGNACIO. Datos registrales. T 17028 , F 186, S 8, H M 291363, I/A 31 (6.05.23).
25 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ECKERT STEFAN;MATUSZEK MARIOLA MARTA. Nombramientos. Adm. Unico: LOEWENALEXANDER. Modificaciones estatutarias. SE APRUEBA UN NUEVO TEXTO INTEGRO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES -ANULANDO LOS ANTERIORES INSCRITOS-. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradoresmancomunados a Administrador único. Datos registrales. T 17028 , F 180, S 8, H M 291363, I/A 29 (18.08.20).
Nombramientos. Apoderado: ALLENDE PEY JUAN LUIS. Datos registrales. T 17028 , F 185, S 8, H M 291363, I/A 30 (18.08.20).
17 de Mayo de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: GODED CABELLO MARTA. Apoderado: GODED CABELLO MARTA. Apo.Manc.: GODED CABELLOMARTA. Apo.Man.Soli: ROLLA VALENTINA. Nombramientos. Apoderado: LOWEN ALEXANDER. Datos registrales. T 17028 , F84, S 8, H M 291363, I/A 28 ( 9.05.18).
21 de Marzo de 2017Declaración de unipersonalidad. Socio único: DMK BABY GMBH. Nombramientos. Apoderado: GODED CABELLO MARTA.Cambio de domicilio social. AVDA ALBERTO ALCOCER 46 5º B (MADRID). Datos registrales. T 17028 , F 84, S 8, H M 291363,I/A 27 (13.03.17).
17 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROLLA VALENTINA. Datos registrales. T 17028 , F 83, S 8, H M 291363, I/A 26 (10.09.15).
08 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: KOPPMEIER AVID SIEGFRIED;ECKERT STEFAN. Presidente: ECKERT STEFAN. Consejero:CUESTA IVAN. Cons.Del.Man: ECKERT STEFAN;CUESTA IVAN. Secretario: WIENBERG CARLOS. Nombramientos. Adm.Mancom.: ECKERT STEFAN;MATUSZEK MARIOLA MARTA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo deadministración a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 17028 , F 83, S 8, H M 291363, I/A 25 (26.05.15).
01 de Junio de 2015Nombramientos. Apoderado: WIENBERG CARLOS;TOMAS BRONCHAL MARIA. Datos registrales. T 17028 , F 83, S 8, H M291363, I/A 24 (22.05.15).
20 de Mayo de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: ECKERT STEFAN;MATUSZEK MARIOLA MARTA. Apo.Manc.: GODED CABELLO MARTA. Datosregistrales. T 17028 , F 82, S 8, H M 291363, I/A 23 (11.05.15).
06 de Marzo de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMEZ VALCARCEL JOSE RAMON. Apoderado: GOMEZ VALCARCEL JOSE RAMON. Apo.Manc.:GOMEZ VALCARCEL JOSE RAMON. Apoderado: GOMEZ VALCARCEL JOSE RAMON;GOMEZ VALCARCEL JOSE RAMON.Nombramientos. Apoderado: GODED CABELLO MARTA. Datos registrales. T 17028 , F 81, S 8, H M 291363, I/A 22 (25.02.15).
05 de Diciembre de 2014Revocaciones. Apoderado: VALSASINA RENATO RAUL. Apo.Sol.: VALSASINA RENATO RAUL;BEACHI ALESSANDRO.Apo.Manc.: VALSASINA RENATO RAUL;BEACHI ALESSANDRO. Otros conceptos: Revocados el 07/10/2014 los poderesotorgados a D. Renato Valsasina mediante escrituras otorgadas por el Notario de Barcelona D. Javier García Ruiz, el 26 de marzo de2001, números 1737 y 1738, que causaron las inscripciones 22 y 23, respectivamente en el R.M. de Barcelona, 1& en este Registro.Datos registrales. T 17028 , F 81, S 8, H M 291363, I/A 21 (26.11.14).
26 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: GODED CABELLO MARTA. Apo.Manc.: ECKERT STEFAN;KOPPMEIER AVIDSIEGFRIED;CUESTA IVAN. Datos registrales. T 17028 , F 80, S 8, H M 291363, I/A 20 (17.09.14).
11 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: VALSASINA RENATO RAUL;BEACHI ALESSANDRO. Cons.Del.Man: VALSASINA RENATORAUL;BEACHI ALESSANDRO. Consejero: BRUGGEMEIER WILHELM. Nombramientos. Consejero: CUESTA IVAN. Datosregistrales. T 17028 , F 79, S 8, H M 291363, I/A 18 ( 3.06.14).
Nombramientos. Cons.Del.Man: ECKERT STEFAN;CUESTA IVAN. Apoderado: GOMEZ VALCARCEL JOSE RAMON. Datosregistrales. T 17028 , F 80, S 8, H M 291363, I/A 19 ( 3.06.14).
13 de Diciembre de 2013Cambio de domicilio social. AVDA DE BRUSELAS - EDIFICIO Nº 5, PLANTA PRIMERA, (ALCOBENDAS). Datos registrales. T17028 , F 79, S 8, H M 291363, I/A 17 ( 5.12.13).