Buscador CIF Logo

Actos BORME Humanis Servicios Inmobiliarios Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Humanis Servicios Inmobiliarios Sl

Actos BORME Humanis Servicios Inmobiliarios Sl - B84802339

Tenemos registrados 9 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Humanis Servicios Inmobiliarios Sl con CIF B84802339

🔙 Perfil de Humanis Servicios Inmobiliarios Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Humanis Servicios Inmobiliarios Sl

18 de Abril de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: NOMBELA GORDO LEONOR ELENA. Apo.Sol.: NOMBELA GORDO LEONOR ELENA;PRESEDOHUETE JAVIER. Apo.Manc.: PRESEDO HUETE JAVIER;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;GARCIA MARIN JOSE;RODRIGUEZHORNOS ANTONIO. Datos registrales. T 38890 , F 193, S 8, H M 418217, I/A 11 (11.04.23).

10 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: DE ENTRAMBASAGUAS ARCONES OLGA MARIA. Datos registrales. T 38890 , F 192, S 8, H M418217, I/A 10 ( 3.06.22).

16 de Agosto de 2021
Reelecciones. Consejero: SCIALDONE SAVERIO GUELFO;DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. Presidente: DIAVERICOMARIA DE SANTIS FRANCESCO. Modificaciones estatutarias. 12bis. Acciones/Participaciones.-Artículo 12 bis.- La asistencia a laJunta podrá realizarse por medios telemáticos, que garanticen debidamente la identidad del sujeto. En la convocatoria se describiránlos plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los socios previstos por los. Datos registrales. T 38890 , F 191, S 8, H M418217, I/A 9 ( 9.08.21).

30 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ BELTRAN TERESA. Fe de erratas: Se omitió por error en la inscripción 8 la publicacióndel nombramiento como apoderado de doña Teresa Rodríguez Beltrán. Datos registrales. T 23322 , F 137, S 8, H M 418217, I/A 8(14.05.19).

22 de Mayo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO. Revocaciones. Apoderado: SAENZ ESPINOSA JOSEANTONIO;RODRIGUEZ BELTRAN TERESA;RODRIGUEZ HORNOS ANTONIO;GARCIA MARIN JOSE;ACEBRON FERNANDEZALVARO;SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. Nombramientos. Consejero: PRESEDO HUETEJAVIER. Apoderado: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDO HUETE JAVIER;GARCIA MARIN JOSE;RODRIGUEZ HORNOSANTONIO;DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDO HUETE JAVIER. Datosregistrales. T 23322 , F 137, S 8, H M 418217, I/A 8 (14.05.19).

20 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Nombramientos. Apoderado: ACEBRON FERNANDEZALVARO;SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. Datos registrales. T 23322 , F 136, S 8, H M418217, I/A 7 ( 9.08.18).

14 de Octubre de 2016
Reelecciones. Consejero: SCIALDONE SAVERIO GUELFO;SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO;DIAVERICO MARIA DE SANTISFRANCESCO. Con.Delegado: SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Presidente: DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO.Secretario: ENSEÑAT BENLLIURE JAIME LUIS. Datos registrales. T 23322 , F 136, S 8, H M 418217, I/A 6 ( 5.10.16).

26 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Consejero: SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Con.Delegado: SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Consejero: SAENZESPINOSA JOSE ANTONIO;DIAVERICO MARIA DE SANTIS FRANCESCO. Presidente: DIAVERICO MARIA DE SANTISFRANCESCO. Secretario: ENSEÑAT BENLLIURE JAIME LUIS. Datos registrales. T 23322 , F 135, S 8, H M 418217, I/A 5(13.09.11).

31 de Diciembre de 2009
Ampliacion del objeto social. LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA.. Datos registrales. T 23322 , F 135, S 8, H M 418217,I/A 4 (21.12.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información