Actos BORME de Hydro Aluminium Iberia Sa
17 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 584 , F 50, S 8, H GU 9255, I/A 14 (10.11.23).
Ceses/Dimisiones. Presidente: ANDERSEN JOHANNES KRISTIAN. Consejero: ANDERSEN JOHANNES KRISTIAN;SCHARF-BERGMAN ROLAND SIEGBERT;HEXEBERG IVAR. Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANDRA BENEYTO ORBAN;JULIO SANZFERNANDEZ. Apoderado: GONZALEZ MORON RAMON. Apo.Man.Soli: GONZALEZ MORON RAMON;ESTEPA SALVADORALICIA;DAVID NAVARRO DE PALENCIA GILKERSON. Nombramientos. Consejero: BJERKAAS HANS;TROND OLAFCHRISTOPHERSEN. Presidente: TROND OLAF CHRISTOPHERSEN. Apoderado: LEIV ERIK ODEGAARD;SANDRA BENEYTOORBAN;ESTEPA SALVADOR ALICIA. Datos registrales. T 584 , F 51, S 8, H GU 9255, I/A 15 (10.11.23).
11 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: NAVARRO DE PALENCIA ZULAICA ANA. SecreNoConsj: NAVARRO DE PALENCIAGILKERSON DAVID. Nombramientos. SecreNoConsj: GONZALEZ ABAD REBECA. VsecrNoConsj: ORTILLES PRATS CARMEN.Datos registrales. T 584 , F 50, S 8, H GU 9255, I/A 13 ( 3.03.21).
22 de Octubre de 2020Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 584 , F 49, S 8, H GU 9255, I/A 12 (14.10.20).
03 de Enero de 2020Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 584 , F 49, S 8, H GU9255, I/A 11 (18.12.19).
22 de Octubre de 2019Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ANDERSEN JOHANNES KRISTIAN;ARANGUREN ISPIZUAIÑIGO;HEXEBERG IVAR;SCHARF-BERGMAN ROLAND SIEGBERT. Presidente: ANDERSEN JOHANNES KRISTIAN. Vicepresid.:ARANGUREN ISPIZUA IÑIGO. Con.Delegado: ARANGUREN ISPIZUA IÑIGO. Nombramientos. Consejero: ANDERSENJOHANNES KRISTIAN;ARANGUREN ISPIZUA IÑIGO;HEXEBERG IVAR;SCHARF-BERGMAN ROLAND SIEGBERT. Presidente:ANDERSEN JOHANNES KRISTIAN. Vicepresid.: ARANGUREN ISPIZUA IÑIGO. Con.Delegado: ARANGUREN ISPIZUA IÑIGO.Datos registrales. T 584 , F 49, S 8, H GU 9255, I/A 10 (11.10.19).
21 de Diciembre de 2018Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 584 , F 48, S 8, H GU9255, I/A 9 (14.12.18).
01 de Junio de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: HYDRO EXTRUDED SOLUTIONS AB. Datos registrales. T 584 , F48, S 8, H GU 9255, I/A 8 (23.05.18).
12 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 584 , F 48, S 8, H GU9255, I/A 7 (28.11.17).
23 de Mayo de 2016Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 584 , F 47, S 8, H GU9255, I/A 6 (13.05.16).
19 de Octubre de 2015Nombramientos. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 584 ,F 47, S 8, H GU 9255, I/A 5 ( 7.10.15).
31 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: FREW SANNA MARIKA SUSANNA. Nombramientos. Consejero: HEXEBERG IVAR. Datosregistrales. T 584 , F 47, S 8, H GU 9255, I/A 4 (20.07.15).
23 de Marzo de 2015Revocaciones. Apoderado: NAVARRO DE PALENCIA GILKERSON DAVID;BENEYTO ORBAN SANDRA;SANZ FERNANDEZJULIO;NAVARRO DE PALENCIA GILKERSON DAVID;ARANGUREN ISPIZUA IÑIGO;NAVARRO DE PALENCIA GILKERSONDAVID;NAVARRO DE PALENCIA GILKERSON DAVID. Apo.Sol.: GONZALEZ MORON RAMON. Apo.Man.Soli: BENEYTO ORBANSANDRA;ESTEPA SALVADOR ALICIA;NAVARRO DE PALENCIA GILKERSON DAVID;SANZ FERNANDEZ JULIO.Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MORON RAMON. Apo.Man.Soli: SANDRA BENEYTO ORBAN;JULIO SANZFERNANDEZ;ESTEPA SALVADOR ALICIA;GONZALEZ MORON RAMON;DAVID NAVARRO DE PALENCIA GILKERSON. Datosregistrales. T 584 , F 44, S 8, H GU 9255, I/A 3 (11.03.15).
15 de Septiembre de 2014Cambio de domicilio social. C/ PINTURA 1 - POLIGONO INDUSTRIAL MIRALCAMPO (AZUQUECA DE HENARES). Datosregistrales. T 584 , F 44, S 8, H GU 9255, I/A 2 (22.08.14).