Buscador CIF Logo

Actos BORME Hydro Building Systems Alumafel Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Hydro Building Systems Alumafel Sa

Actos BORME Hydro Building Systems Alumafel Sa - A01010065

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Sevilla para Hydro Building Systems Alumafel Sa con CIF A01010065

馃敊 Perfil de Hydro Building Systems Alumafel Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Sevilla

Actos BORME de Hydro Building Systems Alumafel Sa

28 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ DE SEGURA LACARRA SILVIA MARIA. Datos registrales. T 1413 , F 77, S 8, H VI 1375, I/A65 ( 3.09.10).

17 de Septiembre de 2010
Otros conceptos: La Sociedad segrega una parte de su patrimonio, sin extinci贸n de la misma, con traspaso del citado patrimonio auna Sociedad beneficiaria de nueva creaci贸n, integramente participada por la segregada.- Datos registrales. T 1413 , F 74, S 8, H VI1375, I/A 64 ( 3.09.10).

Otros conceptos: De conformidad con lo dispuesto en el art潞 231.2 del RRM, se extiende al margen de la inscripci贸n 64&, la notaprevistaen el mismo, que implica el cierre provisional de la hoja de la Compa帽铆a " HYDRO BUIL-DING SYSTEMS ALUMAFEL, S.A."UNIPERSONAL, durante el plazo de seis meses, a contar de hoy. Datos registrales. T 1413 , F 74, S 8, H VI 1375, I/A 64 1 (3.09.10).

26 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datosregistrales. T 1413 , F 73, S 8, H VI 1375, I/A 62 ( 6.08.10).

Revocaciones. Apoderado: LEBRIEZ MARZAL CHRISTINE. Nombramientos. Apoderado: VELASCO ALFONSEDA JOSE. Datosregistrales. T 1413 , F 73, S 8, H VI 1375, I/A 63 ( 6.08.10).

08 de Marzo de 2010
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: CASTAGNA MASSIMO. Con.Delegado: CASTAGNA MASSIMO. Consejero: CASTAGNA MASSIMO.Datos registrales. T 1413 , F 73, S 8, H VI 1375, I/A 61 (19.02.10).

16 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: NAVARRO DE PALENCIA GILKERSON DAVID;LOPEZ FRADE ANA MARIA. Datos registrales. T1413 , F 71, S 8, H VI 1375, I/A 58 ( 3.11.09).

Nombramientos. Apoderado: API脩ANIZ BEJAR FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1413 , F 71, S 8, H VI 1375, I/A 59 (3.11.09).

Ceses/Dimisiones. Presidente: CAVALIE JEAN FRANCOIS. Nombramientos. Consejero: HAUK RINGVOLD LARS;BECKERHORST;CASTAGNA MASSIMO. Presidente: HAUK RINGVOLD LARS. Vicepresid.: CAVALIE JEAN FRANCOIS;CASTAGNAMASSIMO. Con.Delegado: CASTAGNA MASSIMO. Datos registrales. T 1413 , F 72, S 8, H VI 1375, I/A 60 ( 3.11.09).

24 de Abril de 2009
Nombramientos. Apoderado: LEBRIEZ MARZAL CHRISTINE;GOMEZ DE SEGURA LACARRA SILVIA MARIA. Datos registrales. T1413 , F 69, S 8, H VI 1375, I/A 55 (14.04.09).

Revocaciones. Apoderado: CAVALIE JEAN FRANCOIS;VELASCO RUIZ DE OLALLA JOSE LUIS;GONZALEZ DIVASSONJOSE;SANCHEZ GANDARIAS OSCAR;URIA EGUILETA MIRIAM;GOMEZ DE SEGURA LACARRA SILVIA MARIA;ALONSOALMEIDA PABLO;API脩ANIZ BEJAR FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apoderado: VELASCO RUIZ DE OLALLA JOSELUIS;VILLANUEVA ECHEVERRIA JOSE MIGUEL;GONZALEZ DIVASSON JOSE;SAEZ DE IBARRA CRESPO LUIS;SERVANTBERNARD GEORGES;ALONSO ALMEIDA PABLO;VELASCO ALFONSEDA JOSE;URIA EGUILETA MIRIAM. Datos registrales. T1413 , F 69, S 8, H VI 1375, I/A 56 (14.04.09).

Nombramientos. Apoderado: VELASCO RUIZ DE OLALLA JOSE LUIS;SAEZ DE IBARRA CRESPO LUIS. Datos registrales. T1413 , F 71, S 8, H VI 1375, I/A 57 (14.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n