Actos BORME de I.p.asociados Correduria De Seguros Del Grupo Inmobiliaria Henares Sl
17 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: PABLOS ALONSO EZEQUIEL;PABLOS ALONSO FERNANDO. Datos registrales. T 803 , F 168, S8, H LE 3976, I/A 30 (11.01.17).
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PABLOS ALONSO EZEQUIEL;PABLOS ALONSO FERNANDO. Nombramientos. Adm.Mancom.: DEVON HOLDING SL;TAUT SL. Datos registrales. T 803 , F 168, S 8, H LE 3976, I/A 31 (11.01.17).
Nombramientos. Apo.Manc.: PABLOS GARCIA JORGE;PABLOS SALAZAR DIEGO. Datos registrales. T 803 , F 168, S 8, H LE3976, I/A 32 (11.01.17).
30 de Junio de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: AVILA RUBIO PAULA;GOMEZ PESO IGNACIO;NIHARRA LOPEZ ISABEL. Datos registrales. T803 , F 67, S 8, H LE 3976, I/A 27 (23.06.15).
Nombramientos. Apo.Manc.: PABLOS ALONSO FERNANDO;PABLOS ALONSO EZEQUIEL. Datos registrales. T 803 , F 68, S 8,H LE 3976, I/A 28 (23.06.15).
Revocaciones. Apoderado: SABADELL CUETO MANRIQUE;SANTAMARIA REY PRUDENCIO;FERNANDEZ DIEZ JUANJOSE;DIEZ RAMOS HILARIO;PABLOS ALONSO FERNANDO;PABLOS ALONSO EZEQUIEL;SABADELL CUETOMANRIQUE;FERNANDEZ DIEZ JUAN JOSE;DIEZ RAMOS HILARIO;CEPEDA DOMINGUEZ ANGEL JOSE;SANTAMARIA DEL REYPRUDENCIO. Datos registrales. T 803 , F 69, S 8, H LE 3976, I/A 29 (23.06.15).
27 de Agosto de 2014Declaración de unipersonalidad. Socio único: INMOBILIARIA HENARES SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: PABLOS ALONSOEZEQUIEL;PABLOS ALONSO FERNANDO. Presidente: PABLOS ALONSO EZEQUIEL. Vicepresid.: PABLOS ALONSO FERNANDO.Secretario: PABLOS ALONSO FERNANDO. Nombramientos. Adm. Mancom.: PABLOS ALONSO EZEQUIEL;PABLOS ALONSOFERNANDO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradoresmancomunados. Como consecuencia del cambio de estructura del órgano de administración, se modifican los Artículos 7º, 9º, 11º, 12º,13º, Capítulo 2º del Título III), Artículos 14º a 22º, ambos inclusive, y Artículos 24º y 25º, de los Estatutos Sociales. Datos registrales.T 803 , F 65, S 8, H LE 3976, I/A 26 (21.08.14).
23 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: FERRERO LEON VICTOR MANUEL. Apoderado: FERRERO LEON VICTOR MANUEL. Datosregistrales. T 803 , F 64, S 8, H LE 3976, I/A 25 (15.04.14).
18 de Septiembre de 2013Nombramientos. Secretario: PABLOS ALONSO FERNANDO. Apoderado: GOMEZ PESO IGNACIO. Datos registrales. T 803 , F64, S 8, H LE 3976, I/A 24 (11.09.13).
10 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: LINACERO FERNANDEZ MAXIMO RAMON. Consejero: LINACERO FERNANDEZ MAXIMO RAMON.Apoderado: LINACERO FERNANDEZ MAXIMO RAMON;LINACERO FERNANDEZ MAXIMO RAMON. Datos registrales. T 803 , F64, S 8, H LE 3976, I/A 23 ( 4.04.13).
31 de Enero de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: PABLOS ALONSO EZEQUIEL. Vicepresid.: PABLOS ALONSO FERNANDO. Secretario: FERREROLEON VICTOR MANUEL. Con.Delegado: FERRERO LEON VICTOR MANUEL. D. Gerente: FERRERO LEON VICTOR MANUEL.Nombramientos. Presidente: PABLOS ALONSO EZEQUIEL. Vicepresid.: PABLOS ALONSO FERNANDO. Secretario: LINACEROFERNANDEZ MAXIMO RAMON. Datos registrales. T 803 , F 64, S 8, H LE 3976, I/A 22 (21.01.11).