Buscador CIF Logo

Actos BORME I P M Maquinas Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera I P M Maquinas Sl

Actos BORME I P M Maquinas Sl - B11429750

Tenemos registrados 27 Actos BORME del Registro Mercantil de Cadiz para I P M Maquinas Sl con CIF B11429750

🔙 Perfil de I P M Maquinas Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Cadiz

Actos BORME de I P M Maquinas Sl

18 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apoderado: AMAIA DE LA PIEDAD AMONDARAIN;MIGUEL ANGEL MUNUERA GARCIA. Apo.Man.Soli: MANUELMORAL GARCIA;MANUEL MORAL GARCIA. Datos registrales. T 2369 , F 224, S 8, H CA 15612, I/A 30 ( 9.08.23).

13 de Junio de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ ZAFRA JACOBO;LOPEZ ZAFRA JACOBO. Datos registrales. T 2369 , F 224, S 8, H CA15612, I/A 29 ( 1.06.22).

30 de Marzo de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: IGLESIAS SANCHEZ OSCAR;CORZO UCEDA ANGEL. Nombramientos. Adm. Solid.: MIRANDAFONTES EMILIO. Datos registrales. T 2369 , F 223, S 8, H CA 15612, I/A 28 (22.03.22).

04 de Enero de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: BRAVO PAZ JUAN LUIS;PULIDO LOPEZ RAFAEL. Datos registrales. T 2369 , F 224, S 8, H CA 15612,I/A 27 (24.12.21).

08 de Enero de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: CUBELS VILA VICENTE ANTONIO. Datos registrales. T 2282 , F 165, S 8, H CA 15612, I/A 26(29.12.20).

04 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PULIDO LOPEZ RAFAEL. Datos registrales. T 2282 , F 165, S 8, H CA 15612, I/A 24 (23.10.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: CORCHERO MOYA MIRIAM. Datos registrales. T 2282 , F 165, S 8, H CA 15612, I/A 25 (26.10.20).

02 de Abril de 2019
Nombramientos. Apoderado: MIRANDA FONTES EMILIO. Datos registrales. T 2282 , F 164, S 8, H CA 15612, I/A 22 (26.03.19).

Nombramientos. Apoderado: MIRANDA FONTES EMILIO. Datos registrales. T 2282 , F 164, S 8, H CA 15612, I/A 23 (26.03.19).

30 de Enero de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ QUERO JESUS. Datos registrales. T 2282 , F 162, S 8, H CA 15612, I/A 20 (22.01.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ ZAFRA JACOBO;MIRANDA FONTES EMILIO. Datos registrales. T 2282 , F 162, S 8, H CA15612, I/A 21 (23.01.19).

14 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MILLAN LOPEZ FRANCISCO JAVIER;MORAL GARCIA MANUEL;SEVILLA MUROS SILVIA. Datosregistrales. T 2282 , F 160, S 8, H CA 15612, I/A 17 ( 5.11.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: SEVILLA MUROS SILVIA;PEREZ MONTERROSO VIRGINIA. Datos registrales. T 2282 , F 161, S 8, HCA 15612, I/A 18 ( 5.11.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: QUEIRO AMEIJEIRAS MANUEL. Datos registrales. T 2282 , F 162, S 8, H CA 15612, I/A 19 ( 5.11.18).

22 de Agosto de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: MILLAN LOPEZ FRANCISCO JAVIER;PULIDO LOPEZ RAFAEL;BRAVO PAZ JUAN LUIS. Datosregistrales. T 1260 , F 225, S 8, H CA 15612, I/A 15 (14.08.18).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JIMENEZ MARQUEZ DAVID;DI LORETO VICENTE. Nombramientos. Adm. Solid.: CORZOUCEDA ANGEL;IGLESIAS SANCHEZ OSCAR. Datos registrales. T 2282 , F 159, S 8, H CA 15612, I/A 16 (14.08.18).

18 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: PASCUAL GONZALEZ ALEJANDRO;QUEIRO AMEIJEIRAS MANUEL;OFICIALDEGUI ATIN JONAS.Datos registrales. T 1260 , F 225, S 8, H CA 15612, I/A 14 (10.05.18).

06 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ SAMPEDRO ENCARNACION. Nombramientos. Adm. Solid.: JIMENEZ MARQUEZDAVID;DI LORETO VICENTE;PASCUAL GONZALEZ ALEJANDRO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración:Administrador único a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1260 , F 225, S 8, H CA 15612, I/A 13 (27.03.18).

17 de Noviembre de 2017
Declaración de unipersonalidad. Socio único: OPERIBERICA SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DE LA PIEDAD MENDIAIGNACIO JESUS. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ SAMPEDRO ENCARNACION. Datos registrales. T 1260 , F 222, S 8,H CA 15612, I/A 9 ( 9.11.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: PASCUAL GONZALEZ ALEJANDRO;QUEIRO AMEIJEIRAS MANUEL;MARTINEZ QUERO JESUS.Apoderado: LOPEZ SAFRA JACOBO. Datos registrales. T 1260 , F 222, S 8, H CA 15612, I/A 10 ( 9.11.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MILLAN LOPEZ FRANCISCO;PULIDO LOPEZ RAFAEL;MORAL GARCIA MANUEL. Datosregistrales. T 1260 , F 224, S 8, H CA 15612, I/A 11 ( 9.11.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: VIDAL MESA FERNANDO;ALVAREZ NICOLAS MARIA TERESA. Datos registrales. T 1260 , F225, S 8, H CA 15612, I/A 12 ( 9.11.17).

20 de Julio de 2017
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 1260 , F 222, S 8, H CA 15612, I/A 8 (13.07.17).

30 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: MUNUERA GARCIA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 1260 , F 221, S 8, H CA 15612, I/A 7(22.11.16).

19 de Julio de 2016
Nombramientos. Apoderado: DE LA PIEDAD AMONDARAIN AMAIA. Datos registrales. T 1260 , F 221, S 8, H CA 15612, I/A 6(11.07.16).

26 de Septiembre de 2013
Declaración de unipersonalidad. Socio único: DE LA PIEDAD MENDIA IGNACIO JESUS. Datos registrales. T 1260 , F 221, S 8,H CA 15612, I/A 5 (16.09.13).

10 de Febrero de 2010
Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL GIBRALTAR C/ DE LA PERDIZ Nº 29 (LINEA DE LA CONCEPCION (LA). Datosregistrales. T 1260 , F 220, S 8, H CA 15612, I/A 4 (27.01.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información