Actos BORME de Iberdrola Sociedad Anonima
14 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ HERRERO ISABEL PATRICIA;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;MARIN RODENASJORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 6053 , F 139, S 8, H BI 167,A , I/ 2549 .( 5.12.23).
03 de Octubre de 2023Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la BOLSA DE VALORES DE MADRID las 110.278.000 acciones emitidas en laampliaci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 2542. Datos registrales. T 6053 , F 139, S 8, H BI 167,A , I/ 2547 .(22.09.23).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la BOLSA DE VALORES DE VALENCIA las 110.278.000 acciones emitidas en laampliaci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 2542. Datos registrales. T 6053 , F 139, S 8, H BI 167,A , I/ 2548 .(22.09.23).
26 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apoderado: ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL;DE ELEJOSTE ECHEBARRIA AINARA;MARTINEZ GARRIDOSANTIAGO MATIAS;CODES CALATRAVA GERARDO;DE ELEJOSTE ECHEBARRIA AINARA;LEGARRETA-ECHEVARRIALARRAZABAL I脩ESE;MARTINEZ PEREZ JESUS;DE LA FUENTE LECANDA MARIA;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;REAL DEASUA GUINEA IGNACIO;REBOLLO MIGUEL MARIA;OCHOA GIL JUAN PEDRO;EDESA VERDE VANESSA;DE LA SOTA ORTUZARKOSTKA;GUTIERREZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER;ORMAECHEA MERINO I脩IGO;LOPEZ ARANGUREN GORDILLOJUAN BOSCO;GOENAGA ANDONEGUI IKER;INSUNZA GAMINDE PABLO;AGUIRRE UZQUIANO GREGORIO;ALONSO ARANAJON;GARCIA PEREA JUNCAL;BURGUERA PEREZ IVAN;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;FERNANDEZ BEASCOECHEAJOSE MIGUEL;OMAECHEVARRIA LEGARRA JOSE ANGEL;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;PASTOR ZUAZAGA JAVIERJULIO;ALCAIN LOPEZ DANIEL;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;DE ELEJOSTE ECHEVARRIA AINARA;ARRIETAGARRAMIOLA MIGUEL;ZABALZA ESTEVEZ AMAYA. Datos registrales. T 6053 , F 139, S 8, H BI 167,A , I/ 2546 .(14.09.23).
28 de Agosto de 2023Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la BOLSA DE VALORES DE BARCELONA 110.278.000 acciones emitidas en laampliaci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 2542. Datos registrales. T 6053 , F 139, S 8, H BI 167,A , I/ 2545 .(18.08.23).
24 de Agosto de 2023Otros conceptos: Excluidas de la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Madrid 206.364.000 acciones de 0,75 euros de valornominal de cada una. Datos registrales. T 6053 , F 138, S 8, H BI 167,A , I/ 2543 .( 7.08.23).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la BOLSA DE VALORES DE BILBAO 110.278.000 acciones emitidas en la ampliaci贸nde capital que motiv贸 la inscripci贸n 2542. Datos registrales. T 6053 , F 139, S 8, H BI 167,A , I/ 2544 .( 7.08.23).
03 de Agosto de 2023Otros conceptos: Exclu铆das de la negociaci贸n en la bolsa de Valores de Barcelona, 206.364.000 acciones de 0,75 euros de valornominal cada una. Datos registrales. T 6053 , F 137, S 8, H BI 167,A , I/ 2541 .(21.07.23).
27 de Julio de 2023Otros conceptos: Exclu铆das de la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao, de 206.364.000 acciones, de 0,75 Euros de valornominal cada una. Datos registrales. T 6053 , F 137, S 8, H BI 167,A , I/ 2539 .(19.07.23).
Otros conceptos: Exclu铆das de la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia, 206.364.000 acciones de 0,75 euros de valornominal cada una. Datos registrales. T 6053 , F 137, S 8, H BI 167,A , I/ 2540 .(20.07.23).
18 de Julio de 2023Otros conceptos: Acuerdo de ampliaci贸n de capital sin ejecuci贸n de conformidad con el art. 508 de la Ley de Sociedades de Capital.Datos registrales. T 6053 , F 133, S 8, H BI 167,A , I/ 2538 .(10.07.23).
19 de Junio de 2023Nombramientos. Apoderado: AYALA DE LA TORRE JOSE MARIA. Datos registrales. T 6053 , F 122, S 8, H BI 167,A , I/ 2532 .(7.06.23).
Revocaciones. Apoderado: CANALES ABAITUA ASIS;SAN SEBASTIAN HECHT CRISTINA;BENITO DE VALLE VILLALBAAFRICA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 6053 , F 122, S 8, H BI 167,A , I/2531 .( 7.06.23).
02 de Junio de 2023Nombramientos. Apoderado: SAN SEBASTIAN HECHT CRISTINA;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;LOPEZ ROMERO-AVILAENRIQUE JOSE;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR;SANCHEZ-GALAN GARCIA-TABERNEROJOSE IGNACIO. Datos registrales. T 6053 , F 121, S 8, H BI 167,A , I/ 2530 .(25.05.23).
19 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: ZAMARRON CASSINELLO IGNACIO. Datos registrales. T 6053 , F 106, S 8, H BI 167,A , I/ 2523 .(3.05.23).
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del Pre谩mbulo, del ep铆grafe del T铆tulo Preliminar y de los art铆culos 4, 32 y 8 de losEstatutos, y nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 6053 , F 107, S 8, H BI 167,A , I/ 2524 .( 3.05.23).
Nombramientos. Cons.Ejecuti: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO. Reelecciones. Consejero: DE LA RICA GOIRICELAYASARA;MOREU MUNAIZ MANUEL;SAGREDO ORMAZA XABIER;ANTOLIN RAYBAUD MARIA HELENA;MARTINEZ MARTINEZARMANDO. Otros conceptos: Establecer en 14 el n煤mero de miembros del consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 6053 ,F 118, S 8, H BI 167,A , I/ 2525 .( 3.05.23).
Reelecciones. Con.Delegado: MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO. Datos registrales. T 6053 , F 118, S 8, H BI 167,A , I/ 2526 .(4.05.23).
Reelecciones. Miem.Com.Ej.: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO;MOREU MUNAIZ MANUEL. Pres.Com.Ej.: SANCHEZ GALANJOSE IGNACIO. Miem.Com.Ej.: MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO. Datos registrales. T 6053 , F 119, S 8, H BI 167,A , I/ 2527 .(4.05.23).
Nombramientos. PresEjecutiv: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO. Otros conceptos: Delegaci贸n de facultades a favor delPresidente Ejecutivo Don Jos茅 Ignacio Sanchez Gal谩n. Datos registrales. T 6053 , F 120, S 8, H BI 167,A , I/ 2529 .(10.05.23).
17 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ FRANCO JOSE ANGEL. Datos registrales. T 6053 , F 119, S 8, H BI 167,A , I/ 2528 .(5.05.23).
11 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: ZAMARRON CASSINELLO IGNACIO. Datos registrales. T 6053 , F 106, S 8, H BI 167,A , I/ 2523 .(3.05.23).
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del Pre谩mbulo, del ep铆grafe del T铆tulo Preliminar y de los art铆culos 4, 32 y 8 de losEstatutos, y nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 6053 , F 107, S 8, H BI 167,A , I/ 2524 .( 3.05.23).
10 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: CODES CALATRAVA GERARDO;SOBRINO MARTINEZ FELIX;ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL;DEELEJOSTE ECHEBARRIA AINARA;LEGARRETA-ECHEVARRIA LARRAZABAL I脩ESE;HERNANDEZ ELORDUY ALEJANDRO.Datos registrales. T 6053 , F 106, S 8, H BI 167,A , I/ 2522 .( 2.05.23).
27 de Abril de 2023Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao 84.270.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n de capitalque motiv贸 la inscripci贸n 2513陋. Datos registrales. T 6053 , F 105, S 8, H BI 167,A , I/ 2521 .(17.04.23).
24 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: CODES CALATRAVA GERARDO;SOBRINO MARTINEZ FELIX;BENITO DE VALLE VILLALBAAFRICA;LOPEZ ROMERO-AVILA ENRIQUE JOSE. Datos registrales. T 6053 , F 102, S 8, H BI 167,A , I/ 2519 .(16.03.23).
Otros conceptos: Modificaci贸n de los Art铆culos 13潞, 24潞 y 34潞 del Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T6053 , F 103, S 8, H BI 167,A , I/ 2520 .(16.03.23).
07 de Marzo de 2023Nombramientos. Apoderado: CODES CALATRAVA GERARDO;SOBRINO MARTINEZ FELIX;ALCAIN LOPEZ DANIEL;BENITO DEVALLE VILLALBA AFRICA;LOPEZ ROMERO-AVILA ENRIQUE JOSE. Datos registrales. T 6053 , F 99, S 8, H BI 167,A , I/ 2517.(27.02.23).
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ RODRIGUEZ LUIS MARIA. Datos registrales. T 6053 , F 102, S 8, H BI 167,A , I/ 2518.(27.02.23).
28 de Febrero de 2023Otros conceptos: ADMITIDAS A NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA 84.270.000 ACCIONES EMITIDASEN LA AMPLIACION DE CAPITAL QUE MOTIVO LA INSCRIPCION 2513. Datos registrales. T 6053 , F 99, S 8, H BI 167,A , I/ 2516.(17.02.23).
24 de Febrero de 2023Otros conceptos: ADMITIDAS A NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA 84.270.000 ACCIONES EMITIDASEN LA AMPLIACION DE CAPITAL QUE MOTIVO LA INSCRIPCION 2513. Datos registrales. T 6053 , F 99, S 8, H BI 167,A , I/ 2514
Otros conceptos: ADMITIDAS A NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE MADRID 84.270.000 ACCIONES EMITIDAS ENLA AMPLIACION DE CAPITAL QUE MOTIVO LA INSCRIPCION 2513. Datos registrales. T 6053 , F 99, S 8, H BI 167,A , I/ 2515.(15.02.23).
09 de Febrero de 2023Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 63.202.500,00 Euros. Desembolsado: 63.202.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.834.773.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.834.773.000,00 Euros. Datos registrales. T 6053 , F 97, S 8, H BI 167,A , I/ 2513 .( 1.02.23).
02 de Febrero de 2023Nombramientos. Apoderado: MERCHAN GONZALEZ SERGIO;MORENO HERRERO MARTA JOSEFA;ALCAIN LOPEZDANIEL;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;LOPEZ ROMERO-AVILA ENRIQUE JOSE;MARIN RODENAS JORGEMANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 6053 , F 94, S 8, H BI 167,A , I/ 2510 .(23.01.23).
Revocaciones. Apoderado: CANALES ABAITUA IGNACIO;MERCHAN GONZALEZ SERGIO;ALCAIN LOPEZ DANIEL;BENITO DEVALLE VILLALBA AFRICA;LOPEZ ROMERO-AVILA ENRIQUE JOSE;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYAITZIAR. Datos registrales. T 6053 , F 95, S 8, H BI 167,A , I/ 2511 .(25.01.23).
Nombramientos. Apoderado: FERGUSON PAUL;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;LOPEZ ROMERO-AVILA ENRIQUEJOSE;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 6053 , F 96, S 8, H BI 167,A , I/ 2512 .(25.01.23).
30 de Enero de 2023Nombramientos. Apoderado: CODES CALATRAVA GERARDO;SOBRINO MARTINEZ FELIX;ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL;DEELEJOSTE ECHEBARRIA AINARA;LEGARRETA-ECHEVARRIA LARRAZABAL I脩ESE;HERNANDEZ ELORDUY ALEJANDRO.Datos registrales. T 6053 , F 93, S 8, H BI 167,A , I/ 2508 .(19.01.23).
Revocaciones. Apoderado: MARRA RODRIGUEZ JOSE ANGEL;UGARRIZA CAPDEVILLA ARMANDO JOSE;MARRA RODRIGUEZJOSE ANGEL;UGARRIZA CAPDEVILA ARMANDO JOSE;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;MARIN RODENAS JORGEMANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR;MARRA RODRIGUEZ JOSE ANGEL. Datos registrales. T 6053 , F 94, S 8, H BI 167,A , I/2509 .(19.01.23).
19 de Enero de 2023Otros conceptos: Acuerdo de ampliaci贸n de capital sin ejecuci贸n de conformidad con el art铆culo 508 de la Ley de Sociedades deCapital. Datos registrales. T 6053 , F 88, S 8, H BI 167,A , I/ 2507 .(12.01.23).
09 de Enero de 2023Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 7, 8, 10, 13, 34 y 39 del Reglamento del Consejo de Administraci贸n . Datosregistrales. T 6053 , F 85, S 8, H BI 167,A , I/ 2506 .(29.12.22).
05 de Enero de 2023Nombramientos. Apoderado: GORDILLO LUQUE JOSE MIGUEL;ALCAIN LOPEZ DANIEL;BENITO DE VALLE VILLALBAAFRICA;LOPEZ ROMERO-AVILA ENRIQUE JOSE;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR Datosregistrales. T 6053 , F 79, S 8, H BI 167,A , I/ 2501 .(28.12.22).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA GALAN ROBERTO;MARTIN SEGURADO ESTRELLA;UGARRIZA CAPDEVILA ARMANDOJOSE;ALCAIN LOPEZ DANIEL;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;LOPEZ ROMERO-AVILA ENRIQUE JOSE;MARIN RODENASJORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 6053 , F 81, S 8, H BI 167,A , I/ 2502 .(28.12.22).
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN;MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN.Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO MATIAS. Datos registrales. T 6053 , F 84, S 8, H BI 167,A , I/ 2503.(28.12.22).
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN. Datos registrales. T 6053 , F 84, S 8, H BI 167,A , I/ 2504.(28.12.22).
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN. Secretario: MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZJULIAN. VsecrNoConsj: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO. Vsecr2.NC: DE ELEJOSTE ECHEVARRIA AINARA. Nombramientos.SecreNoConsj: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO MATIAS. Sec.Com.Del: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO MATIAS.VsecrNoConsj: DE ELEJOSTE ECHEBARRIA AINARA. Datos registrales. T 6053 , F 84, S 8, H BI 167,A , I/ 2505 .(28.12.22).
21 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: MILLA GONZALEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 6053 , F 79, S 8, H BI 167,A , I/ 2500 .(2.12.22).
28 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: CANALES ABAITUA ASIS;SANCHEZ-GALAN GARCIA-TABERNERO JOSE IGNACIO;ZAMARRONCASSINELLO IGNACIO;ZUMARRAGA GOROSTIZA RAMON;LOMBIDE PALACIOS AITOR;ALCAIN LOPEZ DANIEL;BENITO DEVALLE VILLALBA AFRICA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR;CODES CALATRAVAGERARDO;SOBRINO MARTINEZ FELIX;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;GALLARDO CORRALES MIGUEL;RUIPEREZCASSINELLO CESAR;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYAITZIAR;MESONERO MOLINA DAVID JOSE;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERASMONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 6053 , F 71, S 8, H BI 167,A , I/ 2492 .(17.10.22).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ALBENDEA ROBERTO JULIO;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;LOPEZROMERO-AVILA ENRIQUE JOSE;ARBERAS MONTOYA ITZIAR;MARIN RODENAS JORGE MANUEL. Datos registrales. T 6053 , F71, S 8, H BI 167,A , I/ 2493 .(17.10.22).
Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ MONTECINO RUTH. Datos registrales. T 6053 , F 72, S 8, H BI 167,A , I/ 2494.(17.10.22).
11 de Octubre de 2022Nombramientos. Apoderado: CODES CALATRAVA GERARDO;SOBRINO MARTINEZ FELIX;BENITO DE VALLE VILLALBAAFRICA;LOPEZ ROMERO-AVILA ENRIQUE JOSE. Datos registrales. T 6053 , F 65, S 8, H BI 167,A , I/ 2489 .( 3.10.22).
Nombramientos. Apoderado: MESONERO MOLINA DAVID JOSE;GALLARDO CORRALES MIGUEL;RUIPEREZ CASSINELLOCESAR;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;LOPEZ ROMERO-AVILA ENRIQUE JOSE;MARIN RODENAS JORGEMANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 6053 , F 67, S 8, H BI 167,A , I/ 2490 .( 3.10.22).
Nombramientos. Apoderado: CANALES ABAITUA ASIS;SANCHEZ-GALAN GARCIA-TABERNERO JOSE IGNACIO;ZAMARRONCASSINELLO IGNACIO;ZUMARRAGA GOROSTIZA RAMON;LOMBIDE PALACIOS AITOR;ALCAIN LOPEZ DANIEL;BENITO DEVALLE VILLALBA AFRICA;LOPEZ ROMERO-AVILA ENRIQUE JOSE;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYAITZIAR. Datos registrales. T 6053 , F 70, S 8, H BI 167,A , I/ 2491 .( 3.10.22).
Revocaciones. Apoderado: FIGUEROA BAHILLO JOSE ANGEL;GALAN LECUBARRI GLADYS;GALAN LECUBARRIGLADYS;GALAN LECUBARRI GLADYS;GALAN LECUBARRI GLADYS;GALAN LECUBARRI GLADYS;FERNANDEZ GUERRACARLOS LUIS;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;GALAN LECUBARRI GLADYS;MARIN RODENAS JORGEMANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR;GALAN LECUBARRI GLADYS;GALAN LECUBARRI GLADYS;GALAN LECUBARRIGLADYS;GALAN LECUBARRI GLADYS;GALAN LECUBARRI GLADYS;GALAN LECUBARRI GLADYS;GALAN LECUBARRIGLADYS;GALAN LECUBARRI GLADYS;GALAN LECUBARRI GLADYS;GALAN LECUBARRI GLADYS;GALAN LECUBARRIGLADYS;GALAN LECUBARRI GLADYS. Datos registrales. T 6053 , F 65, S 8, H BI 167,A , I/ 2488 .( 3.10.22).
22 de Septiembre de 2022Otros conceptos: ADMITIDAS A NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA 122.094.000 acciones emitidas en laampliaci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 2481. Datos registrales. T 6053 , F 64, S 8, H BI 167,A , I/ 2486 .(12.09.22).
Otros conceptos: ADMITIDAS A NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE MADRID 122.094.000 acciones emitidas en laampliaci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 2481. Datos registrales. T 6053 , F 65, S 8, H BI 167,A , I/ 2487 .(14.09.22).
19 de Agosto de 2022Otros conceptos: DADAS DE BAJA CON EFECTOS 08/07/2022 197.563.000 ACCIONES CODIGO ISIN ES0144580Y14 EN LABOLSA DE VALENCIA. Datos registrales. T 6053 , F 64, S 8, H BI 167,A , I/ 2483 .(11.08.22).
Otros conceptos: ADMITIDAS A NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO 122.094.000 ACCIONES EMITIDAS ENLA AMPLIACION DE CAPITAL QUE MOTIVO LA INSCRIPCION 2481. Datos registrales. T 6053 , F 64, S 8, H BI 167,A , I/ 2484.(11.08.22).
Otros conceptos: ADMITIDAS A NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA 122.094.000 ACCIONESEMITIDAS EN LA AMPLIACION DE CAPITAL QUE MOTIVO LA INSCRIPCION 2481. Datos registrales. T 6053 , F 64, S 8, H BI167,A , I/ 2485 .(11.08.22).
11 de Agosto de 2022Otros conceptos: DADAS DE BAJA CON EFECTOS 08/07/2022 197.563.000 ACCIONES CODIGO ISIN ESO144580Y14 EN LABOLSA DE MADRID. Datos registrales. T 6053 , F 64, S 8, H BI 167,A , I/ 2482 .( 2.08.22).
09 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;CAVERO DOMINGUEZ JUAN PABLO;DE ANTA RUBIATOGONZALO;AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER. Datos registrales. T 6053 , F 59, S 8, H BI167,A , I/ 2478 .(28.07.22).
Nombramientos. Apoderado: PARDO DE SANTAYANA MONTES JUAN GASPAR. Datos registrales. T 6053 , F 60, S 8, H BI167,A , I/ 2479 .(28.07.22).
Modificaciones estatutarias. Modificado el Art铆culo 32 del Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 6053 , F61, S 8, H BI 167,A , I/ 2480 .(28.07.22).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 91.570.500,00 Euros. Desembolsado: 91.570.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.771.570.500,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.771.570.500,00 Euros. Datos registrales. T 6053 , F 62, S 8, H BI 167,A , I/ 2481 .( 2.08.22).
04 de Agosto de 2022Otros conceptos: DADAS DE BAJA CON EFECTOS 08/07/2022 197.563.000 ACCIONES CODIGO ISIN ES0144580Y14 EN LABOLSA DE BARCELONA. Datos registrales. T 6053 , F 59, S 8, H BI 167,A , I/ 2477 .(22.07.22).
27 de Julio de 2022Otros conceptos: DADAS DE BAJA CON EFECTOS 08/07/2022 197.563.000 ACCIONES CODIGO ISIN ES0144580Y14 EN LABOLSA DE BILBAO. Datos registrales. T 6053 , F 59, S 8, H BI 167,A , I/ 2476 .(19.07.22).
19 de Julio de 2022Otros conceptos: Acuerdo de ampliaci贸n de capital sin ejecuci贸n de conformidad con el art. 508 de la Ley de Sociedades de Capital.Datos registrales. T 6053 , F 54, S 8, H BI 167,A , I/ 2475 .(12.07.22).
14 de Julio de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 148.172.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.680.000.000,00 Euros. Datos registrales. T6053 , F 48, S 8, H BI 167,A , I/ 2471 .( 6.07.22).
Revocaciones. Apoderado: ELORRIAGA FERNANDEZ DE ARROYABE I脩IGO. Datos registrales. T 6053 , F 48, S 8, H BI 167,A , I/2472 .( 7.07.22).
Nombramientos. Apoderado: ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;DOMINGUEZ CAVERO JUAN PABLO;DE ANTA RUBIATOGONZALO. Datos registrales. T 6053 , F 51, S 8, H BI 167,A , I/ 2473 .( 7.07.22).
Nombramientos. Apoderado: MESONERO MOLINA DAVID JOSE;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;GALAN LECUBARRIGLADYS;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 6053 , F 52, S 8, H BI 167,A , I/2474 .( 7.07.22).
04 de Julio de 2022Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n y refundici贸n de los estatutos sociales. Datos registrales. T 6053 , F 21, S 8, H BI 167,A ,I/ 2466 .(23.06.22).
Otros conceptos: Modificaci贸n y nueva redacci贸n del Reglamento de la Junta General de Accionistas Datos registrales. T 6053 , F33, S 8, H BI 167,A , I/ 2467 .(23.06.22).
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 6053 , F 33, S 8, H BI 167,A , I/ 2468 .(24.06.22).
Reelecciones. Consejero: GARDNER ANTHONY LUZZATTO;ALCALA DIAZ MARIA ANGELES;GARCIA TEJERINA ISABEL. Otrosconceptos: Determinar el n煤mero de miembros del Consejo de Administraci贸n en catorce. Datos registrales. T 6053 , F 47, S 8, HBI 167,A , I/ 2469 .(24.06.22).
Reelecciones. Miem.Com.Ej.: GARDNER ANTHONY LUZZATTO. Datos registrales. T 6053 , F 48, S 8, H BI 167,A , I/ 2470.(24.06.22).
16 de Junio de 2022Revocaciones. Apoderado: SAINZ ARMADA JOSE;MARURI HERNAEZ I脩AKI;DE LA FUENTE GARCIA IGNACIO;GALANLECUBARRI GLADYS;URQUIDI GARCIA JAVIER. Datos registrales. T 6053 , F 21, S 8, H BI 167,A , I/ 2465 .( 8.06.22).
26 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: SAINZ ARMADA JOSE. Datos registrales. T 6053 , F 20, S 8, H BI 167,A , I/ 2464 .(19.05.22).
23 de Mayo de 2022Otros conceptos: Modificaci贸n del Art铆culo 13潞 del Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 6053 , F 19, S8, H BI 167,A , I/ 2463 .(12.05.22).
12 de Mayo de 2022Otros conceptos: Modificaci贸n del art铆culo 32潞 del Reglamento del Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 6053 , F 18, S 8,H BI 167,A , I/ 2462 .( 5.05.22).
28 de Abril de 2022Revocaciones. Apoderado: MOSO RAIGOSO AITOR;RELA脩O COBIAN GREGORIO;RAPUN JIMENEZ JOSE LUIS;MOLINANU脩EZ-LAGOS JOSE MARIA;MARTIN GOMEZ SANTIAGO;MORENO HERRERO MARTA. Datos registrales. T 6053 , F 18, S 8, HBI 167,A , I/ 2461 .(21.04.22).
31 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: RELA脩O COBIAN GREGORIO;FERNANDEZ DE PRADA ALFIN MARGARITA ANDREA;ZARAGOZADORR ISABEL;MARTINEZ PEREZ JESUS;URQUIDI GARCIA JAVIER;OCHOA GIL JUAN PEDRO;EDESA VERDE VANESSA;DE LASOTA ORTUZAR KOSTKA;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;GUTIERREZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER;DE LA FUENTELECANDA MARIA;ORMAECHEA MERINO I脩IGO;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;LOPEZ-ARANGUREN GORDILLOBOSCO;REBOLLO MIGUEL MARIA;INSUNZA GAMINDE PABLO;AGUIRRE UZQUIANO GREGORIO;ALONSO ARANA JON;GARCIAPEREA JUNCAL;BURGUERA PEREZ IVAN;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;FERNANDEZ BEASCOECHEA JOSEMIGUEL;OMAECHEVARRIA LEGARRA JOSE ANGEL;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;PASTOR ZUAZAGA JAVIERJULIO;ALCAIN LOPEZ DANIEL;MORENO HERRERO MARTA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GIMENEZTAMAYO ELENA;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GIMENEZ TAMAYOELENA;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GIMENEZTAMAYO ELENA;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GIMENEZ TAMAYOELENA;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GIMENEZ TAMAYO ELENA;CAMARA BELLO ESTER CELINA.Datos registrales. T 6053 , F 17, S 8, H BI 167,A , I/ 2460 .(21.03.22).
03 de Marzo de 2022Otros conceptos: Modificaci贸n del Art铆culo 34 del Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 6053 , F 11, S 8,H BI 167,A , I/ 2457 .(24.02.22).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PEREZ JESUS;DE LA FUENTE LECANDA MARIA;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;REALDE ASUA GUINEA IGNACIO;REBOLLO MIGUEL MARIA;OCHOA GIL JUAN PEDRO;EDESA VERDE VANESSA;DE LA SOTAORTUZAR KOSTKA;GUTIERREZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER;ORMAECHEA MERINO I脩IGO;LOPEZ ARANGURENGORDILLO JUAN BOSCO;GOENAGA ANDONEGUI IKER;INSUNZA GAMINDE PABLO;AGUIRRE UZQUIANO GREGORIO;ALONSOARANA JON;GARCIA PEREA JUNCAL;BURGUERA PEREZ IVAN;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;FERNANDEZBEASCOECHEA JOSE MIGUEL;OMAECHEVARRIA LEGARRA JOSE ANGEL;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;PASTORZUAZAGA JAVIER JULIO;ALCAIN LOPEZ DANIEL;MORENO HERRERO MARTA;GALAN LECUBARRI GLADYS;BENITO DE VALLEVILLALBA AFRICA. Datos registrales. T 6053 , F 13, S 8, H BI 167,A , I/ 2458 .(24.02.22).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN;DE ELEJOSTE ECHEVARRIA AINARA;ARRIETAGARRAMIOLA MIGUEL;ZABALZA ESTEVEZ AMAYA. Datos registrales. T 6053 , F 16, S 8, H BI 167,A , I/ 2459 .(24.02.22).
28 de Febrero de 2022Otros conceptos: Admisi贸n a negociaci贸n en la Bolsa de Bilbao de 71.475.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n de capital quemotiv贸 la inscripci贸n 2452. Datos registrales. T 6053 , F 11, S 8, H BI 167,A , I/ 2456 .(18.02.22).
22 de Febrero de 2022Otros conceptos: Admisi贸n a negociaci贸n en la Bolsa de Valencia de 71.475.000 acciones de 0,75 euros de valor nominal emitidasen la ampliaci贸n de capital social que motiv贸 la inscripci贸n 2452陋. Datos registrales. T 6053 , F 11, S 8, H BI 167,A , I/ 2453.(14.02.22).
Otros conceptos: Admisi贸n a negociaci贸n en la Bolsa de Madrid de 71.475.000 acciones de 0,75 euros de valor nominal emitidas enla ampliaci贸n de capital social que motiv贸 la inscripci贸n 2452陋. Datos registrales. T 6053 , F 11, S 8, H BI 167,A , I/ 2454 .(14.02.22).
Otros conceptos: Admisi贸n a negociaci贸n en la Bolsa de Barcelona de 71.475.000 acciones de 0,75 euros de valor nominal emitidasen la ampliaci贸n de capital social que motiv贸 la inscripci贸n 2452陋. Datos registrales. T 6053 , F 11, S 8, H BI 167,A , I/ 2455.(14.02.22).
10 de Febrero de 2022Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 53.606.250,00 Euros. Desembolsado: 53.606.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.828.172.250,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.828.172.250,00 Euros. Datos registrales. T 6053 , F 11, S 8, H BI 167,A , I/ 2452 .( 3.02.22).
20 de Enero de 2022Otros conceptos: Acuerdo de ampliaci贸n de capital sin ejecuci贸n de conformidad con el art. 508 de la Ley de Sociedades de Capital.Datos registrales. T 6053 , F 6, S 8, H BI 167,A , I/ 2451 .(13.01.22).
03 de Enero de 2022Otros conceptos: Modificaci贸n del Art铆culo 34 del Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 6053 , F 3, S 8,H BI 167,A , I/ 2448 .(22.12.21).
Nombramientos. Consejero: GARCIA TEJERINA ISABEL. Datos registrales. T 6053 , F 4, S 8, H BI 167,A , I/ 2449 .(22.12.21).
Nombramientos. Apoderado: CRISOSTOMO MERINO BEATRIZ MARIA;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;GALANLECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datosregistrales. T 6053 , F 4, S 8, H BI 167,A , I/ 2450 .(22.12.21).
29 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ CORCOLES FRANCISCO;LEON MU脩OZ ELENA;BENITO DE VALLE VILLALBAAFRICA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYAITZIAR;SAN JUAN MERINERO SUSANA;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYOELENA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 5814 , F 225, S 8, H BI 167,A , I/2446 .(19.11.21).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO. Datos registrales. T 6053 , F 1, S 8, H BI 167,A , I/ 2447.(19.11.21).
11 de Noviembre de 2021Nombramientos. Consejero: ALCALA DIAZ MARIA ANGELES. Datos registrales. T 5814 , F 224, S 8, H BI 167,A , I/ 2443.(29.10.21).
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GONZALEZ SERNA JUAN MANUEL. Nombramientos. Vicepr.1: GONZALEZ SERNA JUANMANUEL. Vicepr.2: GARDNER ANTHONY LUZZATTO. Datos registrales. T 5814 , F 224, S 8, H BI 167,A , I/ 2444 .(29.10.21).
Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: BARBER SAMANTHA. Consejero: BARBER SAMANTHA. Nombramientos. Miem.Com.Ej.:GARDNER ANTHONY LUZZATTO. Otros conceptos: Se fija el n煤mero de miembros de la Comisi贸n Ejecutiva Delegada en cinco.Datos registrales. T 5814 , F 225, S 8, H BI 167,A , I/ 2445 .(29.10.21).
08 de Octubre de 2021Revocaciones. Apoderado: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;RUIPEREZ CASSINELLO CESAR;BENITO DE VALLE VILLALBAAFRICA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYAITZIAR. Datos registrales. T 5814 , F 222, S 8, H BI 167,A , I/ 2441 .(30.09.21).
Nombramientos. Apoderado: QUEVEDO CHAPERO ANGELA. Datos registrales. T 5814 , F 222, S 8, H BI 167,A , I/ 2442.(30.09.21).
29 de Septiembre de 2021Otros conceptos: Admisi贸n a negociaci贸n en la Bolsa de Barcelona de 1260.88.000 acciones de 0,75 euros de valor nominalemitidas en la ampliaci贸n de capital social que motiv贸 la inscripci贸n 2431潞. Datos registrales. T 5814 , F 222, S 8, H BI 167,A , I/ 2440.(16.09.21).
21 de Septiembre de 2021Otros conceptos: Dadas de baja las 178.156.000 acciones amortizadas en la inscripci贸n 2426潞 en la Bolsa de Madrid. Datosregistrales. T 5814 , F 219, S 8, H BI 167,A , I/ 2436 .( 9.09.21).
Otros conceptos: Admisi贸n a negociaci贸n en la Bolsa de Madrid de 126.088.000 acciones de 0,75 euros de valor nominal emitidasen la ampliaci贸n de capital social que motiv贸 la inscripci贸n 2431潞. Datos registrales. T 5814 , F 219, S 8, H BI 167,A , I/ 2437 .(9.09.21).
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE MORENO MARIA TERESA;MESONERO MOLINA DAVID JOSE. Datosregistrales. T 5814 , F 220, S 8, H BI 167,A , I/ 2438 .( 9.09.21).
Nombramientos. Apoderado: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;GALLARDO CORRALES MIGUEL;RUIPEREZ CASSINELLOCESAR;BENITO DE VALLE VILLABA AFRICA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGEMANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 5814 , F 220, S 8, H BI 167,A , I/ 2439 .( 9.09.21).
15 de Septiembre de 2021Otros conceptos: Admisi贸n a negociaci贸n en la Bolsa de Valencia de 1260.88.000 acciones de 0,75 euros de valor nominal emitidasen la ampliaci贸n de capital social que motiv贸 la inscripci贸n 2431潞. Datos registrales. T 5814 , F 219, S 8, H BI 167,A , I/ 2435 .(7.09.21).
13 de Septiembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: WALFREDO FERNANDEZ JOSE. Datos registrales. T 5814 , F 219, S 8, H BI 167,A , I/ 2434 .(3.09.21).
08 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apoderado: NOVILLO MARTIN ANA. Datos registrales. T 5814 , F 218, S 8, H BI 167,A , I/ 2433 .( 1.09.21).
17 de Agosto de 2021Otros conceptos: Admisi贸n a negociaci贸n en la Bolsa de Bilbao de 126.088.000 acciones de 0,75 euros de valor nominal cada unaemitidas en la ampliaci贸n de capital social que motiv贸 la inscripci贸n 2431潞- C贸digo ISIN 144583244. Datos registrales. T 5814 , F218, S 8, H BI 167,A , I/ 2432 .( 5.08.21).
05 de Agosto de 2021Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 94.566.000,00 Euros. Desembolsado: 94.566.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.774.566.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.774.566.000,00 Euros. Datos registrales. T 5814 , F 217, S 8, H BI 167,A , I/ 2431 .(30.07.21).
04 de Agosto de 2021Otros conceptos: DADAS DE BAJA CON EFECTOS AL 08/07/2021 178.156.000 ACCIONES CODIGO ISIN ESO144580Y14 EN LABOLSA DE BARCELONA. Datos registrales. T 5814 , F 217, S 8, H BI 167,A , I/ 2430 .(28.07.21).
28 de Julio de 2021Otros conceptos: DADAS DE BAJA CON EFECTOS 08/07/2021 178.156.000 ACCIONES CODIGO ISIN ESO144580Y14 EN LABOLSA DE BILBAO. Datos registrales. T 5814 , F 217, S 8, H BI 167,A , I/ 2429 .(15.07.21).
23 de Julio de 2021Otros conceptos: DADAS DE BAJA CON EFECTOS 08/07/2021 178.156.000 ACCIONES CODIGO ISIN ESO144580Y14 EN LABOLSA DE VALENCIA. Datos registrales. T 5814 , F 217, S 8, H BI 167,A , I/ 2428 .(15.07.21).
15 de Julio de 2021Otros conceptos: Acuerdo de ampliaci贸n de capital sin ejecuci贸n de conformidad con el art. 508 de la Ley de Sociedades de Capital.Datos registrales. T 5814 , F 212, S 8, H BI 167,A , I/ 2427 .( 9.07.21).
13 de Julio de 2021Nombramientos. Miem.Com.Ej.: GONZALEZ SERNA JUAN MANUEL;ACEBES PANIAGUA ANGEL JESUS. Reelecciones.Consej.Coord: GONZALEZ SERNA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 5814 , F 209, S 8, H BI 167,A , I/ 2425 .( 2.07.21).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 133.617.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.680.000.000,00 Euros. Datos registrales. T5814 , F 210, S 8, H BI 167,A , I/ 2426 .( 6.07.21).
02 de Julio de 2021Otros conceptos: Modificaci贸n y nueva redacci贸n de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 5814 , F 184, S 8, H BI 167,A , I/2422 .(24.06.21).
Otros conceptos: Modificaci贸n y nueva redacci贸n del Reglamento de la Junta. Datos registrales. T 5814 , F 195, S 8, H BI 167,A , I/2423 .(24.06.21).
Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: GONZALEZ SERNA JUAN MANUEL;ACEBES PANIAGUA ANGEL JESUS. Reelecciones.Consejero: GONZALEZ SERNA JUAN MANUEL;MARTINEZ CORCOLES FRANCISCO;ACEBES PANIAGUA ANGEL JESUS. Otrosconceptos: Se determina en catorce el n煤mero de miembros del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 5814 , F 209, S 8,H BI 167,A , I/ 2424 .(24.06.21).
01 de Julio de 2021Otros conceptos: Modificaci贸n de los art铆culos 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 55y 56. Datos registrales. T 5814 , F 177, S 8, H BI 167,A , I/ 2421 .(22.06.21).
23 de Junio de 2021Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ PEREZ JESUS;ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;CUENCA ARAMBARRI IGNACIO;DELVILLAR DURA ANA MARIA;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRIGLADYS;GARCIA- ROZADO GONZALEZ BEGO脩A;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;CODESCALATRAVA GERARDO;GARZON ORTEGA JUSTO;DURAN DOMINGUEZ JULIA;GALAN LECUBARRI GLADYS. Datosregistrales. T 5814 , F 176, S 8, H BI 167,A , I/ 2420 .(16.06.21).
09 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: MORAN LEON JOSE RAMON. Datos registrales. T 5814 , F 176, S 8, H BI 167,A , I/ 2419.(31.05.21).
03 de Junio de 2021Revocaciones. Apoderado: ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL;ELORRIAGA FERNANDEZ DE ARROYABE I脩IGO;SAITUA IRIBARMARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;ELORRIAGA FERNANDEZ DE ARROYABE I脩IGO;ARRIETAGARRAMIOLA MIGUEL. Datos registrales. T 5814 , F 172, S 8, H BI 167,A , I/ 2415 .(26.05.21).
Nombramientos. Apoderado: HERRERA PEREDA MARIA DOLORES;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;GALAN LECUBARRIGLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T5814 , F 173, S 8, H BI 167,A , I/ 2416 .(26.05.21).
Nombramientos. Apoderado: CUENCA ARAMBARRI IGNACIO;DEL VILLAR DURA ANA;ZU脩IGA BENAVIDES JUANJOSE;MARTINEZ PEREZ JESUS;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;URQUIDI GARCIA JAVIER;BENITO DE VALLE VILLALBAAFRICA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYAITZIAR. Datos registrales. T 5814 , F 173, S 8, H BI 167,A , I/ 2417 .(26.05.21).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA- ROZADO GONZALEZ BEGO脩A;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;GALANLECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datosregistrales. T 5814 , F 174, S 8, H BI 167,A , I/ 2418 .(26.05.21).
31 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: DELGADO MARTIN AGUSTIN;UGARRIZA CAPDEVILLA ARMANDO JOSE;CRISOSTOMO MERINOBEATRIZ MARIA;SAITUA IRIBAR MARTIN;GIMENEZ TAMAYO ELENA;SAN JUAN MERINERO SUSANA;SAITUA IRIBARMARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;SAITUA IRIBAR MARTIN;PUBLISI REIG SILVIA;BILBAO IBEASANA;SAITUA IRIBAR MARTIN;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRI GLADYS;CODES CALATRAVA GERARDO;SAITUAIRIBAR MARTIN;ROJO SEVILLANO FELIX;URIBE DIEZ JOAN;ORTEGA MARI脩O IGNACIO;SAITUA IRIBAR MARTIN;SAITUAIRIBAR MARTIN;LEON MU脩OZ ELENA;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;ELORZA MARTIN I脩IGO;CANALESABAITUA ASIS;SAN SEBASTIAN HECHT CRISTINA;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;ARBERAS MONTOYAITZIAR;AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;MESONERO MOLINA DAVID JOSE;RUIPEREZ CASSINELLO CESAR;ALCAIN
Nombramientos. Apoderado: ELORRIAGA FERNANDEZ DE ARROYABE I脩IGO;ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL;BENITO DEVALLE VILLALBA AFRICA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGEMANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 5814 , F 171, S 8, H BI 167,A , I/ 2414 .(18.05.21).
04 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: CANALES ABAITUA ASIS;SANCHEZ-GALAN GARCIA-TABERNERO JOSE IGNACIO;ZAMARRONCASSINELLO IGNACIO;ZUMARRAGA GOROSTIZA RAMON;LOMBIDE PALACIOS AITOR;ALCAIN LOPEZ DANIEL;BENITO DEVALLE VILLALBA AFRICA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGEMANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 5814 , F 159, S 8, H BI 167,A , I/ 2404 .(23.04.21).
Nombramientos. Apoderado: MARRA RODRIGUEZ JOSE ANGEL;UGARRIZA CAPDEVILA ARMANDO JOSE;BENITO DE VALLEVILLALBA AFRICA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERASMONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 5814 , F 161, S 8, H BI 167,A , I/ 2405 .(23.04.21).
Nombramientos. Apoderado: CODES CALATRAVA GERARDO;SOBRINO MARTINEZ FELIX;BENITO DE VALLE VILLALBAAFRICA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5814 , F 162, S 8, H BI 167,A , I/ 2406.(23.04.21).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GUERRA CARLOS LUIS;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;GALAN LECUBARRIGLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR;CAMARA BELLO ESTERCELINA. Datos registrales. T 5814 , F 163, S 8, H BI 167,A , I/ 2407 .(23.04.21).
Nombramientos. Apoderado: BILBAO IBEAS ANA;PUGLISI SILVIA;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;GALAN LECUBARRIGLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T5814 , F 165, S 8, H BI 167,A , I/ 2408 .(23.04.21).
Nombramientos. Apoderado: SAN JUAN MERINERO SUSANA;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;GALAN LECUBARRIGLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T5814 , F 165, S 8, H BI 167,A , I/ 2409 .(23.04.21).
Nombramientos. Apoderado: DELGADO MARTIN AGUSTIN;CRISOSTOMO MERINO BEATRIZ MARIA;BENITO DE VALLEVILLALBA AFRICA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERASMONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 5814 , F 166, S 8, H BI 167,A , I/ 2410 .(23.04.21).
Nombramientos. Apoderado: CANALES ABAITUA ASIS;SAN SEBASTIAN HECHT CRISTINA;BENITO DE VALLE VILLALBAAFRICA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYAITZIAR. Datos registrales. T 5814 , F 167, S 8, H BI 167,A , I/ 2411 .(23.04.21).
Nombramientos. Apoderado: MARRA RODRIGUEZ JOSE ANGEL;COLLADA BANDERAS ANTONIO;RODRIGUEZ ZARZALEJOSAMALIO;CANALES ABAITUA IGNACIO;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYOELENA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 5814 , F 168, S 8, H BI 167,A , I/2412 .(23.04.21).
22 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: ALCAIN LOPEZ DANIEL;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;MARIN RODENAS JORGEMANUEL;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;BURGUERA PEREZ IVAN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYOELENA;MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO MATIAS;CODES CALATRAVA GERARDO;SOBRINO MARTINEZ FELIX. Datosregistrales. T 5814 , F 153, S 8, H BI 167,A , I/ 2399 .(15.04.21).
Nombramientos. Apoderado: MOJAS RODRIGUEZ JAVIER. Datos registrales. T 5814 , F 155, S 8, H BI 167,A , I/ 2400 .(15.04.21).
Nombramientos. Apoderado: LEON MU脩OZ ELENA;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;GALAN LECUBARRIGLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T5814 , F 156, S 8, H BI 167,A , I/ 2401 .(15.04.21).
Nombramientos. Apoderado: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;MESONERO MOLINA DAVID JOSE;RUIPEREZ CASSINELLOCESAR;BENITO DE VALLE VILLALBA AFRICA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;MARIN RODENASJORGE MANUEL;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 5814 , F 157, S 8, H BI 167,A , I/ 2402 .(15.04.21).
Nombramientos. Apoderado: MARRA RODRIGUEZ JOSE ANGEL;UGARRIZA CAPDEVILLA ARMANDO JOSE. Datos registrales.T 5814 , F 159, S 8, H BI 167,A , I/ 2403 .(15.04.21).
05 de Abril de 2021Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la bolsa de Madrid, con efectos el 10 de febrero de 2021, las 68.095.000 accionesemitidas en la ampliaci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 2390陋, c贸digo ES0144583236. Datos registrales. T 5814 , F 153, S 8, H
25 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: LUCARINI SAN JOSE DANIEL;IPI脩A RUIZ DE AGUIRRE ESTIBALIZ. Datos registrales. T 5814 , F152, S 8, H BI 167,A , I/ 2396 .(16.03.21).
Revocaciones. Apoderado: ZOTES GARCIA ANA ARANZAZU. Datos registrales. T 5814 , F 153, S 8, H BI 167,A , I/ 2397.(16.03.21).
11 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: DE ELEJOSTE ECHEVARRIA AINARA;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;BURGUERA PEREZIVAN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5814 , F 150, S 8, H BI 167,A , I/ 2393 .(1.03.21).
Otros conceptos: Modificaci贸n del Art铆culo 29潞 del Reglamento del Consejo. Datos registrales. T 5814 , F 151, S 8, H BI 167,A , I/2394 .( 1.03.21).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valencia de 68.095.000 acciones de 0,75 euros de valor nominal emitidasen la inscripcion 2390潞. Datos registrales. T 5814 , F 152, S 8, H BI 167,A , I/ 2395 .( 4.03.21).
01 de Marzo de 2021Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la bolsa de Barcelona, con efectos al 10 de febrero de 2021, las 68.095000 accionesemitidas en la ampliaci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 2390陋, c贸digo ES0144583236. Datos registrales. T 5814 , F 150, S 8, HBI 167,A , I/ 2391 .(17.02.21).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao las 68.095.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2390陋, c贸digo ES0144583236. Datos registrales. T 5814 , F 150, S 8, H BI 167,A , I/ 2392.(17.02.21).
15 de Febrero de 2021Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 51.071.250,00 Euros. Desembolsado: 51.071.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.813.617.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.813.617.000,00 Euros. Datos registrales. T 5814 , F 145, S 8, H BI 167,A , I/ 2390 .( 5.02.21).
11 de Febrero de 2021Revocaciones. Apoderado: PEREZ SANZ ANGEL. Datos registrales. T 5814 , F 145, S 8, H BI 167,A , I/ 2389 .( 2.02.21).
29 de Diciembre de 2020Otros conceptos: Modificaci贸n y nueva redacci贸n del Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 5814 , F 136,S 8, H BI 167,A , I/ 2388 .(17.12.20).
10 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apoderado: TOLEDANO LANZA MANUEL;OCHOA GIL BEGO脩A. Datos registrales. T 5814 , F 135, S 8, H BI167,A , I/ 2386 .(27.11.20).
Nombramientos. Apoderado: SAN JUAN MERINERO SUSANA;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZTAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5814 , F 135, S 8, H BI 167,A , I/ 2387 .(27.11.20).
04 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: DE LA FUENTE GARCIA IGNACIO;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datosregistrales. T 5814 , F 130, S 8, H BI 167,A , I/ 2381 .(21.10.20).
Nombramientos. Apoderado: MARURI HERNAEZ I脩AKI. Datos registrales. T 5814 , F 132, S 8, H BI 167,A , I/ 2382 .(21.10.20).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ ANTON MANUEL. Datos registrales. T 5814 , F 133, S 8, H BI 167,A , I/ 2383.(21.10.20).
Revocaciones. Apoderado: ARRIOLA ALCIBAR ITZIAR;CASTRO RUIZ BEGO脩A;DE LA FUENTE LECANDA MARIA;DE LA SOTAORTUZAR KOSTKA;DIEZ REBANAL JORGE;EDESA VERDE VANESSA;GUTIERREZ CASTELLANOS FRANCISCOJAVIER;LEZANA VISUS LUIS JAVIER;LOPEZ SANZ MAIDER;MARTINEZ PEREZ JESUS;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;OCHOAGIL JUAN PEDRO;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;URQUIDI GARCIA JAVIER;ZUAZAGA SASTRE DAVID;HERRERO NAVASSANTIAGO;IZQUIERDO PUMAR MARTA;LOPEZ ARANGUREN GORDILLO JUAN BOSCO;REBOLLO MIGUEL MARIA;AGUIRREUZQUIANO GREGORIO;ALONSO ARANA JON;ARBERAS MONTOYA ITZIAR;ARETXALDE UGARTETXE AITOR;ARRIETA LOPEZAINHOA;BURGUERA PEREZ IVAN;DE PALACIO ALBIZU IDOIA;DIEZ ALUSTIZA ROBERTO;DORIA DE ELEJOSTEADRIANA;FERNANDEZ BEASCOECHEA JOSE MIGUEL;GARAIZAR ZORRILLA BORJA;GARCIA PEREA JUNCAL;GONZALEZIZAGUIRRE I脩IGO;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;IBA脩EZ RODELGO LAURA;INSUNZA GAMINDE PABLO;LETONALOPEZ ALBERTO JOSE;LLAMAZARES SALVADOR AINTZANE;LUCARINI SAN JOSE DANIEL;MARIN RODENAS JORGEMANUEL;MARTINEZ GUTIERREZ MIGUEL;OMAECHEVARRIA LEGARRA JOSE ANGEL;PASTOR ZUAZAGA JAVIERJULIO;ROTAECHE LACHIONDO MIKEL;SAITUA IRIBAR MARTIN;SALAZAR BLANCO JAVIER;SENDIN BOREA I脩IGO;SOLOZABALAPELLANIZ JOSE IGNACIO;TOBAR PARDO DE SANTAYANA ROCIO;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYOELENA;RODRIGUEZ FRADE ALFONSO MARIA;MARTINEZ PEREZ JESUS;URQUIDI GARCIA JAVIER;OCHOA GIL JUANPEDRO;EDESA VERDE VANESSA;DE LA SOTA ORTUZAR KOSTKA;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;GUTIERREZCASTELLANOS FRANCISCO JAVIER;DE LA FUENTE LECANDA MARIA;ORMAECHEA MERINO I脩IGO;MENJON ERIZMENDIALBERTO;LOPEZ-ARANGUREN GORDILLO BOSCO;REBOLLO MIGUEL MARIA;INSUNZA GAMINDE PABLO;AGUIRRE
Ceses/Dimisiones. Consejero: KESSEL MARTINEZ GEORGINA YAMILET. Nombramientos. Consejero: ACEBES PANIAGUAANGEL JESUS. M.Com.Ejec: ACEBES PANIAGUA ANGEL JESUS. Datos registrales. T 5814 , F 135, S 8, H BI 167,A , I/ 2385.(22.10.20).
22 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PEREZ JESUS;URQUIDI GARCIA JAVIER;OCHOA GIL JUAN PEDRO;EDESA VERDEVANESSA;DE LA SOTA ORTUZAR KOSTKA;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;GUTIERREZ CASTELLANOS FRANCISCOJAVIER;DE LA FUENTE LECANDA MARIA;ORMAECHEA MERINO I脩IGO;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;LOPEZ-ARANGURENGORDILLO BOSCO;REBOLLO MIGUEL MARIA;INSUNZA GAMINDE PABLO;AGUIRRE UZQUIANO GREGORIO;ALONSO ARANAJON;GARCIA PEREA JUNCAL;BURGUERA PEREZ IVAN;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;FERNANDEZ BEASCOECHEAJOSE MIGUEL;OMAECHEVARRIA LEGARRA JOSE ANGEL;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;PASTOR ZUAZAGA JAVIERJULIO;SAITUA IRIBAR MARTIN;ALCAIN LOPEZ DANIEL;MORENO HERRERO MARTA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZTAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5814 , F 125, S 8, H BI 167,A , I/ 2378 .(14.10.20).
Nombramientos. Apoderado: DELGADO MARTIN AGUSTIN;CRISOSTOMO MERINO BEATRIZ MARIA;SAITUA IRIBARMARTIN;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5814 , F 129, S 8, H BI 167,A , I/ 2379 .(14.10.20).
Revocaciones. Apoderado: MOSO RAIGOSO AITOR;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER. Apo.Man.Soli: SAINZ ARMADAJOSE;AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;VITERI SOLAUN XABIER. Apo.Manc.: HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER.Apoderado: REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;INSUNZA GAMINDE PABLO;SAITUA IRIBAR MARTIN;MARIN RODENAS JORGEMANUEL;PASTOR ZUAZAGA JAVIER JULIO;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;MARTINEZ GARRIDO SANTIAGOMATIAS;CODES CALATRAVA GERARDO;GARZON ORTEGA JUSTO;ALCAIN LOPEZ DANIEL;MARTINEZ GARRIDO SANTIAGOMATIAS;CODES CALATRAVA GERARDO;GARZON ORTEGA JUSTO. Datos registrales. T 5814 , F 130, S 8, H BI 167,A , I/ 2380.(14.10.20).
20 de Octubre de 2020Otros conceptos: Se admiten a negociaci贸n en la Bolsa de Madrid, con efectos a partir del 5 de agosto de 2020, 110.061.000acciones de 0,75 euros de valor nominal, C贸digo Isin ESO144583228, emitidas en la ampliaci贸n de capital que motiv贸 la 2363潞. Datosregistrales. T 5814 , F 125, S 8, H BI 167,A , I/ 2377 .( 8.10.20).
09 de Octubre de 2020Otros conceptos: Dada de baja con efectos del 8 de julio de 2020 de 213.592.000 acciones, c贸digo isin ES0144580Y14, relativas a lareducci贸n de capital social que motiv贸 la 2360潞 inscripci贸n. Datos registrales. T 5814 , F 125, S 8, H BI 167,A , I/ 2376 .(30.09.20).
05 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: ALCAIN LOPEZ DANIEL;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;MARIN RODENAS JORGEMANUEL;SAITUA IRIBAR MARTIN;BURGUERA PEREZ IVAN;MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO MATIAS;CODES CALATRAVA
Revocaciones. Apoderado: REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS. Apo.Manc.: REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;REBOLLOLICEAGA JUAN CARLOS. Apoderado: REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;URQUIDI GARCIA JAVIER;INSUNZA GAMINDEPABLO;PALOMAR HERRERO JORGE;VOZMEDIANO SERRANO MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 5814 , F 120, S 8, HBI 167,A , I/ 2370 .(23.09.20).
Nombramientos. Apoderado: SAINZ ARMADA JOSE;AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;REBOLLO LICEAGA JUANCARLOS;VITERI SOLAUN XABIER;MOSO RAIGOSO AITOR;ALCAIN LOPEZ DANIEL;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER.Datos registrales. T 5814 , F 121, S 8, H BI 167,A , I/ 2374 .(25.09.20).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PEREZ JESUS;URQUIDI GARCIA JAVIER;OCHOA GIL JUAN PEDRO;EDESA VERDEVANESSA;DE LA SOTA ORTUZAR KOSTKA;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;GUTIERREZ CASTELLANOS FRANCISCOJAVIER;DE LA FUENTE LECANDA MARIA;ORMAECHEA MERINO I脩IGO;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;LOPEZ-ARANGURENGORDILLO BOSCO;REBOLLO MIGUEL MARIA;INSUNZA GAMINDE PABLO;AGUIRRE UZQUIANO GREGORIO;ALONSO ARANAJON;GARCIA PEREA JUNCAL;BURGUERA PEREZ IVAN;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;FERNANDEZ BEASCOECHEAJOSE MIGUEL;OMAECHEVARRIA LEGARRA JOSE ANGEL;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;PASTOR ZUAZAGA JAVIERJULIO;SAITUA IRIBAR MARTIN;ALCAIN LOPEZ DANIEL;MORENO HERRERA MARTA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZTAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5814 , F 123, S 8, H BI 167,A , I/ 2375 .(25.09.20).
01 de Octubre de 2020Otros conceptos: Dada de baja con efectos del 8 de julio de 2020 de 213.592.000 acciones, c贸digo isin ES0144580Y14, relativas a lareducci贸n de capital social que motiv贸 la 2360潞 inscripci贸n. Datos registrales. T 5814 , F 121, S 8, H BI 167,A , I/ 2371 .(23.09.20).
Otros conceptos: Dada de baja con efectos del 8 de julio de 2020 de 213.592.000 acciones, c贸digo isin ES0144580Y14, relativas a lareducci贸n de capital social que motiv贸 la 2360潞 inscripci贸n. Datos registrales. T 5814 , F 121, S 8, H BI 167,A , I/ 2372 .(23.09.20).
Otros conceptos: Se admiten a negociaci贸n en la Bolsa de Barcelona , con efectos a partir del 5 de agosto de 2020, 110.061.000acciones de 0,75 euros de valor nominal, C贸digo Isin ESO144583228, emitidas en la ampliaci贸n de capital que motiv贸 la 2363潞. Datosregistrales. T 5814 , F 121, S 8, H BI 167,A , I/ 2373 .(23.09.20).
28 de Septiembre de 2020Otros conceptos: Dada de baja con efectos del 8 de julio de 2020 de 213.592.000 acciones, c贸digo isin ES0124580Y14 relativas a lareducci贸n de capital social que motiv贸 la 2360潞 inscripci贸n. Datos registrales. T 5814 , F 118, S 8, H BI 167,A , I/ 2366 .(16.09.20).
Otros conceptos: Se admiten a negociaci贸n en la Bolsa de Valencia , con efectos a partir del 5 de agosto de 2020, 110.061.000acciones de 0,75 euros de valor nominal, C贸digo Isin ESO144583228, emitidas en la ampliaci贸n de capital que motiv贸 la 2363潞. Datosregistrales. T 5814 , F 118, S 8, H BI 167,A , I/ 2367 .(16.09.20).
Otros conceptos: Se admiten a negociaci贸n en la Bolsa de Bilbao, con efectos a partir del 5 de agosto de 2020, 110.061.000acciones de 0,75 euros de valor nominal, C贸digo Isin ESO144583228, emitidas en la amliaci贸n de capital que motiv贸 la 2363潞. Datosregistrales. T 5814 , F 118, S 8, H BI 167,A , I/ 2368 .(16.09.20).
12 de Agosto de 2020Revocaciones. Apoderado: SAITUA IRIBAR MARTIN;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRI GLADYS. Modificaci贸n depoderes. Apoderado: GOMEZ RODRIGUEZ LUIS MARIA. Datos registrales. T 5814 , F 114, S 8, H BI 167,A , I/ 2364 .(30.07.20).
Otros conceptos: Se modifican los Art铆culos 13潞, 21潞, 27潞, 30潞, 31潞, 34潞, 36潞, 38潞 y 49潞 del Reglamento del Consejo deAdministraci贸n. Datos registrales. T 5814 , F 114, S 8, H BI 167,A , I/ 2365 .(30.07.20).
06 de Agosto de 2020Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 82.545.750,00 Euros. Desembolsado: 82.545.750,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.762.545.750,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.762.545.750,00 Euros. Datos registrales. T 5814 , F 108, S 8, H BI 167,A , I/ 2363 .(30.07.20).
20 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: ALCAIN LOPEZ DANIEL;MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO MATIAS;CODES CALATRAVAGERARDO;GARZON ORTEGA JUSTO. Datos registrales. T 5814 , F 106, S 8, H BI 167,A , I/ 2361 .(10.07.20).
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ GUERRA CARLOS LUIS;FERNANDEZ GUERRA CARLOS LUIS;SAITUA IRIBARMARTIN;UGARRIZA CAPDEVILA ARMANDO JOSE;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYOELENA;COLLADA BANDERAS ANTONIO;VICTORERO VIGIL ENRIQUE;CANALES ABAITUA IGNACIO;RODRIGUEZ ZARZALEJOSAMALIO;COLLADA BANDERAS ANTONIO;ANDREU MERINO MARIA MAGDALENA;COLLADA BANDERAS ANTONIO;ANDREUMERINO MARIA MAGDALENA;DE LA FUENTE GARCIA IGNACIO;VICTORERO VIGIL ENRIQUE;CANALES ABAITUAIGNACIO;RODRIGUEZ ZARZALEJOS AMALIO;COLLADA BANDERAS ANTONIO;ANDREU MERINO MARIA MAGDALENA;DE LAFUENTE GARCIA IGNACIO;MARURI HERNAEZ I脩AKI;CAMARA BELLO ESTER. Apo.Manc.: UGARRIZA CAPDEVILA ARMANDOJOSE;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Apo.Sol.: UGARRIZA CAPDEVILAARMANDO JOSE. Apoderado: UGARRIZA CAPDEVILA ARMANDO JOSE;MARRA RODRIGUEZ JOSE ANGEL;SAITUA IRIBARMARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRIGLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datosregistrales. T 5814 , F 107, S 8, H BI 167,A , I/ 2362 .(10.07.20).
09 de Julio de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 160.194.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.680.000.000,00 Euros. Datos registrales. T5814 , F 103, S 8, H BI 167,A , I/ 2360 .( 2.07.20).
06 de Julio de 2020Otros conceptos: Modificaci贸n de los Art铆culos 36潞, 37潞 y 42潞 del Reglamento del Consejo. Datos registrales. T 5814 , F 96, S 8, HBI 167,A , I/ 2355 .(26.06.20).
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO. Datos registrales. T 5814 , F 96, S 8, H BI 167,A , I/ 2356.(26.06.20).
Nombramientos. Apoderado: MARRA RODRIGUEZ JOSE ANGEL;COLLADA BANDERAS ANTONIO;VICTORERO VIGILENRIQUE;RODRIGUEZ ZARZALEJOS AMALIO;CANALES ABAITUA IGNACIO;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRIGLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5814 , F 98, S 8, H BI 167,A , I/ 2357 .(26.06.20).
Nombramientos. Apoderado: MARRA RODRIGUEZ JOSE ANGEL;UGARRIZA CAPDEVILLA ARMANDO JOSE;SAITUA IRIBARMARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5814 , F 100, S 8, H BI 167,A , I/ 2358.(26.06.20).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GUERRA CARLOS LUIS;CAMARA BELLO ESTER CELINA;SAITUA IRIBARMARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5814 , F 102, S 8, H BI 167,A , I/ 2359.(26.06.20).
24 de Junio de 2020Revocaciones. Apoderado: CANALES ABAITUA ASIS;OCHOA GIL BEGO脩A;ZAMARRON CASSINELLO IGNACIO;SANCHEZGALAN GARCIA TABERNERO IGNACIO;ZUMARRAGA GOROSTIZA RAMON;MARTIN BRAVO BERTA MARIA;CIFUENTESFERNANDEZ FRANCISCO;CABALLERO OCA脩A SILVIA;LOPEZ MONTERO JAVIER;RIBES HURTADO JOSE RAMON;SAITUAIRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GARCIA RUIZ FRANCISCO DE BORJA;AZAGRABLAZQUEZ PEDRO JAVIER;ROMERO IZQUIERDO JUAN;RUIPEREZ CASSINELLO CESAR;REBOLLO LICEAGA JUANCARLOS;SAITUA IRIBAR MARTIN;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRI GLADYS;TOLEDANO LANZA MANUEL;PEREZSANZ ANGEL;O'DONNELL ARMADA ALFONSO. Modificaci贸n de poderes. Apoderado: MOLINA NU脩EZ-LAGOS JOSE MARIA.Datos registrales. T 5814 , F 96, S 8, H BI 167,A , I/ 2354 .(17.06.20).
11 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: CANALES ABAITUA ASIS;OCHOA GIL BEGO脩A;SANCHEZ-GALAN GARCIA-TABERNERO JOSEIGNACIO;ZAMARRON CASSINELLO IGNACIO;ZUMARRAGA GOROSTIZA RAMON;LOMBIDE PALACIOS AITOR;SAITUA IRIBARMARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5814 , F 94, S 8, H BI 167,A , I/ 2352 .(2.06.20).
Revocaciones. Apoderado: SAN SEBASTIAN HECHT CRISTINA;RIBES HURTADO JOSE RAMON. Datos registrales. T 5814 , F95, S 8, H BI 167,A , I/ 2353 .( 2.06.20).
01 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;MESONERO MOLINA DAVID JOSE;RUIPEREZ CASSINELLOCESAR;ALCAIN LOPEZ DANIEL;SAITUA IRIBAR MARTIN;TOLEDANO LANZA MANUEL;PEREZ SANZ ANGEL. Datos registrales.T 5814 , F 91, S 8, H BI 167,A , I/ 2351 .(25.05.20).
28 de Abril de 2020Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y NUEVA REDACCION DE ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 5814 , F67, S 8, H BI 167,A , I/ 2349 .(20.04.20).
Otros conceptos: MODIFICACION Y NUEVA REDACCION DE REGLAMENTO DE LA JUNTA. Datos registrales. T 5814 , F 79, S8, H BI 167,A , I/ 2350 .(20.04.20).
22 de Abril de 2020Nombramientos. Miem.Com.Ej.: GONZALEZ SERNA JUAN MANUEL. Vicepresid.: GONZALEZ SERNA JUAN MANUEL.Reelecciones. Miem.Com.Ej.: BARBER SAMANTHA. Datos registrales. T 5814 , F 64, S 8, H BI 167,A , I/ 2345 .( 6.04.20).
Nombramientos. Vsecr2.NC: DE ELEJOSTE ECHEVARRIA AINARA. Datos registrales. T 5814 , F 64, S 8, H BI 167,A , I/ 2346 .(6.04.20).
Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 5814 , F 64, S 8, H BI 167,A , I/ 2347 .( 6.04.20).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MACHO STADLER INES. Vicepresid.: MACHO STADLER INES. Miem.Com.Ej.: MACHO STADLERINES. Consejero: HOLT DENISE MARY. Nombramientos. Consejero: BREWER NICOLA MARY;NUNES REGINA HELENA JORGE.Reelecciones. Consejero: DE ORIOL IBARRA I脩IGO VICTOR;BARBER SAMANTHA. Datos registrales. T 5814 , F 67, S 8, H BI167,A , I/ 2348 .(15.04.20).
07 de Abril de 2020Nombramientos. Apoderado: ELORZA MARTIN I脩IGO. Datos registrales. T 5814 , F 62, S 8, H BI 167,A , I/ 2340 .(27.03.20).
Nombramientos. Apoderado: ZOTES GARCIA ANA ARANZAZU. Datos registrales. T 5814 , F 62, S 8, H BI 167,A , I/ 2341.(27.03.20).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ FRADE ALFONSO MARIA. Datos registrales. T 5814 , F 63, S 8, H BI 167,A , I/ 2342.(27.03.20).
Nombramientos. Apoderado: MURGA TOME ALVARO. Datos registrales. T 5814 , F 64, S 8, H BI 167,A , I/ 2343 .(27.03.20).
Nombramientos. Apoderado: CANALES ABAITUA ASIS;SAN SEBASTIAN HECHT CRISTINA;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALANLECUBARRI GLADYS;ARBERAS MONTOYA ITZIAR. Datos registrales. T 5814 , F 64, S 8, H BI 167,A , I/ 2344 .(27.03.20).
10 de Marzo de 2020Revocaciones. Apoderado: SIMON BUELA JOSE;SIMON BUELA JOSE. Datos registrales. T 5814 , F 59, S 8, H BI 167,A , I/ 2338.(28.02.20).
Otros conceptos: Se modifican los Art铆culos 1, 6, 8, 9, 10, 13, 34, 36, 52 y 55 del Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Datosregistrales. T 5814 , F 60, S 8, H BI 167,A , I/ 2339 .(28.02.20).
05 de Marzo de 2020Otros conceptos: Admisi贸n a negociaci贸n en la Bolsa de Madrid de 91.520.000 acciones de 0,75 euros de valor nominal emitidas porla inscripci贸n 2333. Datos registrales. T 5814 , F 59, S 8, H BI 167,A , I/ 2336 .(19.02.20).
Otros conceptos: Admisi贸n a negociaci贸n en la Bolsa de Valencia de 91.520.000 acciones de 0,75 euros de valor nominal emitidaspor la inscripci贸n 2333. Datos registrales. T 5814 , F 59, S 8, H BI 167,A , I/ 2337 .(24.02.20).
26 de Febrero de 2020Otros conceptos: Se admiten a negociaci贸n en la Bolsa de Bilbao de 91.520.000 acciones de 0,75 Euros de valor nominal cada unaemitidas en la inscripci贸n 2.333. Datos registrales. T 5814 , F 59, S 8, H BI 167,A , I/ 2334 .(14.02.20).
Otros conceptos: Se admiten a negociacion en la Bolsa de Barcelona 91.520.000 acciones de 0,75 euros de valor nominal emitidasen la inscripci贸n 2333. Datos registrales. T 5814 , F 59, S 8, H BI 167,A , I/ 2335 .(17.02.20).
12 de Febrero de 2020Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 68.640.000,00 Euros. Desembolsado: 68.640.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.840.194.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.840.194.000,00 Euros. Datos registrales. T 5814 , F 52, S 8, H BI 167,A , I/ 2333 .( 4.02.20).
29 de Enero de 2020Nombramientos. Apoderado: GOMEZ RODRIGUEZ LUIS MARIA;SAITUA IRIBAR MARTIN;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALANLECUBARRI GLADYS. Datos registrales. T 5814 , F 50, S 8, H BI 167,A , I/ 2331 .(20.01.20).
Nombramientos. Apoderado: ELORRIAGA FERNANDEZ DE ARROYABE I脩IGO;ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL. Datosregistrales. T 5814 , F 51, S 8, H BI 167,A , I/ 2332 .(20.01.20).
30 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apoderado: ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;DOMINGUEZ CAVERO JUAN PABLO;AGUIRRE UZQUIANOGREGORIO;ARRIETA LOPEZ AINHOA;BURGUERA PEREZ IVAN;DE PALACIO ALBIZU IDOIA;DIEZ ALUSTIZAROBERTO;FERNANDEZ BEASCOECHEA JOSE MIGUEL;GARAYZAR ZORRILLA BORJA;GONZALEZ IZAGUIRREI脩IGO;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;INSUNZA GAMINDE PABLO;LUCARINI SAN JOSE DANIEL;LLAMAZARESSALVADOR AINTZANE;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;MARTINEZ GUTIERREZ MIGUEL;OMAECHEVARRIA LEGARRA JOSEANGEL;PASTOR ZUAZAGA JAVIER JULIO;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;SAITUA IRIBAR MARTIN;SENDIN BOREAI脩IGO;TOBAR PARDO DE SANTAYANA ROCIO;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRI GLADYS. Datos registrales. T5814 , F 49, S 8, H BI 167,A , I/ 2329 .(18.12.19).
Modificaciones estatutarias. Quedan modificados los art铆culos 17潞, 23潞, 24潞, 25, 39潞 y 52潞 del Reglamento del consejo.. Datosregistrales. T 5814 , F 49, S 8, H BI 167,A , I/ 2330 .(19.12.19).
19 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apoderado: ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL;ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL;DE ELEJOSTE ECHEBARRIAAINARA;ZABALZA ESTEVEZ AMAYA;LUCARINI SAN JOSE DANIEL;LAPIDO LAGE MARTA;LEZANA VISUS LUIS JAVIER;ALONSOOSEGUERA SILVIA. Datos registrales. T 5814 , F 46, S 8, H BI 167,A , I/ 2324 .( 9.12.19).
Nombramientos. Apoderado: ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;CAVERO DOMINGUEZ JUAN PABLO;DE ANTA RUBIATOGONZALO. Datos registrales. T 5814 , F 47, S 8, H BI 167,A , I/ 2325 .( 9.12.19).
Nombramientos. Apoderado: ZAPATA BEBIA CRISTINA;ARANDA ORTEGA MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 5814 , F 47, S8, H BI 167,A , I/ 2326 .( 9.12.19).
Nombramientos. Apoderado: LAPIDO LAGE MARTA. Datos registrales. T 5814 , F 48, S 8, H BI 167,A , I/ 2327 .( 9.12.19).
Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ CERVANTES JOSE;LOWHAGEN CARL ARNE FREDERIK;GARCIA GARCIA MARIO.Datos registrales. T 5814 , F 49, S 8, H BI 167,A , I/ 2328 .( 9.12.19).
14 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apoderado: ASENJO MARTIN ANTONIO;ASENJO MARTIN ANTONIO. Datos registrales. T 5814 , F 46, S 8, H BI167,A , I/ 2323 .( 6.11.19).
10 de Octubre de 2019Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN. Datos registrales. T 5814 , F 45, S 8, H BI 167,A , I/ 2322 .(2.10.19).
24 de Septiembre de 2019Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Madrid las 122.072.000 acciones emitidas en la Inscripci贸n2317陋. Datos registrales. T 5814 , F 45, S 8, H BI 167,A , I/ 2321 .(16.09.19).
02 de Septiembre de 2019Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao las 122.072.000 acciones emitidas en la inscripci贸n2317陋. Datos registrales. T 5814 , F 45, S 8, H BI 167,A , I/ 2318 .(22.08.19).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Barcelona las 122.072.000 acciones emitidas en la inscripci贸n2317陋. Datos registrales. T 5814 , F 45, S 8, H BI 167,A , I/ 2319 .(22.08.19).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia las 122.072.000 acciones emitidas en la inscripci贸n2317陋. Datos registrales. T 5814 , F 45, S 8, H BI 167,A , I/ 2320 .(22.08.19).
08 de Agosto de 2019Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 91.554.000,00 Euros. Desembolsado: 91.554.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.771.554.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.771.554.000,00 Euros. Datos registrales. T 5814 , F 39, S 8, H BI 167,A , I/ 2317 .(30.07.19).
26 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO MATIAS;CODES CALATRAVA GERARDO;DE ELEJOSTEECHEBARRIA AINARA;LEGARRETA-ECHEVARRIA LARRAZABAL I脩ESE. Datos registrales. T 5814 , F 39, S 8, H BI 167,A , I/2316 .(19.07.19).
25 de Julio de 2019Otros conceptos: DADAS DE BAJA CON EFECTOS 26/06/2019 280.457.000 ACCIONES CODIGO ES0144580Y14 EN LA BOLSADE VALORES DE BARCELONA. Datos registrales. T 5814 , F 38, S 8, H BI 167,A , I/ 2312 .( 5.07.19).
Otros conceptos: DADAS DE BAJA CON EFECTOS 26/06/2019 280.457.000 ACCIONES CODIGO ES0144580Y14 EN LA BOLSADE VALORES DE BILBAO. Datos registrales. T 5814 , F 38, S 8, H BI 167,A , I/ 2313 .(15.07.19).
Otros conceptos: DADAS DE BAJA CON EFECTOS 26/06/2019 280.457.000 ACCIONES CODIGO ES0144580Y14 EN LA BOLSADE VALORES DE VALENCIA. Datos registrales. T 5814 , F 38, S 8, H BI 167,A , I/ 2314 .(18.07.19).
Otros conceptos: DADAS DE BAJA CON EFECTOS 26/06/2019 280.457.000 ACCIONES CODIGO ES0144580Y14 EN LA BOLSADE VALORES DE MADRID. Datos registrales. T 5814 , F 38, S 8, H BI 167,A , I/ 2315 .(18.07.19).
04 de Julio de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 210.342.750,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.680.000.000,00 Euros. Datos registrales. T5814 , F 36, S 8, H BI 167,A , I/ 2310 .(20.06.19).
Nombramientos. Apoderado: ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;DOMINGUEZ CAVERO JUAN PABLO;DE ANTA RUBIATOGONZALO. Datos registrales. T 5814 , F 38, S 8, H BI 167,A , I/ 2311 .(25.06.19).
25 de Junio de 2019Revocaciones. Apoderado: MOTA GAGO JOSEBA;ARRANZ RUBIO SONIA;CERVANTES DOBBERTIN BEATRIZ GUIOMAR;MOTAGAGO JOSEBA;ASENSIO CASTELLO MARIA DE LOS DESAMPARADOS. Datos registrales. T 5814 , F 34, S 8, H BI 167,A , I/2309 .(17.06.19).
09 de Mayo de 2019Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ART. 13 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.. Datosregistrales. T 5814 , F 34, S 8, H BI 167,A , I/ 2308 .(30.04.19).
17 de Abril de 2019Otros conceptos: Modificaci贸n de los art铆culos 4, 6, 7, 8, 22, 33, 34, 37, 41 y 49 y nueva redacci贸n de los Estatutos Sociales. Datosregistrales. T 5814 , F 15, S 8, H BI 167,A , I/ 2304 .( 4.04.19).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ACEBES PANIAGUA ANGEL JESUS. Nombramientos. Consejero: DE LA RICA GOIRICELAYASARA. Reelecciones. Consejero: ANTOLIN RAYBAUD MARIA HELENA;SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO;HOLT DENISEMARY;WALFREDO FERNANDEZ JOSE;MOREU MUNAIZ MANUEL;SAGREDO ORMAZA XABIER. Otros conceptos: Se determinaque el n煤mero de miembros del Consejo de Administraci贸n sea de catorce. Datos registrales. T 5814 , F 24, S 8, H BI 167,A , I/ 2305.( 4.04.19).
Otros conceptos: Se modifican los art铆culos 13, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 43, 51, 54 y 57, y se da nuevaredacci贸n al Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 5814 , F 25, S 8, H BI 167,A , I/ 2306 .( 4.04.19).
Reelecciones. Con.Delegado: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO. Miem.Com.Ej.: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO;MOREUMUNAIZ MANUEL. Otros conceptos: Se fija en cuatro el n煤mero de miembros de la Comisi贸n Ejecutiva Delegada. Datosregistrales. T 5814 , F 33, S 8, H BI 167,A , I/ 2307 .( 4.04.19).
08 de Abril de 2019Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la bolsa de valores de Madrid las 122.828.000 acciones emitidas en la inscripci贸n2297陋. Datos registrales. T 5814 , F 15, S 8, H BI 167,A , I/ 2303 .(29.03.19).
08 de Marzo de 2019Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia 122.828.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital social que motiv贸 la inscripci贸n 2297陋. Datos registrales. T 5814 , F 14, S 8, H BI 167,A , I/ 2302 .(28.02.19).
04 de Marzo de 2019Otros conceptos: Modificados los art铆culos 7潞, 8潞, 10潞 y 13潞 del Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T5814 , F 12, S 8, H BI 167,A , I/ 2300 .(22.02.19).
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAGREDO ORMAZA XABIER. Nombramientos. Consejero: SAGREDO ORMAZA XABIER. Datosregistrales. T 5814 , F 14, S 8, H BI 167,A , I/ 2301 .(22.02.19).
22 de Febrero de 2019Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Barcelona 122.828.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital social que motiv贸 la inscripci贸n 2297陋. Datos registrales. T 5814 , F 12, S 8, H BI 167,A , I/ 2299 .(13.02.19).
18 de Febrero de 2019Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao, 122.828.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2297陋. Datos registrales. T 5814 , F 12, S 8, H BI 167,A , I/ 2298 .( 7.02.19).
07 de Febrero de 2019Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 92.121.000,00 Euros. Desembolsado: 92.121.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.890.342.750,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.890.342.750,00 Euros. Datos registrales. T 5814 , F 5, S 8, H BI 167,A , I/ 2297 .(31.01.19).
25 de Enero de 2019Revocaciones. Apoderado: JUNQUERA BLANCO ELIMENA. Datos registrales. T 5814 , F 5, S 8, H BI 167,A , I/ 2296 .(18.01.19).
26 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO;MIGOYA VARGAS JOSE LUIS;MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO.Apo.Manc.: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO MATIAS;CODES CALATRAVA GERARDO. Datos registrales. T 5814 , F 5, S 8, H BI167,A , I/ 2295 .(14.12.18).
07 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL;ELORRIAGA FERNANDEZ DE ARROYABE I脩IGO;SAITUA IRIBAR
Revocaciones. Apo.Sol.: MENJON ERIZMENDI ALBERTO;ALONSO OSEGUERA SILVIA. Nombramientos. Apoderado: LEZANAVISUS LUIS JAVIER;ALONSO OSEGUERA SILVIA. Datos registrales. T 5814 , F 4, S 8, H BI 167,A , I/ 2293 .(27.11.18).
Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO. Datos registrales. T 5814 , F 5, S 8, H BI 167,A , I/ 2294 .(27.11.18).
16 de Noviembre de 2018Otros conceptos: Modificaci贸n y nueva redacci贸n del Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 5549 , F 224,S 8, H BI 167,A , I/ 2291 .( 5.11.18).
07 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;INSUNZA GAMINDE PABLO;SAITUA IRIBAR MARTIN;MARINRODENAS JORGE MANUEL;PASTOR ZUAZAGA JAVIER JULIO;BURGUERA PEREZ IVAN;HERNANDO ISLA FRANCISCOJAVIER;MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO MATIAS;CODES CALATRAVA GERARDO;GARZON ORTEGA JUSTO. Datosregistrales. T 5549 , F 222, S 8, H BI 167,A , I/ 2289 .(30.10.18).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;INSUNZA GAMINDE PABLO;MIGOYA VARGAS JOSELUIS;SAITUA IRIBAR MARTIN;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;PASTOR ZUAZAGA JAVIER;BURGUERA PEREZIVAN;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: ELORRIAGA FERNANDEZ DE ARROYABE I脩IGO;ARRIETAGARRAMIOLA MIGUEL;DE ELEJOSTE ECHEBARRIA AINARA. Datos registrales. T 5549 , F 224, S 8, H BI 167,A , I/ 2290.(30.10.18).
02 de Noviembre de 2018Modificaci贸n de poderes. Apoderado: ASENJO MARTIN ANTONIO;VICTORERO VIGIL ENRIQUE;CANALES ABAITUAIGNACIO;RODRIGUEZ ZARZALEJOS AMALIO;COLLADA BANDERAS ANTONIO;ANDREU MERINO MARIA MAGDALENA;DE LAFUENTE GARCIA IGNACIO;CANALES ABAITUA ASIS;LOPEZ MONTERO JAVIER;ARRANZ RUBIO SONIA;RIBES HURTADO JOSERAMON;MARURI HERNAEZ I脩AKI;CERVANTES DOBBERTIN BEATRIZ GUIOMAR. Apo.Sol.: UGARRIZA CAPDEVILA ARMANDOJOSE. Datos registrales. T 5549 , F 222, S 8, H BI 167,A , I/ 2288 .(17.10.18).
11 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: LEON MU脩OZ ELENA;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS. Datos registrales. T5549 , F 221, S 8, H BI 167,A , I/ 2287 .( 3.10.18).
26 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: CASTRO GONZALEZ JULIO RAMON;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;SAITUA IRIBARMARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS. Apo.Sol.: CASTRO GONZALEZ JULIO RAMON. Datos registrales. T 5549 , F 221, S 8, HBI 167,A , I/ 2286 .(18.09.18).
07 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apoderado: ARRIETA BLANCO JAVIER;MIGOYA VARGAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 5549 , F 218, S 8, H BI167,A , I/ 2284 .(31.08.18).
Nombramientos. Apoderado: MARRA RODRIGUEZ JOSE ANGEL;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRIGLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5549 , F 218, S 8, H BI 167,A , I/ 2285 .(31.08.18).
28 de Agosto de 2018Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Madrid las 157.629.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2278陋, con efectos a partir del 1/8/2018 y con C贸digo Isin ES0144583186. Datos registrales. T 5549 ,F 218, S 8, H BI 167,A , I/ 2283 .(20.08.18).
22 de Agosto de 2018Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia las 157.629.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2278陋, con efectos a partir del 1/8/2018, y con C贸digo Isin ES0144583186. Datos registrales. T 5549, F 218, S 8, H BI 167,A , I/ 2281 .(14.08.18).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Barcelona las 157.629.000 acciones emitidas en la ampliaci贸nde capital que motiv贸 la inscripci贸n 2278陋, con efectos a partir del 1/8/2018, y con C贸digo Isin ES0144583186. Datos registrales. T5549 , F 218, S 8, H BI 167,A , I/ 2282 .(14.08.18).
16 de Agosto de 2018Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao las 157.629.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2278陋, con efectos a partir del 1/8/2018, y con C贸digo Isin ES0144583186. Datos registrales. T 5549, F 218, S 8, H BI 167,A , I/ 2280 .( 6.08.18).
03 de Agosto de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 118.221.750,00 Euros. Desembolsado: 118.221.750,00 Euros. Resultante Suscrito:4.798.221.750,00 Euros. Resultante Desembolsado: 4.798.221.750,00 Euros. Datos registrales. T 5549 , F 212, S 8, H BI 167,A , I/2278 .(30.07.18).
Otros conceptos: Dadas de baja de la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Mdrid, con efectos del d铆a 2 de julio de 2018, inclusive,las 198.374.000 acciones de esta sociedad, de 0,75 euros de valor nominal. Datos registrales. T 5549 , F 217, S 8, H BI 167,A , I/2279 .(30.07.18).
01 de Agosto de 2018Otros conceptos: Dadas de baja de la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia, con efectos del d铆a 2 de julio de 2018,inclusive, 198.374.000 acciones de 0,75 euros de valor nominal c/u. C贸digo de valor ES0144580Y14. Datos registrales. T 5549 , F212, S 8, H BI 167,A , I/ 2277 .(24.07.18).
17 de Julio de 2018Otros conceptos: Causan baja 198.374.000. acciones con efectos del 2 de julio de 2018. C贸digo ESO144580Y14. Datosregistrales. T 5549 , F 212, S 8, H BI 167,A , I/ 2276 .( 6.07.18).
12 de Julio de 2018Revocaciones. Apoderado: MURGA TOME ALVARO;NAVALON BURGOS BALDOMERO;NAVALON BURGOSBALDOMERO;NAVALON BURGOS BALDOMERO;NAVALON BURGOS BALDOMERO;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALANLECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;NAVALON BURGOS BALDOMERO;MURGA TOME ALVARO. Datos registrales.T 5549 , F 207, S 8, H BI 167,A , I/ 2271 .( 5.07.18).
Nombramientos. Apoderado: ALONSO RODRIGUEZ I脩IGO;FERNANDEZ MOLINA DIEGO. Datos registrales. T 5549 , F 208, S 8,H BI 167,A , I/ 2272 .( 5.07.18).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE MORENO MARIA TERESA. Datos registrales. T 5549 , F 209, S 8, HBI 167,A , I/ 2273 .( 5.07.18).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO MATIAS. Datos registrales. T 5549 , F 209, S 8, H BI 167,A , I/2274 .( 5.07.18).
Otros conceptos: Causan baja 198.374.000 acciones a efectos del 2 de julio de 2018, c贸digo ES0144580Y14, en la Bolsa de Valoresde Bilbao. Datos registrales. T 5549 , F 212, S 8, H BI 167,A , I/ 2275 .( 6.07.18).
11 de Julio de 2018Otros conceptos: Modificaci贸n y nueva redacci贸n del Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 5549 , F 202,S 8, H BI 167,A , I/ 2268 .(28.06.18).
Nombramientos. Vicepresid.: MACHO STADLER INES. Datos registrales. T 5549 , F 206, S 8, H BI 167,A , I/ 2269 .(28.06.18).
Nombramientos. Consej.Coord: GONZALEZ SERNA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 5549 , F 207, S 8, H BI 167,A , I/ 2270.(28.06.18).
05 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO;MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN;MARTINEZ GARRIDOSANTIAGO;ELEJOSTE ECHEBARRIA AINARA. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 148.780.500,00 Euros. Resultante
08 de Junio de 2018Revocaciones. Apoderado: SAINZ HERNANDEZ NOEMI. Datos registrales. T 5549 , F 198, S 8, H BI 167,A , I/ 2265 .(30.05.18).
Revocaciones. Apoderado: SAINZ HERNANDEZ NOEMI;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZTAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5549 , F 198, S 8, H BI 167,A , I/ 2266 .(30.05.18).
04 de Mayo de 2018Revocaciones. Apoderado: ARIAS COTERILLO FERNANDO JULIO;ARIAS COTERILLO FERNANDO JULIO. Apo.Man.Soli: ARIASCOTERILLO FERNANDO. Apoderado: ARIAS COTERILLO FERNANDO JULIO. Datos registrales. T 5549 , F 195, S 8, H BI 167,A ,I/ 2261 .(18.04.18).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA- ROZADO GONZALEZ BEGO脩A;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRIGLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5549 , F 195, S 8, H BI 167,A , I/ 2262 .(18.04.18).
Nombramientos. Apoderado: CODES CALATRAVA GERARDO;GARZON ORTEGA JUSTO;DURAN DOMINGUEZ JULIA;SAITUAIRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS. Datos registrales. T 5549 , F 197, S 8, H BI 167,A , I/ 2263 .(18.04.18).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MEDEL CAMARA BRAULIO. Nombramientos. Consejero: GARDNER ANTHONY LUZZATTO.Reelecciones. Consejero: KESSEL MARTINEZ GEORGINA YAMILET. Datos registrales. T 5549 , F 198, S 8, H BI 167,A , I/ 2264.(19.04.18).
21 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: SIMON BUELA JOSE;PALOMAR HERRERO JORGE;VOZMEDIANO SERRANO MARIA DELCARMEN;URIBE DIEZ JOAN;ORTEGA MARI脩O IGNACIO. Datos registrales. T 5549 , F 194, S 8, H BI 167,A , I/ 2259 .(14.03.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: RUPEREZ GARCIA DEL CARRIZO I脩IGO;ZARAGOZA DORR ISABEL. Nombramientos. Apoderado:RELA脩O COBIAN GREGORIO;FERNANDEZ DE PRADA ALFIN MARGARITA ANDREA;ZARAGOZA DORR ISABEL. Datosregistrales. T 5549 , F 194, S 8, H BI 167,A , I/ 2260 .(14.03.18).
07 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;SANCHEZ HERRERO ISABEL;ROMERO IZQUIERDOJUAN;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;SAITUA IRIBAR MARTIN;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRIGLADYS;TOLEDANO LANZA MANUEL;JUNQUERA BLANCO ELIMENA;PEREZ SANZ ANGEL. Datos registrales. T 5549 , F 193, S8, H BI 167,A , I/ 2257 .(28.02.18).
Otros conceptos: Adminitidas a negociaci贸n en la bolsa de valores de Bilbao las acciones emitidas en la ampliaci贸n de capital de lainscripci贸n 2252陋. Datos registrales. T 5549 , F 193, S 8, H BI 167,A , I/ 2258 .(28.02.18).
01 de Marzo de 2018Otros conceptos: Adminitidas a negociaci贸n en la bolsa de valores de Valencia las acciones emitidas en la ampliaci贸n de capital dela inscripci贸n 2252陋. Datos registrales. T 5549 , F 193, S 8, H BI 167,A , I/ 2256 .(22.02.18).
23 de Febrero de 2018Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la bolsa de valores de Madrid, las 120.859.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2252陋. Datos registrales. T 5549 , F 193, S 8, H BI 167,A , I/ 2254 .(14.02.18).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la bolsa de valores de Barcelona las acciones emitidas en la ampliaci贸n de capital de lainscripci贸n 2252陋. Datos registrales. T 5549 , F 193, S 8, H BI 167,A , I/ 2255 .(15.02.18).
16 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;ROMERO IZQUIERDO JUAN;RUIPEREZ CASSINELLOCESAR;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;SAITUA IRIBAR MARTIN;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRIGLADYS;TOLEDANO LANZA MANUEL;JUNQUERA BLANCO ELIMENA;PEREZ SANZ ANGEL;O'DONNELL ARMADA ALFONSO.Datos registrales. T 5549 , F 190, S 8, H BI 167,A , I/ 2253 .( 9.02.18).
07 de Febrero de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 90.644.250,00 Euros. Desembolsado: 90.644.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.828.780.500,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.828.780.500,00 Euros. Datos registrales. T 5549 , F 186, S 8, H BI 167,A , I/ 2252 .(31.01.18).
31 de Enero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: CHIARRI TOSCANO ANGEL JESUS. Apoderado: CHIARRI TOSCANO ANGEL JESUS. Datos registrales.T 5549 , F 186, S 8, H BI 167,A , I/ 2251 .(19.01.18).
02 de Enero de 2018Modificaciones estatutarias. Modificados los Art铆culos 8, 11, 27, 29 y 44 del Reglamento del Consejo de Administraci贸n.. Datosregistrales. T 5549 , F 184, S 8, H BI 167,A , I/ 2250 .(22.12.17).
23 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: FIGUEROA BAHILLO JOSE ANGEL;FRESNEDA PORTILLO ANA MARIA. Datos registrales. T 5549 ,F 178, S 8, H BI 167,A , I/ 2248 .(15.11.17).
Revocaciones. Apoderado: ARRIOLA ALCIBAR ITZIAR;CASTRO RUIZ BEGO脩A;DE LA FUENTE LECANDA MARIA;DE LA SOTAORTUZAR KOSTKA;DIEZ REBANAL JORGE;EDESA VERDE VANESSA;GUTIERREZ CASTELLANOS FRANCISCOJAVIER;LEZANA VISUS LUIS;LOPEZ SANZ MAIDER;MARTINEZ PEREZ JESUS;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;OCHOA GILJUAN PEDRO;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;URQUIDI GARCIA JAVIER;ZUAZAGA SASTRE DAVID;ARRIETA BLANCOJAVIER;HERRERO NAVAS SANTIAGO;IZQUIERDO PUMAR MARTA;LOPEZ-ARANGUREN GORDILLO BOSCO;REBOLLO MIGUELMARIA;AGUIRRE UZQUIANO GREGORIO;ALONSO ARANA JON;ARBERAS MONTOYA ITZIAR;ARETXALDE UGARTETXEAITOR;ARIAS COTERILLO FERNANDO JULIO;ARRIETA LOPEZ AINHOA;BURGUERA PEREZ IVAN;CAMARDIEL FERNANDEZGORKA;DE PALACIO ALBIZU IDOIA;DIEZ ALUSTIZA ROBERTO;DORIA DE ELEJOSTE ADRIANA;FERNANDEZ BEASCOECHEAJOSE MIGUEL;GARAIZAR ZORRILLA BORJA;GARCIA PEREA JUNCAL;GONZALEZ IZAGUIRRE I脩IGO;HERNANDO ISLAFRANCISCO JAVIER;IBA脩EZ RODELGO LAURA;INSUNZA GAMINDE PABLO;LETONA LOPEZ ALBERTO JOSE;LUCARINI SANJOSE DANIEL;LLAMAZARES SALVADOR AINTZANE;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;MARTINEZ GUTIERREZMIGUEL;MIGOYA VARGAS JOSE LUIS;MORCK FELIX;MOTA GAGO JOSEBA;OMAECHEVARRIA LEGARRA JOSEANGEL;PASTOR ZUAZAGA JAVIER JULIO;ROTAECHE LACHIONDO MIKEL;SAITUA IRIBAR MARTIN;SALAZAR BLANCOJAVIER;SENDIN BOREA I脩IGO;TOBAR PARDO DE SANTAYANA ROCIO;ASENSIO CASTELLO MARIA DE LOSDESAMPARADOS;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Apo.Sol.: ZU脩IGA BENAVIDES JUANJOSE;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS. Nombramientos. Apoderado: ARRIOLA ALCIBAR ITZIAR;CASTRO RUIZ BEGO脩A;DELA FUENTE LECANDA MARIA;DE LA SOTA ORTUZAR KOSTKA;DIEZ REBANAL JORGE;EDESA VERDE VANESSA;GUTIERREZCASTELLANOS FRANCISCO JAVIER;LEZANA VISUS LUIS JAVIER;LOPEZ SANZ MAIDER;MARTINEZ PEREZ JESUS;MENJONERIZMENDI ALBERTO;OCHOA GIL JUAN PEDRO;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;URQUIDI GARCIA JAVIER;ZUAZAGASASTRE DAVID;ARRIETA BLANCO JAVIER;HERRERO NAVAS SANTIAGO;IZQUIERDO PUMAR MARTA;LOPEZ ARANGURENGORDILLO JUAN BOSCO;REBOLLO MIGUEL MARIA;AGUIRRE UZQUIANO GREGORIO;ALONSO ARANA JON;ARBERASMONTOYA ITZIAR;ARETXALDE UGARTETXE AITOR;ARIAS COTERILLO FERNANDO JULIO;ARRIETA LOPEZAINHOA;BURGUERA PEREZ IVAN;DE PALACIO ALBIZU IDOIA;DIEZ ALUSTIZA ROBERTO;DORIA DE ELEJOSTEADRIANA;FERNANDEZ BEASCOECHEA JOSE MIGUEL;GARAIZAR ZORRILLA BORJA;GARCIA PEREA JUNCAL;GONZALEZIZAGUIRRE I脩IGO;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;IBA脩EZ RODELGO LAURA;INSUNZA GAMINDE PABLO;LETONALOPEZ ALBERTO JOSE;LLAMAZARES SALVADOR AINTZANE;LUCARINI SAN JOSE DANIEL;MARIN RODENAS JORGEMANUEL;MARTINEZ GUTIERREZ MIGUEL;MIGOYA VARGAS JOSE LUIS;MOTA GAGO JOSEBA;OMAECHEVARRIA LEGARRAJOSE ANGEL;PASTOR ZUAZAGA JAVIER JULIO;ROTAECHE LACHIONDO MIKEL;SAITUA IRIBAR MARTIN;SALAZAR BLANCOJAVIER;SENDIN BOREA I脩IGO;SOLOZABAL APELLANIZ JOSE IGNACIO;TOBAR PARDO DE SANTAYANA ROCIO;ASENSIOCASTELLO MARIA DE LOS DESAMPARADOS;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T5549 , F 178, S 8, H BI 167,A , I/ 2249 .(15.11.17).
16 de Noviembre de 2017Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 8 y 26 del Reglamento del Consejo de Administraci贸n.. Datos registrales. T5549 , F 175, S 8, H BI 167,A , I/ 2247 .( 6.11.17).
13 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apoderado: RIOS CANOVAS JOSE LUIS. Apo.Manc.: VIDEGAIN MURO JUAN;BORRAS ALVAREZ JOSE MANUEL.Apoderado: ELORZA MARTIN I脩IGO. Datos registrales. T 5549 , F 175, S 8, H BI 167,A , I/ 2246 .( 2.11.17).
25 de Octubre de 2017Revocaciones. Apoderado: GOMEZ RODRIGUEZ LUIS MARIA;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 5549 , F175, S 8, H BI 167,A , I/ 2245 .(13.10.17).
11 de Octubre de 2017Revocaciones. Apoderado: IBERDROLA GENERACION SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 5549 , F 174, S 8, H BI 167,A, I/ 2244 .(28.09.17).
11 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: PARDO DE SANTAYANA MONTES JUAN GASPAR. Datos registrales. T 5549 , F 171, S 8, H BI167,A , I/ 2241 .( 4.09.17).
Nombramientos. Apo.Manc.: CASTRO GONZALEZ JULIO RAMON;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;SAITUA IRIBARMARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS. Apo.Sol.: CASTRO GONZALEZ JULIO RAMON. Datos registrales. T 5549 , F 172, S 8, HBI 167,A , I/ 2242 .( 4.09.17).
Revocaciones. Apoderado: LLEDO VICENTE JAVIER;ANDREU MERINO MARIA MAGDALENA;SAINZ HERNANDEZ NOEMI.Apo.Sol.: CASTRO GONZALEZ JULIO RAMON. Apoderado: CASTRO GONZALEZ JULIO RAMON;REBOLLO LICEAGA JUANCARLOS;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;PERNIA OSTOLAZA JESUS MARIA;SAITUA IRIBAR MARTIN.Apo.Sol.: PERNIA OSTOLAZA JESUS MARIA;ORBEGOZO GUZMAN RAFAEL. Apoderado: GARCIA LOPEZ JESUS;SAITUA IRIBARMARTIN. Datos registrales. T 5549 , F 174, S 8, H BI 167,A , I/ 2243 .( 4.09.17).
21 de Agosto de 2017Otros conceptos: Admitidas a cotizaci贸n en la Bolsa de Valores de Barcelona las 77.515.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2.233陋- Datos registrales. T 5549 , F 171, S 8, H BI 167,A , I/ 2237 .(10.08.17).
Otros conceptos: Admitidas a cotizaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao las 77.515.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2.233陋. Datos registrales. T 5549 , F 171, S 8, H BI 167,A , I/ 2238 .(10.08.17).
Otros conceptos: Admitidas a cotizaci贸n en la Bolsa de Valores de Madrid las 77.515.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2.233陋. Datos registrales. T 5549 , F 171, S 8, H BI 167,A , I/ 2239 .(10.08.17).
Otros conceptos: Admitidas a cotizaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia, las 77.515.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2.233陋. Datos registrales. T 5549 , F 171, S 8, H BI 167,A , I/ 2240 .(10.08.17).
03 de Agosto de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 58.136.250,00 Euros. Desembolsado: 58.136.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.738.136.250,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.738.136.250,00 Euros. Datos registrales. T 5549 , F 162, S 8, H BI 167,A , I/ 2233 .(24.07.17).
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ SAEZ ELENA;MOSO RAIGOSO AITOR;CHIARRI TOSCANO ANGEL JESUS;SIMONBUELA JOSE;ROJO SEVILLANO FELIX;MARTIN GOMEZ SANTIAGO;CAMPA脩A AVILA ANDRES. Datos registrales. T 5549 , F167, S 8, H BI 167,A , I/ 2234 .(26.07.17).
Nombramientos. Apoderado: MOSO RAIGOSO AITOR;CHIARRI TOSCANO ANGEL JESUS;RELA脩O COBIAN GREGORIO;SIMONBUELA JOSE;RAPUN JIMENEZ JOSE LUIS;ROJO SEVILLANO FELIX;MOLINA NU脩EZ-LAGOS JOSE MARIA;MARTIN GOMEZSANTIAGO;GARCIA RUIZ FRANCISCO DE BORJA. Datos registrales. T 5549 , F 168, S 8, H BI 167,A , I/ 2235 .(26.07.17).
Nombramientos. Apoderado: NAVALON BURGOS BALDOMERO;UGARRIZA CAPDEVILA ARMANDO JOSE;MURGA TOMEALVARO. Datos registrales. T 5549 , F 169, S 8, H BI 167,A , I/ 2236 .(26.07.17).
29 de Junio de 2017Otros conceptos: Modificados los art铆culos 8, 22, 24, 26, 27, 28, 29 y 32 del Reglamento del Consejo. Datos registrales. T 5549 , F158, S 8, H BI 167,A , I/ 2232 .(22.06.17).
21 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: CAMPA脩A AVILA ANDRES. Datos registrales. T 5549 , F 156, S 8, H BI 167,A , I/ 2229 .(12.06.17).
Otros conceptos: DADAS DE BAJA CON EFECTOS 01/06/2017 219.990.000 ACCIONES CODIGO ESO 0144580Y14 EN LABOLSA DE VALORES DE MADRID. Datos registrales. T 5549 , F 156, S 8, H BI 167,A , I/ 2230 .(12.06.17).
Otros conceptos: DADAS DE BAJA CON EFECTOS 01/06/2017 219.990.000 ACCIONES CODIGO ES0144580Y14 EN LA BOLSADE VALORES DE VALENCIA. Datos registrales. T 5549 , F 156, S 8, H BI 167,A , I/ 2231 .(12.06.17).
16 de Junio de 2017Otros conceptos: DADAS DE BAJA CON EFECTOS 1/6/2017 219.990.000 ACCIONES CODIGO ES0144580Y14 EN LA BOLSA DEVALORES DE BARCELONA. Datos registrales. T 5549 , F 156, S 8, H BI 167,A , I/ 2227 .( 9.06.17).
Otros conceptos: DADAS DE BAJA CON EFECTOS 1/6/2017 219.990.000 ACCIONES CODIGO ES0144580Y14 EN LA BOLSA DEVALORES DE BILBAO. Datos registrales. T 5549 , F 156, S 8, H BI 167,A , I/ 2228 .( 9.06.17).
07 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO;MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN;MARTINEZ GARRIDOSANTIAGO;DE ELEJOSTE ECHEBARRIA AINARA. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 164.992.500,00 Euros. ResultanteSuscrito: 4.680.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 5549 , F 151, S 8, H BI 167,A , I/ 2225 .(29.05.17).
09 de Mayo de 2017Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ BILBAO BORJA;FERNANDEZ BILBAO BORJA;FERNANDEZ BILBAO BORJA. Datosregistrales. T 5549 , F 151, S 8, H BI 167,A , I/ 2224 .(28.04.17).
18 de Abril de 2017Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA.Datos registrales. T 5549 , F 128, S 8, H BI 167,A , I/ 2216 .( 4.04.17).
Modificaciones estatutarias. Introducci贸n de un Pre谩mbulo y modificaci贸n de los Art铆culos 7潞 y 8潞 y nueva redacci贸n de losESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 5549 , F 128, S 8, H BI 167,A , I/ 2217 .( 4.04.17).
Otros conceptos: Modificado y redactado nuevamente el Reglamento de la Junta. Datos registrales. T 5549 , F 137, S 8, H BI167,A , I/ 2218 .( 4.04.17).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ LAGE SANTIAGO;SAN PEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS. Miem.Com.Ej.: SANPEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ SERNA JUAN MANUEL;MARTINEZCORCOLES FRANCISCO. Datos registrales. T 5549 , F 148, S 8, H BI 167,A , I/ 2219 .( 4.04.17).
Nombramientos. Miem.Com.Ej.: BARBER SAMANTHA. Datos registrales. T 5549 , F 148, S 8, H BI 167,A , I/ 2220 .( 4.04.17).
Nombramientos. Apoderado: MOSO RAIGOSO AITOR;CHIARRI TOSCANO ANGEL JESUS;SIMON BUELA JOSE;ROJOSEVILLANO FELIX;MARTIN GOMEZ SANTIAGO;CAMPA脩A AVILA ANDRES. Datos registrales. T 5549 , F 148, S 8, H BI 167,A , I/2221 .( 5.04.17).
Nombramientos. Apoderado: NAVALON BURGOS BALDOMERO;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRIGLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5549 , F 149, S 8, H BI 167,A , I/ 2222 .( 5.04.17).
Revocaciones. Apoderado: CASTRESANA SANCHEZ RAMON;CASTRESANA SANCHEZ RAMON;CASTRESANA SANCHEZRAMON;CASTRESANA SANCHEZ RAMON;CASTRESANA SANCHEZ RAMON. Datos registrales. T 5549 , F 151, S 8, H BI 167,A ,I/ 2223 .( 5.04.17).
21 de Marzo de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: UGARRIZA CAPDEVILA ARMANDO JOSE;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRIGLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Apo.Sol.: UGARRIZA CAPDEVILA ARMANDO JOSE. Datos registrales. T 5549 , F 126, S 8,H BI 167,A , I/ 2214 .(10.03.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN;ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL;DE ELEJOSTEECHEBARRIA AINARA;ZABALZA ESTEVEZ AMAYA. Datos registrales. T 5549 , F 127, S 8, H BI 167,A , I/ 2215 .(10.03.17).
06 de Marzo de 2017Revocaciones. Apoderado: CODES CALATRAVA GERARDO;HERRERA PEREDA MARIA DOLORES;GARZON ORTEGAJUSTO;ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 5549 , F 122, S 8, H BI 167,A ,I/ 2212 .(23.02.17).
Modificaciones estatutarias. Modificacion de los art铆culos 8, 26, 27, 28, 29, 34 y 39 del Reglamento del Consejo de Administraci贸n..Datos registrales. T 5549 , F 122, S 8, H BI 167,A , I/ 2213 .(24.02.17).
20 de Febrero de 2017Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Madrid 97.911.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n de capital quemotiv贸 la inscripci贸n 2205陋. Datos registrales. T 5549 , F 117, S 8, H BI 167,A , I/ 2207 .(10.02.17).
Nombramientos. Apoderado: CODES CALATRAVA GERARDO;SAITUA IRIBAR MARTIN. Datos registrales. T 5549 , F 117, S 8, HBI 167,A , I/ 2208 .(10.02.17).
Revocaciones. Apoderado: ARRIOLA ALCIBAR ITZIAR;CASTRO RUIZ BEGO脩A;DIEZ REBANAL JORGE;DE LA FUENTELECANDA MARIA;DE LA SOTA ORTUZAR KOSTKA;EDESA VERDE VANESSA;GUTIERREZ CASTELLANOS FRANCISCOJAVIER;LEZANA VISUS LUIS;LOPEZ SANZ MAIDER;MARTINEZ PEREZ JESUS;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;OCHOA GILJUAN PEDRO;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;URQUIDI GARCIA JAVIER;ZUAZAGA SASTRE DAVID;ARRIETA BLANCOJAVIER;HERRERO NAVAS SANTIAGO;IZQUIERDO PUMAR MARTA;LOPEZ-ARANGUREN GORDILLO BOSCO;REBOLLO MIGUELMARIA;ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;AGUIRRE UZQUIANO GREGORIO;ARBERAS MONTOYA ITZIAR;ARETXALDEUGARTETXE AITOR;ARIAS COTERILLO FERNANDO JULIO;ARRIETA LOPEZ AINHOA;BURGUERA PEREZ IVAN;CAMARDIELFERNANDEZ GORKA;DE PALACIO ALBIZU IDOIA;DIEZ ALUSTIZA ROBERTO;DORIA DE ELEJOSTE ADRIANA;FERNANDEZBEASCOECHEA JOSE MIGUEL;GARAYZAR ZORRILLA BORJA;GONZALEZ IZAGUIRRE I脩IGO;HERNANDO ISLA FRANCISCOJAVIER;IBA脩EZ RODELGO LAURA;INSUNZA GAMINDE PABLO;LETONA LOPEZ ALBERTO JOSE;LUCARINI SAN JOSEDANIEL;LLAMAZARES SALVADOR AINTZANE;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;MARTINEZ GUTIERREZ MIGUEL;MIGOYAVARGAS JOSE LUIS;MORCK FELIX;MOTA GAGO JOSEBA;OMAECHEVARRIA LEGARRA JOSE ANGEL;PASTOR ZUAZAGAJAVIER JULIO;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;ROTAECHE LACHIONDO MIKEL;SAITUA IRIBAR MARTIN;SALAZAR BLANCOJAVIER;SENDIN BOREA I脩IGO;TOBAR PARDO DE SANTAYANA ROCIO;ASENSIO CASTELLO MARIA DE LOSDESAMPARADOS;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Nombramientos. Apoderado: ARRIOLA ALCIBARITZIAR;CASTRO RUIZ BEGO脩A;DE LA FUENTE LECANDA MARIA;DE LA SOTA ORTUZAR KOSTKA;DIEZ REBANALJORGE;EDESA VERDE VANESSA;GUTIERREZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER;LEZANA VISUS LUIS;LOPEZ SANZMAIDER;MARTINEZ PEREZ JESUS;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;OCHOA GIL JUAN PEDRO;REAL DE ASUA GUINEAIGNACIO;URQUIDI GARCIA JAVIER;ZUAZAGA SASTRE DAVID;ARRIETA BLANCO JAVIER;HERRERO NAVASSANTIAGO;IZQUIERDO PUMAR MARTA;LOPEZ-ARANGUREN GORDILLO BOSCO;REBOLLO MIGUEL MARIA;AGUIRREUZQUIANO GREGORIO;ALONSO ARANA JON;ARBERAS MONTOYA ITZIAR;ARETXALDE UGARTETXE AITOR;ARIAS
Otros conceptos: Admitidas en la Bolsa de Barcelona las 97.911.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n de capital que motiv贸 lainscripci贸n 2205陋. Datos registrales. T 5549 , F 122, S 8, H BI 167,A , I/ 2210 .(13.02.17).
Otros conceptos: Admitidas en la Bolsa de Valencia 97.911.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n de capital que motiv贸 lainscripci贸n 2205陋. Datos registrales. T 5549 , F 122, S 8, H BI 167,A , I/ 2211 .(13.02.17).
16 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: RIBES HURTADO JOSE RAMON. Datos registrales. T 5549 , F 116, S 8, H BI 167,A , I/ 2206 .(9.02.17).
14 de Febrero de 2017Otros conceptos: Admitidas a negociacion en la Bolsa de Valores de Bilbao 97.911.000 acciones de 0,75euros de valor nominalemitidas en la ampliaci贸n de capital que motiv贸 la ins. 2204. Datos registrales. T 5549 , F 116, S 8, H BI 167,A , I/ 2205 .( 3.02.17).
06 de Febrero de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 73.433.250,00 Euros. Desembolsado: 73.433.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.844.992.500,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.844.992.500,00 Euros. Datos registrales. T 5549 , F 112, S 8, H BI 167,A , I/ 2204 .(26.01.17).
02 de Enero de 2017Revocaciones. Apoderado: DE LA TORRE RODRIGUEZ MARIA. Datos registrales. T 5549 , F 109, S 8, H BI 167,A , I/ 2202.(23.12.16).
Modificaciones estatutarias. Supresi贸n de la Disposici贸n Transitoria Unica y modificaci贸n de los art铆culos 2, 8, 15, 18, 27, 34 y 43 delReglamento del Consejo.. Datos registrales. T 5549 , F 109, S 8, H BI 167,A , I/ 2203 .(23.12.16).
30 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apoderado: ITURRIA MALFATTI RICHARD;BASAGOITI MIRANDA I脩IGO. Datos registrales. T 5549 , F 108, S 8, HBI 167,A , I/ 2201 .(16.12.16).
19 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apoderado: DOMINGUEZ INIESTA ROSA MARIA;NAVAJOS GARBIN MARIANO;MARTIN BOIX ANTONIO;MU脩OZMARTIN SANTIAGO;VELAZQUEZ GONZALEZ LUIS;VELAZQUEZ GONZALEZ DIEGO;MU脩OZ BLANCO YAGO;GARCIA BUENOJULIO;DE MATEOS I脩IGUEZ RAMON;GARCIA ARQUIMBAU PEREZ HEREDIA VICENTE;SANZ DE BREMOND NORIEGACARLOS;AGUIRREZABAL GABICAECHEVARRIA IGNACIO;LOR BALLABRIGA ANGEL;FERNANDEZ TORIJA OYON MARIAPUY;HERAS ROMANOS ISAAC;HERAS ERADES ISAAC;DEL CAMPO GOMIS JUAN CARLOS;MONLLOR ALEJOS ROSAMARIA;LOPEZ ALASCIO SANCHEZ JAVIER;GARCIA SANCHEZ JOSE ANTONIO;ANDRES GUZMAN EDUARDO;HIERROREQUENA LIBORIO PABLO;AGUIRREZABAL EGILUZ MARIA AURELIA;REYES GALLUR REGINA;GARAY IBARRECHE BORJA.Datos registrales. T 5549 , F 108, S 8, H BI 167,A , I/ 2200 .( 7.12.16).
05 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: ESTEBAN FERNANDEZ LAURA;PEREZ AVILA JOSE ENRIQUE;MARTINEZ TENDERO MARIAJOSE;VIDAL MOLTO RAMON JOSE;GIL AGUNDEZ EVARISTO;TEJEDA HERREROS JESUS;PEREZ BARRIOS JOSELUIS;FERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS;ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA;MARTINEZ ALCOBA MARIA BEGO脩A;BONAILMARTINEZ FRANCISCO JAVIER;CRISOL VAZQUEZ MIGUEL ANGEL;GRACIA CHICHARRO JOSE MANUEL;MAROTO ALBARI脩OJOSE MARIA;SALAS TRUJILLO DIEGO. Apoderado: BUSTINZA CASTRESANA MIREN KARMELE;CABALLERO HERRERIAMARINA;MARTINEZ PEREZ JESUS;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;URQUIDI GARCIA JAVIER;CASAS CHINCHURRETAPABLO;OCHOA GIL JUAN PEDRO;ARRIOLA ALCIBAR ITZIAR;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;BARRONDO ARECHAGAJON;ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;CUENCA ARAMBARRI IGNACIO;DEL VILLAR DURA ANA MARIA;ARRIETA BLANCOJAVIER;CHENTO CHENTO SONIA;ESTEBAN FERNANDEZ LAURA;LOPEZ ARANGUREN GORDILLO JUAN BOSCO;REBOLLOLICEAGA JUAN CARLOS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRI GLADYS;PASTOR ZUAZAGA JAVIER JULIO;MARINRODENAS JORGE MANUEL. Datos registrales. T 5549 , F 105, S 8, H BI 167,A , I/ 2197 .(23.11.16).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PEREZ JESUS;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;URQUIDI GARCIA JAVIER;ZU脩IGABENAVIDES JUAN JOSE;CUENCA ARAMBARRI IGNACIO;DEL VILLAR DURA ANA MARIA;SAITUA IRIBAR MARTIN;INSUNZAGAMINDE PABLO;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRI GLADYS. Datosregistrales. T 5549 , F 106, S 8, H BI 167,A , I/ 2198 .(23.11.16).
Nombramientos. Apoderado: CAMARA BELLO ESTER;PUBLISI REIG SILVIA;BILBAO IBEAS ANA;SAITUA IRIBARMARTIN;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRI GLADYS. Datos registrales. T 5549 , F 106, S 8, H BI 167,A , I/ 2199.(24.11.16).
14 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: CANALES ABAITUA ASIS;OCHOA GIL BEGO脩A;ZAMARRON CASSINELLO IGNACIO;SANCHEZGALAN GARCIA TABERNERO IGNACIO;ZUMARRAGA GOROSTIZA RAMON;MARTIN BRAVO BERTA MARIA;CIFUENTESFERNANDEZ FRANCISCO;CABALLERO OCA脩A SILVIA;LOPEZ MONTERO JAVIER;ARRANZ RUBIO SONIA;RIBES HURTADOJOSE RAMON;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5549 , F102, S 8, H BI 167,A , I/ 2193 .(28.10.16).
Nombramientos. Apoderado: QUEVEDO CHAPERO ANGELA. Datos registrales. T 5549 , F 103, S 8, H BI 167,A , I/ 2194.(28.10.16).
Nombramientos. Apoderado: MARURI HERNAEZ I脩AKI;CERVANTES DOBBERTIN BEATRIZ GUIOMAR. Datos registrales. T5549 , F 104, S 8, H BI 167,A , I/ 2195 .(28.10.16).
Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ MARTINEZ JOSE LUIS;MADURGA MAYOR IDOIA;MALLO CA脩O LUIS;ALONSORODRIGUEZ I脩IGO;ZABALZA ESTEVEZ MERCEDES;SAENZ MANCEBO JOSE RAMON;VARGAS MATO CAROLINADEBORA;ALVAREZ IBA脩EZ GORKA;CANALES ABAITUA ASIS;OCHOA GIL BEGO脩A;ZAMARRON CASSINELLOIGNACIO;SANCHEZ GALAN GARCIA TABERNERO IGNACIO;TOLEDO SANCHEZ JOSU;CIFUENTES FERNANDEZFRANCISCO;CABALLERO OCA脩A SILVIA;LOPEZ MONTERO JAVIER;ARRANZ RUBIO SONIA;CANALES ABAITUA ASIS;OCHOAGIL BEGO脩A;ZAMARRON CASSINELLO IGNACIO;SANCHEZ GALAN GARCIA TABERNERO IGNACIO;TOLEDO SANCHEZJOSU;CIFUENTES FERNANDEZ FRANCISCO;CABALLERO OCA脩A SILVIA;LOPEZ MONTERO JAVIER;ARRANZ RUBIOSONIA;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5549 , F 105, S 8,H BI 167,A , I/ 2196 .( 2.11.16).
26 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: GARCIA LOPEZ JESUS;SAITUA IRIBAR MARTIN. Datos registrales. T 5549 , F 100, S 8, H BI 167,A, I/ 2192 .(19.10.16).
05 de Octubre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;INSUNZA GAMINDE PABLO;ARIAS COTERILLOFERNANDO;MIGOYA VARGAS JOSE LUIS;SAITUA IRIBAR MARTIN;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;PASTOR ZUAZAGAJAVIER;BURGUERA PEREZ IVAN;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: ELORRIAGA FERNANDEZ DE ARROYABEI脩IGO;ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL;DE ELEJOSTE ECHEBARRIA AINARA. Datos registrales. T 5549 , F 96, S 8, H BI 167,A ,I/ 2189 .(28.09.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAINZ ARMADA JOSE;AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;VITERI SOLAUN XABIER.Apo.Manc.: REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;MARTINEZ GARRIDO SANTIAGOMATIAS;CODES CALATRAVA GERARDO. Apo.Sol.: ORBEGOZO GUZMAN RAFAEL. Datos registrales. T 5549 , F 98, S 8, H BI167,A , I/ 2190 .(28.09.16).
Revocaciones. Apoderado: PRIETO HERNANDEZ CLEMENTE;ESCONDRILLAS WENCEL JUAN. Apo.Manc.: ESCONDRILLASWENCEL JUAN. Datos registrales. T 5549 , F 100, S 8, H BI 167,A , I/ 2191 .(28.09.16).
15 de Septiembre de 2016Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Madrid 122.079.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2183陋. Datos registrales. T 5549 , F 96, S 8, H BI 167,A , I/ 2188 .( 6.09.16).
12 de Septiembre de 2016Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL;ASENJO MARTIN ANTONIO;VICTORERO VIGILENRIQUE;CANALES ABAITUA IGNACIO;RODRIGUEZ ZARZALEJOS AMALIO;NAVALON BURGOS BALDOMERO;JIMENEZJIMENEZ MIGUEL ANGEL;ANDREU MERINO MARIA MAGDALENA;FERNANDEZ BILBAO BORJA;ASENJO MARTINANTONIO;VICTORERO VIGIL ENRIQUE;CANALES ABAITUA IGNACIO;RODRIGUEZ ZARZALEJOS AMALIO;NAVALON BURGOSBALDOMERO;JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL;ANDREU MERINO MARIA MAGDALENA;FERNANDEZ BILBAO BORJA;SAITUAIRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5549 , F 96, S 8, H BI 167,A , I/2187 .( 1.09.16).
30 de Agosto de 2016Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Barcelona las 122.079.000 acciones de 0,75 euros de valornominal, procedentes de la ampliaci贸n de capital de Julio de 2016 por importe de 91.559.250 euros. Datos registrales. T 5549 , F 96,S 8, H BI 167,A , I/ 2186 .(23.08.16).
26 de Agosto de 2016Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia, 122.079.000 acciones de 0,75 euros de valor nominal,procedentes de la ampliaci贸n de capital de Julio de 2016 por importe de 91.559.250 euros. Datos registrales. T 5549 , F 96, S 8, H BI167,A , I/ 2185 .(18.08.16).
18 de Agosto de 2016Otros conceptos: Admisi贸n en el Bolsa de Valores de Bilbao 122.079.000 acciones emitidas en la ampliacion de capital que motiv贸 lainscripci贸n 2183潞. Datos registrales. T 5549 , F 96, S 8, H BI 167,A , I/ 2184 .( 5.08.16).
04 de Agosto de 2016Otros conceptos: Se modifican los art铆culos 39潞 y 43潞 y la Disposici贸n Transitoria Unica del Reglamento del Consejo deAdministraci贸n. Datos registrales. T 5549 , F 87, S 8, H BI 167,A , I/ 2179 .(26.07.16).
Nombramientos. Apoderado: SAN SEBASTIAN HECHT CRISTINA. Datos registrales. T 5549 , F 88, S 8, H BI 167,A , I/ 2180.(26.07.16).
Nombramientos. Apoderado: ASENJO MARTIN ANTONIO;VICTORERO VIGIL ENRIQUE;CANALES ABAITUAIGNACIO;RODRIGUEZ ZARZALEJOS AMALIO;NAVALON BURGOS BALDOMERO;COLLADA BANDERAS ANTONIO;ANDREUMERINO MARIA MAGDALENA;FERNANDEZ BILBAO BORJA;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZTAMAYO ELENA;NAVALON BURGOS BALDOMERO;COLLADA BANDERAS ANTONIO;ANDREU MERINO MARIAMAGDALENA;FERNANDEZ BILBAO BORJA;DE LA FUENTE GARCIA IGNACIO;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRIGLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;ASENJO MARTIN ANTONIO;VICTORERO VIGIL ENRIQUE;CANALES ABAITUAIGNACIO;RODRIGUEZ ZARZALEJOS AMALIO;NAVALON BURGOS BALDOMERO;COLLADA BANDERAS ANTONIO;ANDREUMERINO MARIA MAGDALENA;FERNANDEZ BILBAO BORJA;DE LA FUENTE GARCIA IGNACIO. Datos registrales. T 5549 , F 89,S 8, H BI 167,A , I/ 2181 .(26.07.16).
Nombramientos. Apoderado: COLLADA BANDERAS ANTONIO. Datos registrales. T 5549 , F 90, S 8, H BI 167,A , I/ 2182.(26.07.16).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 91.559.250,00 Euros. Desembolsado: 91.559.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.771.559.250,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.771.559.250,00 Euros. Datos registrales. T 5549 , F 91, S 8, H BI 167,A , I/ 2183 .(28.07.16).
06 de Julio de 2016Modificaciones estatutarias. Modificados el Art铆culo 44 y la Disposici贸n Transitoria Unica del Reglamento del Consejo . Datosregistrales. T 5549 , F 86, S 8, H BI 167,A , I/ 2178 .(28.06.16).
29 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: ALCOLEA CANTOS JOSE MIGUEL;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: DEL OLMO RUIZJOSE ANTONIO. Apoderado: CODES CALATRAVA GERARDO;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;AZAGRA BLAZQUEZ PEDROJAVIER.Apo.Manc.: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO.Apo.Sol.: FUENTES-CANTILLANA ISUSI PABLO;SANCHEZ HERRERO ISABEL PATRICIA;CASTRO PEREZ-MANZUCO JOSELUIS;DE ORUETA GONZALEZ JOSE MANUEL;ROMERO IZQUIERDO JUAN. Apo.Manc.: FUENTES-CANTILLANA ISUSIPABLO;SANCHEZ HERRERO ISABEL PATRICIA;CASTRO PEREZ-MANZUCO JOSE LUIS;DE ORUETA GONZALEZ JOSEMANUEL;ROMERO IZQUIERDO JUAN;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRIGLADYS. Apo.Sol.: GARCIA RUIZ FRANCISCO DE BORJA;FERNANDEZ SAEZ ELENA. Apoderado: ALCOLEA CANTOS JOSEMIGUEL. Apo.Manc.: PERNIA OSTOLAZA JESUS MARIA. Apoderado: DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;DEL OLMO RUIZ JOSEANTONIO. Apo.Manc.: CASTRO GONZALEZ JULIO RAMON;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;DEL OLMO RUIZ JOSEANTONIO;GALAN LECUBARRI GLADYS. Apoderado: CANALES ABAITUA ASIS;SAN SEBASTIAN HECHT CRISTINA;GALANLECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZTAMAYO ELENA;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;ALCOLEA CANTOSJOSE MIGUEL;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;MAROTO YURREBASO MARIA ELENA;ORBE BENGOECHEA JESUSMARIA;ALDECOCEA ANDRES LEIRE;BARRIALES FERNANDEZ ALFONSO;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;GALAN LECUBARRIGLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;REBOLLO LICEAGAJUAN CARLOS;SAITUA IRIBAR MARTIN;FUENTES-CANTILLANA ISUSI PABLO;ESTELLA RODILLA JESUS IGNACIO;SANCHEZHERRERO ISABEL PATRICIA;CASTRO PEREZ-MANZUCO JOSE LUIS;DE ORUETA GONZALEZ JOSE MANUEL;ROMEROIZQUIERDO JUAN;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRI GLADYS;ALCOLEA CANTOS JOSE MIGUEL. Apo.Manc.:ALCOLEA CANTOS JOSE MIGUEL. Modificaci贸n de poderes. Apoderado: GOMEZ RODRIGUEZ LUIS MARIA;CANALESABAITUA ASIS;OCHOA GIL BEGO脩A;ZAMARRON CASSINELLO IGNACIO;SANCHEZ GALAN GARCIA TABERNEROIGNACIO;TOLEDO SANCHEZ JOSU;CIFUENTES FERNANDEZ FRANCISCO;CABALLERO OCA脩A SILVIA;LOPEZ MONTEROJAVIER;ARRANZ RUBIO SONIA;CASTRESANA SANCHEZ RAMON;SAINZ HERNANDEZ NOEMI;ASENJO MARTINANTONIO;VICTORERO VIGIL ENRIQUE;CANALES ABAITUA IGNACIO;RODRIGUEZ ZARZALEJOS AMALIO;NAVALON BURGOSBALDOMERO;JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL;ANDREU MERINO MARIA MAGDALENA;FERNANDEZ BILBAOBORJA;FERNANDEZ GUERRA CARLOS LUIS. Datos registrales. T 5549 , F 85, S 8, H BI 167,A , I/ 2176 .(20.06.16).
Nombramientos. Apoderado: CASTRESANA SANCHEZ RAMON;UGARRIZA CAPDEVILA ARMANDO JOSE;SAITUA IRIBARMARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5549 , F 86, S 8, H BI 167,A , I/ 2177.(21.06.16).
24 de Junio de 2016Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PEREZ JESUS;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;URQUIDI GARCIA JAVIER;CASASCHINCHURRETA PABLO;OCHOA GIL JUAN PEDRO;ARRIOLA ALCIBAR ITZIAR;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;BARRONDO
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PEREZ JESUS;ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;CUENCA ARAMBARRI IGNACIO;DELVILLAR DURA ANA MARIA. Datos registrales. T 5549 , F 84, S 8, H BI 167,A , I/ 2175 .(17.06.16).
01 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;SAITUA IRIBARMARTIN;SANCHEZ HERRERO ISABEL PATRICIA;CASTRO PEREZ-MANZUCO JOSE LUIS;DE ORUETA GONZALEZ JOSEMANUEL;ROMERO IZQUIERDO JUAN;GALLARDO CORRALES MIGUEL;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRIGLADYS;TOLEDANO LANZA MANUEL;FERNANDEZ SAEZ ELENA;JUNQUERA BLANCO ELIMENA;PEREZ SANZ ANGEL. Datosregistrales. T 5549 , F 81, S 8, H BI 167,A , I/ 2171 .(25.05.16).
Nombramientos. Apoderado: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;SANCHEZ HERRERO ISABEL;ROMERO IZQUIERDOJUAN;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;SAITUA IRIBAR MARTIN;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRIGLADYS;TOLEDANO LANZA MANUEL;FERNANDEZ SAEZ ELENA;JUNQUERA BLANCO ELIMENA;PEREZ SANZ ANGEL. Datosregistrales. T 5549 , F 82, S 8, H BI 167,A , I/ 2172 .(25.05.16).
Otros conceptos: Excluidas de la Bolsa de Madrid las 157.197000 acciones amortizadas en la reducci贸n de capital que motiv贸 lainscripci贸n 2167&. Datos registrales. T 5549 , F 83, S 8, H BI 167,A , I/ 2173 .(25.05.16).
25 de Mayo de 2016Otros conceptos: Han causado baja de la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Barcelona las 157.197.000 acciones amortizadascomo consecuencia de la reducci贸n de capital que motiv贸 la ins. 2167&. Datos registrales. T 5549 , F 81, S 8, H BI 167,A , I/ 2169.(13.05.16).
Otros conceptos: Han causado baja en la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia las 157.197.000 acciones amortizadascomo consecuencia de la reducci贸n de capital que motiv贸 la ins. 2167&. Datos registrales. T 5549 , F 81, S 8, H BI 167,A , I/ 2170.(17.05.16).
19 de Mayo de 2016Otros conceptos: Han causado baja de la negocicaci贸n de la Bolsa de Valores de Bilbao 157.197. 000 acciones amortizadas comoconsecuencia de la reducci贸n de capital que motiv贸 la Inscripci贸n 2167. Datos registrales. T 5549 , F 81, S 8, H BI 167,A , I/ 2168.(10.05.16).
09 de Mayo de 2016Nombramientos. Miem.Com.Ej.: MOREU MUNAIZ MANUEL. Datos registrales. T 5549 , F 77, S 8, H BI 167,A , I/ 2166 .(29.04.16).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO;MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN;MARTINEZ GARRIDOSANTIAGO;DE ELEJOSTE ECHEBARRIA AINARA. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 117.897.750,00 Euros. ResultanteSuscrito: 4.680.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 5549 , F 78, S 8, H BI 167,A , I/ 2167 .(29.04.16).
25 de Abril de 2016Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 5549 , F 54, S 8, H BI 167,A , I/ 2161 .(13.04.16).
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE IRALA ESTEVEZ XABIER. Miem.Com.Ej.: DE IRALA ESTEVEZ XABIER. Nombramientos.Consejero: SAGREDO ORMAZA XABIER. Reelecciones. Consejero: DE ORIOL IBARRA I脩IGO VICTOR;MACHO STADLERINES;MEDEL CAMARA BRAULIO;BARBER SAMANTHA. Datos registrales. T 5549 , F 54, S 8, H BI 167,A , I/ 2162 .(13.04.16).
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y NUEVA REDACCION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T5549 , F 55, S 8, H BI 167,A , I/ 2163 .(14.04.16).
Otros conceptos: MODIFICACION Y NUEVA REDACCION DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA. Datos registrales. T 5549 , F 65, S8, H BI 167,A , I/ 2164 .(14.04.16).
Reelecciones. Miem.Com.Ej.: MACHO STADLER INES. Datos registrales. T 5549 , F 77, S 8, H BI 167,A , I/ 2165 .(14.04.16).
29 de Marzo de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE ELEJOSTE ECHEBARRIA AINARA. Apo.Manc.: REBOLLO LICEAGA JUANCARLOS;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;BURGUERA PEREZ IVAN;MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO;ALCOLEA CANTOSJOSE MIGUEL. Datos registrales. T 5549 , F 51, S 8, H BI 167,A , I/ 2158 .(16.03.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: CHIARRI TOSCANO ANGEL JESUS;RUPEREZ GARCIA DEL CARRIZO I脩IGO;ZARAGOZA DORRISABEL. Datos registrales. T 5549 , F 53, S 8, H BI 167,A , I/ 2159 .(16.03.16).
Revocaciones. Apoderado: DE ELEJOSTE Y DE LA QUINTANA JUAN CARLOS;DE ELEJOSTE Y DE LA QUINTANA JUANCARLOS. Datos registrales. T 5549 , F 53, S 8, H BI 167,A , I/ 2160 .(16.03.16).
16 de Marzo de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ MAXI PABLO. Apoderado: ROJO SEVILLANO FELIX;MARTIN GOMEZ SANTIAGO. Apo.Sol.:ALONSO SAN JUAN JOSE ANTONIO;NIETO DEL CA脩O CARLOS. Datos registrales. T 5549 , F 44, S 8, H BI 167,A , I/ 2155 .(3.03.16).
Revocaciones. Apoderado: ARRIOLA ALCIBAR ITZIAR;CASAS CHINCHURRETA PABLO;DE LA FUENTE LECANDA MARIA;DE LASOTA ORTUZAR KOSTKA;EDESA VERDE VANESSA;GUTIERREZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER;LEZANA VISUSLUIS;MARTINEZ PEREZ JESUS;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;OCHOA GIL JUAN PEDRO;REAL DE ASUA GUINEAIGNACIO;URQUIDI GARCIA JAVIER;ZUAZAGA SASTRE DAVID;ARRIETA BLANCO JAVIER;HERRERO NAVASSANTIAGO;IZQUIERDO PUMAR MARTA;LOPEZ-ARANGUREN GORDILLO BOSCO;SANCHEZ MAXI PABLO;ZU脩IGA BENAVIDESJUAN JOSE;AGUIRRE UZQUIANO GREGORIO;ARBERAS MONTOYA ITZIAR;ARETXALDE UGARTETXE AITOR;ARIASCOTERILLO FERNANDO JULIO;ARRIETA LOPEZ AINHOA;BURGUERA PEREZ IVAN;CAMARDIEL FERNANDEZ GORKA;DELOLMO RUIZ JOSE ANTONIO;DE PALACIO ALBIZU IDOIA;DIEZ ALUSTIZA ROBERTO;DORIA ELEJOSTE ADRIANA;FERNANDEZBEASCOECHEA JOSE MIGUEL;GARAYZAR ZORRILLA BORJA;GONZALEZ IZAGUIRRE I脩IGO;HERNANDO ISLA FRANCISCO
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de los art铆culos 6潞, 8, 10潞, 22潞, 23 y 26潞 asi como la disposicion transitoria unica delReglamento del Consejo de Administraci贸n.. Datos registrales. T 5549 , F 48, S 8, H BI 167,A , I/ 2157 .( 3.03.16).
08 de Marzo de 2016Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Madrid, 60.327.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2146&. Datos registrales. T 5549 , F 44, S 8, H BI 167,A , I/ 2154 .(24.02.16).
25 de Febrero de 2016Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Barcelona 60.327.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n de capital quemotiv贸 la inscripci贸n 2146. Datos registrales. T 5549 , F 43, S 8, H BI 167,A , I/ 2151 .(12.02.16).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO. Datos registrales. T 5549 , F 43, S 8, H BI 167,A , I/ 2152.(12.02.16).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia 60.327.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2146潞. Datos registrales. T 5549 , F 44, S 8, H BI 167,A , I/ 2153 .(15.02.16).
18 de Febrero de 2016Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Bilbao 60.327.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n de capital que motiv贸la inscripci贸n 2146. Datos registrales. T 5549 , F 41, S 8, H BI 167,A , I/ 2148 .(11.02.16).
Nombramientos. Apoderado: MOSO RAIGOSO AITOR;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;HERNANDO ISLA FRANCISCOJAVIER;MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO;ALCOLEA CANTOS JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 5549 , F 41, S 8, H BI 167,A , I/2149 .(11.02.16).
Revocaciones. Apoderado: VILLALBA SANCHEZ JAVIER;MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO. Datos registrales. T 5549 , F 43, S8, H BI 167,A , I/ 2150 .(11.02.16).
08 de Febrero de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 45.245.250,00 Euros. Desembolsado: 45.245.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.797.897.750,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.797.897.750,00 Euros. Datos registrales. T 5549 , F 36, S 8, H BI 167,A , I/ 2146 .(28.01.16).
Revocaciones. Apoderado: MORA GRANADOS TOMAS BITO;URIBARRI CHACON BEATRIZ. Apo.Manc.: VITERI SOLAUNXABIER;MARRA RODRIGUEZ JOSE ANGEL;ORIOL HOYOS JOSE;CANALES ABAITUA PABLO;ASTIZ BARRENECHEAUNAI;CALVO HERNANDEZ CESAR;DE LA PE脩A CARRETON JORGE;TARANCO ZABALA ENEKO. Apo.Sol.: VITERI SOLAUNXABIER;MARRA RODRIGUEZ JOSE ANGEL;ORIOL HOYOS JOSE. Apo.Manc.: PRIMO TERROBA CARLOS. Apoderado: PRIMOTERROBA CARLOS. Datos registrales. T 5549 , F 42, S 8, H BI 167,A , I/ 2147 .(29.01.16).
04 de Febrero de 2016Nombramientos. Apoderado: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;SAITUA IRIBARMARTIN;SANCHEZ HERRERO ISABEL PATRICIA;CASTRO PEREZ-MANZUCO JOSE LUIS;DE ORUETA GONZALEZ JOSE
11 de Enero de 2016Otros conceptos: Modificados los art铆culos 8潞, 26潞 y 28潞 del Reglamento del Consejo. Datos registrales. T 5549 , F 31, S 8, H BI167,A , I/ 2144 .(28.12.15).
05 de Enero de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: OZCOIDI ARAGON FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5549 , F 26, S 8, H BI 167,A , I/ 2133.(23.12.15).
Nombramientos. Apoderado: CODES CALATRAVA GERARDO;SAITUA IRIBAR MARTIN. Datos registrales. T 5549 , F 26, S 8, HBI 167,A , I/ 2134 .(23.12.15).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ RODRIGUEZ LUIS MARIA;SAITUA IRIBAR MARTIN. Datos registrales. T 5549 , F 26, S 8, HBI 167,A , I/ 2135 .(23.12.15).
Nombramientos. Apoderado: CANALES ABAITUA ASIS;SAN SEBASTIAN HECHT CRISTINA;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALANLECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5549 , F 27, S 8, H BI 167,A , I/ 2136 .(23.12.15).
Nombramientos. Apoderado: CASTRO GONZALEZ JULIO RAMON;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;SAITUA IRIBARMARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS. Datos registrales. T 5549 , F 27, S 8, H BI 167,A , I/ 2137 .(23.12.15).
Nombramientos. Apoderado: PERNIA OSTOLAZA JESUS MARIA;SAITUA IRIBAR MARTIN. Datos registrales. T 5549 , F 28, S 8,H BI 167,A , I/ 2138 .(23.12.15).
Nombramientos. Apoderado: CANALES ABAITUA ASIS;OCHOA GIL BEGO脩A;ZAMARRON CASSINELLO IGNACIO;SANCHEZGALAN GARCIA TABERNERO IGNACIO;TOLEDO SANCHEZ JOSU;CIFUENTES FERNANDEZ FRANCISCO;CABALLERO OCA脩ASILVIA;LOPEZ MONTERO JAVIER;ARRANZ RUBIO SONIA;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZTAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5549 , F 28, S 8, H BI 167,A , I/ 2139 .(23.12.15).
Nombramientos. Apoderado: CASTRESANA SANCHEZ RAMON;SAINZ HERNANDEZ NOEMI;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALANLECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5549 , F 29, S 8, H BI 167,A , I/ 2140 .(23.12.15).
Nombramientos. Apoderado: ASENJO MARTIN ANTONIO;VICTORERO VIGIL ENRIQUE;CANALES ABAITUAIGNACIO;RODRIGUEZ ZARZALEJOS AMALIO;NAVALON BURGOS BALDOMERO;JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL;ANDREUMERINO MARIA MAGDALENA;FERNANDEZ BILBAO BORJA;SAITUA IRIBAR MARTIN;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZTAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5549 , F 29, S 8, H BI 167,A , I/ 2141 .(23.12.15).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GUERRA CARLOS LUIS;SAITUA IRIBAR MARTIN. Datos registrales. T 5549 , F 30, S8, H BI 167,A , I/ 2142 .(23.12.15).
Nombramientos. Apoderado: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;SAITUA IRIBARMARTIN;FUENTES-CANTILLANA ISUSI PABLO;ESTELLA RODILLA JESUS IGNACIO;SANCHEZ HERRERO ISABELPATRICIA;CASTRO PEREZ-MANZUCO JOSE LUIS;DE ORUETA GONZALEZ JOSE MANUEL;ROMERO IZQUIERDOJUAN;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRI GLADYS. Datos registrales. T 5549 , F 30, S 8, H BI 167,A , I/ 2143.(23.12.15).
02 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: SOTO MU脩OZ EDUARDO;SOTO MU脩OZ EDUARDO. Datos registrales. T 5549 , F 25, S 8, H BI 167,A ,I/ 2132 .(25.11.15).
04 de Noviembre de 2015Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de los art铆culos 8潞 y 29潞 del Reglamento del Consejo de Administraci贸n.. Datosregistrales. T 5549 , F 21, S 8, H BI 167,A , I/ 2128 .(28.10.15).
Revocaciones. Apoderado: DELGADO MARTIN AGUSTIN;DELGADO MARTIN AGUSTIN. Datos registrales. T 5549 , F 23, S 8, HBI 167,A , I/ 2129 .(28.10.15).
Nombramientos. Apoderado: DELGADO MARTIN AGUSTIN;SAITUA IRIBAR MARTIN;DELGADO MARTIN AGUSTIN. Datosregistrales. T 5549 , F 24, S 8, H BI 167,A , I/ 2130 .(28.10.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: YARTE DEL TORO ALBERTO. Datos registrales. T 5549 , F 25, S 8, H BI 167,A , I/ 2131 .(28.10.15).
23 de Octubre de 2015Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GUERRA CARLOS LUIS;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 5549, F 20, S 8, H BI 167,A , I/ 2126 .(15.10.15).
Revocaciones. Apoderado: GIMENEZ TAMAYO ELENA;VICTORERO VIGIL ENRIQUE;ASENJO MARTIN ANTONIO;CANALESABAITUA IGNACIO;RODRIGUEZ ZARZALEJOS AMALIO;JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL;DEL OLMO RUIZ JOSEANTONIO;GALAN LECUBARRI GLADYS. Datos registrales. T 5549 , F 21, S 8, H BI 167,A , I/ 2127 .(15.10.15).
23 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apoderado: ASENJO MARTIN ANTONIO;VICTORERO VIGIL ENRIQUE;CANALES ABAITUAIGNACIO;RODRIGUEZ ZARZALEJOS AMALIO;NAVALON BURGOS BALDOMERO;JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL;ANDREUMERINO MARIA MAGDALENA;FERNANDEZ BILBAO BORJA;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;GALAN LECUBARRIGLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5549 , F 18, S 8, H BI 167,A , I/ 2124 .(16.09.15).
Revocaciones. Apo.Sol.: DOMINGUEZ ALCOVER CARLOS;BARREDO CEDRONIL MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 5549 , F19, S 8, H BI 167,A , I/ 2125 .(16.09.15).
16 de Septiembre de 2015Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ VAZQUEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 5549 , F 18, S 8, H BI 167,A , I/ 2123 .(9.09.15).
26 de Agosto de 2015Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Madrid las 96.870.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n de capital quemotiv贸 la inscripci贸n 2117&, con efectos al 29 de julio de 2015. Datos registrales. T 5549 , F 18, S 8, H BI 167,A , I/ 2122 .(17.08.15).
21 de Agosto de 2015Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la bolsa de Barcelona las 96.870.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n de capital quemotiv贸 la inscripci贸n 2117&, con efectos al 29 de julio de 2015. Datos registrales. T 5549 , F 17, S 8, H BI 167,A , I/ 2120 .(14.08.15).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la bolsa de Valencia las 96.870.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n de capital quemotiv贸 la inscripci贸n 2117&, con efectos al 29 de julio de 2015. Datos registrales. T 5549 , F 17, S 8, H BI 167,A , I/ 2121 .(14.08.15).
19 de Agosto de 2015Revocaciones. Apoderado: PINA MOURA JOAQUIM. Datos registrales. T 5549 , F 17, S 8, H BI 167,A , I/ 2118 .(10.08.15).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Bilbao 96.870.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n de capital que motiv贸la inscripci贸n 2117&. Datos registrales. T 5549 , F 17, S 8, H BI 167,A , I/ 2119 .(10.08.15).
29 de Julio de 2015Nombramientos. Apoderado: MAROTO YURREBASO MARIA ELENA;ORBE BENGOECHEA JESUS MARIA;ALDECOCEA ANDRESLEIRE;BARRIALES FERNANDEZ ALFONSO. Datos registrales. T 5549 , F 12, S 8, H BI 167,A , I/ 2115 .(20.07.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;CANALES ABAITUA ASIS;SAN SEBASTIAN HECHT CRISTINA.Apoderado: ZUMARRAGA GOROSTIZA RAMON;IGLESIAS VELASCO PABLO;OCHOA GIL BEGO脩A;LOMBIDE PALACIOSAITOR;ZAMARRON CASSINELLO IGNACIO;SANCHEZ GALAN GARCIA TABERNERO IGNACIO;SOJO CIRION JOSEIGNACIO;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRI GLADYS. Datos registrales. T 5549 , F 12, S 8, H BI 167,A , I/ 2116.(20.07.15).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 72.652.500,00 Euros. Desembolsado: 72.652.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.752.652.500,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.752.652.500,00 Euros. Datos registrales. T 5549 , F 13, S 8, H BI 167,A , I/ 2117 .(21.07.15).
08 de Julio de 2015Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 47潞 del Reglamento del Consejo de administraci贸n.. Otros conceptos:Modificaci贸n y nueva redacci贸n del Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 5549 , F 3, S 8, H BI 167,A , I/2114 .(29.06.15).
26 de Junio de 2015Nombramientos. Apoderado: ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;DOMINGUEZ CAVERO JUAN PABLO;AGUIRRE UZQUIANOGREGORIO;ARIAS COTERILLO FERNANDO JULIO;ARRIETA LOPEZ AINHOA;BURGUERA PEREZ IVAN;DEL OLMO RUIZ JOSEANTONIO;DE PALACIO ALBIZU IDOIA;DIEZ ALUSTIZA ROBERTO;FERNANDEZ BEASCOECHEA JOSE MIGUEL;GARAYZARZORRILLA BORJA;GONZALEZ IZAGUIRRE I脩IGO;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;INSUNZA GAMINDE PABLO;LUCARINISAN JOSE DANIEL;LLAMAZARES SALVADOR AINTZANE;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;MARTINEZ GUTIERREZMIGUEL;MIGOYA VARGAS JOSE LUIS;MOTA GAGO JOSEBA;OMAECHEVARRIA LEGARRA JOSE ANGEL;PASTOR ZUAZAGAJAVIER JULIO;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;SAITUA IRIBAR MARTIN;SENDIN BOREA I脩IGO;TOBAR PARDO DESANTAYANA ROCIO;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRI GLADYS. Datos registrales. T 5549 , F 2, S 8, H BI 167,A ,I/ 2112 .(17.06.15).
Revocaciones. Apoderado: IZAGUIRRE NAZAR JOSE. Modificaci贸n de poderes. Apoderado: SALAZAR BLANCO JAVIER. Datosregistrales. T 5549 , F 3, S 8, H BI 167,A , I/ 2113 .(17.06.15).
11 de Junio de 2015Otros conceptos: Se dan de baja en la negociaci贸n de valores, con fecha 7/5/2015 en la Bolsa de Valores de Madrid 148.483.000acciones de IBERDROLA S.A. amortizadas seg煤n la inscripci贸n 2097&. Datos registrales. T 5549 , F 2, S 8, H BI 167,A , I/ 2111 .(1.06.15).
03 de Junio de 2015Nombramientos. Apoderado: CANALES ABAITUA ASIS;SAN SEBASTIAN HECHT CRISTINA;DEL OLMO RUIZ JOSEANTONIO;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5231 , F 217, S 8, H BI 167,A , I/ 2103.(27.05.15).
Nombramientos. Apoderado: CANALES ABAITUA ASIS;OCHOA GIL BEGO脩A;ZAMARRON CASSINELLO IGNACIO;SANCHEZGALAN GARCIA TABERNERO IGNACIO;TOLEDO SANCHEZ JOSU;CIFUENTES FERNANDEZ FRANCISCO;CABALLERO OCA脩ASILVIA;LOPEZ MONTERO JAVIER;ARRANZ RUBIO SONIA;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;GALAN LECUBARRIGLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5231 , F 217, S 8, H BI 167,A , I/ 2104 .(27.05.15).
Nombramientos. Apoderado: VICTORERO VIGIL ENRIQUE;ASENJO MARTIN ANTONIO;CANALES ABAITUAIGNACIO;RODRIGUEZ ZARZALEJOS AMALIO;ALVAREZ VAZQUEZ JOSE MARIA;JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL;DEL OLMORUIZ JOSE ANTONIO;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5231 , F 218, S 8, H BI167,A , I/ 2105 .(27.05.15).
Nombramientos. Apoderado: MURGA TOME ALVARO;MARRODAN LORO JUAN KARIN;GONZALEZ AGRAZ NURIA;AZORINCUADRILLERO JAVIER;MARTIN MANGAS GERMAN;RODRIGUEZ FRADE ALFONSO;ZOTES GARCIA ANA ARANZAZU;ELORZAMARTIN I脩IGO;CASTRESANA SANCHEZ RAMON;SAINZ HERNANDEZ NOEMI;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;GALANLECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA. Datos registrales. T 5231 , F 220, S 8, H BI 167,A , I/ 2106 .(27.05.15).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO;ALCOLEA CANTOS JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 5231 , F222, S 8, H BI 167,A , I/ 2107 .(27.05.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ RUIZ VICTOR MANUEL;RODRIGUEZ RUIZ VICTOR MANUEL. Apo.Sol.: RODRIGUEZRUIZ VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 5231 , F 222, S 8, H BI 167,A , I/ 2108 .(27.05.15).
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ VAZQUEZ JOSE MARIA;ASENJO MARTIN ANTONIO;BASAGOITI GONZALEZ TREVILLAJAVIER;CASTRESANA SANCHEZ RAMON;DELGADO MARTIN AGUSTIN;GASSET LORING JOSE;DEL OLMO RUIZ JOSEANTONIO;CANALES ABAITUA IGNACIO;GARCIA LOPEZ JESUS;GOMEZ RODRIGUEZ LUIS MARIA;PUGLISI REIGSILVIA;JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL;MARTINEZ CID PEDRO MARIA;MURGA TOME ALVARO;MONTEJO AYALAEDUARDO;GARCIA VILLACA脩AS ANTONIO;ROLDAN SANTIAS CELIA;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYOELENA;SOJO CIRION JOSE IGNACIO;CASTRESANA SANCHEZ RAMON;MURGA TOME ALVARO;RODRIGUEZ FRADE ALFONSOMARIA;ZUBIETA JAUREGUI PEDRO FRANCISCO. Apo.Sol.: DE LA FUENTE GARCIA IGNACIO;IRASTORZA VACAPEDRO;VALLES NAVARRO CARMEN;ZABALA ALLICA RAUL CARLOS. Apo.Manc.: ALVAREZ VAZQUEZ JOSEMARIA;IRASTORZA VACA PEDRO;DE LA FUENTE GARCIA IGNACIO;VALLES NAVARRO CARMEN;ZABALA ALLICA RAULCARLOS;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS. Apoderado: ZOTES GARCIA ANA ARANZAZU. Datos registrales. T 5231 , F 223, S8, H BI 167,A , I/ 2109 .(27.05.15).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ PEREZ JESUS;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;URQUIDI GARCIA JAVIER;CASASCHINCHURRETA PABLO;OCHOA GIL JUAN PEDRO;ARRIOLA ALCIBAR ITZIAR;LUENGO TOLOSA JOSE MIGUEL;MENJON
02 de Junio de 2015Otros conceptos: Causan baja de la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia las 148.483.000 acciones amortizadas en lareducci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 2097&, con efectos del 7 de mayo de 2015,. Datos registrales. T 5231 , F 216, S 8, HBI 167,A , I/ 2102 .(22.05.15).
28 de Mayo de 2015Otros conceptos: POR SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012 Y SENTENCIA DELTRIBUNAL SUPREMO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 SE ANULAN LOS ART. 20.3, 27.1, 29.2 Y 30.1 DE ESTATUTOS YART.9.3 LETRA C) Y ART.28.2 LETRA C DEL REGLAMENTO QUE MOTIVARON LAS INS.1911 Y 1912 RESPECTIVAMENTE.Datos registrales. T 5231 , F 216, S 8, H BI 167,A , I/ 2100 .(19.05.15).
Otros conceptos: Causan baja de la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Barcelona las 148.483.000 acciones amortizadas en lareducci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 2097&, con efectos del 7 de mayo de 2015. Datos registrales. T 5231 , F 216, S 8, H BI167,A , I/ 2101 .(19.05.15).
22 de Mayo de 2015Otros conceptos: Causan baja de la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao las 148.483.000 acciones amortizadas en lareducci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 2097&, con efectos del 7 de mayo de 2015,. Datos registrales. T 5231 , F 216, S 8, HBI 167,A , I/ 2099 .(12.05.15).
Nombramientos. Vicesecret.: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO. Datos registrales. T 5231 , F 215, S 8, H BI 167,A , I/ 2098.(12.05.15).
11 de Mayo de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 111.362.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.680.000.000,00 Euros. Datos registrales. T5231 , F 213, S 8, H BI 167,A , I/ 2097 .( 4.05.15).
23 de Abril de 2015Fe de erratas: Se subsana el nombre del consejero DON JOSE WALFREDO FERNANDEZ que por error se consign贸 como D. Jos茅Walfrerdo Fern谩ndez. Datos registrales. T 5231 , F 177, S 8, H BI 167,A , I/ 2082 .(27.02.15).
17 de Abril de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: CASTRO GONZALEZ JULIO RAMON. Datos registrales. T 5231 , F 182, S 8, H BI 167,A , I/ 2092 .(8.04.15).
Nombramientos. Apo.Manc.: CASTRO GONZALEZ JULIO RAMON;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;DEL OLMO RUIZ JOSEANTONIO;GALAN LECUBARRI GLADYS. Apo.Sol.: CASTRO GONZALEZ JULIO RAMON. Datos registrales. T 5231 , F 183, S 8, HBI 167,A , I/ 2093 .( 8.04.15).
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y NUEVA REDACCION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T5231 , F 184, S 8, H BI 167,A , I/ 2094 .( 9.04.15).
Otros conceptos: MODIFICACION Y NUEVA REDACCION DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL. Datos registrales. T5231 , F 193, S 8, H BI 167,A , I/ 2095 .( 9.04.15).
Otros conceptos: MODIFICACION Y NUEVA REDACCION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datosregistrales. T 5231 , F 204, S 8, H BI 167,A , I/ 2096 .( 9.04.15).
09 de Abril de 2015Reelecciones. Consejero: ANTOLIN RAYBAUD MARIA HELENA;MARTINEZ LAGE SANTIAGO;SANCHEZ GALAN JOSEIGNACIO;SAN PEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS;ACEBES PANIAGUA ANGEL JESUS;HOLT DENISE MARY;WALFRERDOFERNANDEZ JOSE;MOREU MUNAIZ MANUEL. Datos registrales. T 5231 , F 181, S 8, H BI 167,A , I/ 2088 .(31.03.15).
Reelecciones. Presidente: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO. Con.Delegado: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO. Datosregistrales. T 5231 , F 182, S 8, H BI 167,A , I/ 2089 .(31.03.15).
Reelecciones. Miem.Com.Ej.: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO;ACEBES PANIAGUA ANGEL JESUS;SAN PEDROGUERENABARRENA JOSE LUIS. Pres.Com.Ej.: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 5231 , F 182, S 8, H BI167,A , I/ 2090 .(31.03.15).
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 5231 , F 182, S 8, H BI 167,A , I/ 2091 .(31.03.15).
26 de Marzo de 2015Nombramientos. Apoderado: ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL;DE ELEJOSTE ECHEBARRIA AINARA;ZABALZA ESTEVEZAMAYA;LUCARINI SAN JOSE DANIEL;LAPIDO LAGE MARTA. Datos registrales. T 5231 , F 180, S 8, H BI 167,A , I/ 2085.(18.03.15).
Nombramientos. Apoderado: BUSTINZA CASTRESANA MIREN KARMELE;CABALLERO HERRERIA MARINA. Datos registrales.T 5231 , F 180, S 8, H BI 167,A , I/ 2086 .(18.03.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: AGUIRRE GARABIETA JOSE LUIS. Apoderado: FERNANDEZ ABALOS LUIS CARLOS. Apo.Man.Soli:ALA脩A LATXIONDO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 5231 , F 180, S 8, H BI 167,A , I/ 2087 .(18.03.15).
Nombramientos. Apoderado: ELORRIAGA FERNANDEZ DE ARROYABE I脩IGO;ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL;DE ELEJOSTEECHEBARRIA AINARA. Datos registrales. T 5231 , F 178, S 8, H BI 167,A , I/ 2084 .(18.03.15).
10 de Marzo de 2015Revocaciones. Apoderado: MATEOS VALLES MIGUEL CELSO;GRANDA SAMA MANUEL JESUS;DIAZ RIO EDUARDO;DIEZMARTIN ANGEL;GRANADOS GARCIA RICARDO;COLL BRAUT LUIS;LOPEZ DE SANTAMARIA GIL DELGADO JULIAN;MARTINEZGILGADO SANTIAGO;FERNANDEZ CAMBLOR ANGEL;MIR FIGUEROLA ANDRES;RABASSA ASENJO MANUEL;FIGUEROLASEQUI FRANCISCO;ROCA MORELL ANTONIO;FERNANDEZ ALFARO RAFAEL. Otros conceptos: REVOCADOS los poderesconferidos a todos los abogados y procuradores, contenidos en la escritura autorizada por el notario de Bilbao, D. Jos茅 Maria ArriolaArana con fecha 29 de diciembre de 1992, n潞 4371 de su protocolo, que motiv贸 la inscripci贸n 942&. Datos registrales. T 5231 , F 168,S 8, H BI 167,A , I/ 2079 .(25.02.15).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MIGUEL AYNAT JULIO;BATTANER ARIAS SEBASTIAN. Nombramientos. Consejero:WALFRERDO FERNANDEZ JOSE;MOREU MUNAIZ MANUEL. Datos registrales. T 5231 , F 177, S 8, H BI 167,A , I/ 2082.(27.02.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: PEREZ FERNANDEZ GONZALO. Apoderado: PEREZ FERNANDEZ GONZALO. Datos registrales. T5231 , F 177, S 8, H BI 167,A , I/ 2083 .(27.02.15).
04 de Marzo de 2015Revocaciones. Apoderado: SALLE ALONSO CARLOS EMILIO. Apo.Manc.: SALLE ALONSO CARLOS EMILIO;DEL OLMO RUIZJOSE ANTONIO. Apo.Sol.: SALLE ALONSO CARLOS EMILIO. Datos registrales. T 5231 , F 168, S 8, H BI 167,A , I/ 2080.(25.02.15).
Otros conceptos: Se aprueba un nuevo texto refundido del Reglamento del Consejo. Datos registrales. T 5231 , F 169, S 8, H BI167,A , I/ 2081 .(26.02.15).
18 de Febrero de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: SALLE ALONSO CARLOS EMILIO;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO. Apo.Sol.: SALLE ALONSOCARLOS EMILIO. Datos registrales. T 5231 , F 166, S 8, H BI 167,A , I/ 2078 .(11.02.15).
11 de Febrero de 2015Nombramientos. Apoderado: GOMEZ RODRIGUEZ LUIS MARIA;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 5231 , F165, S 8, H BI 167,A , I/ 2077 .( 4.02.15).
04 de Febrero de 2015Revocaciones. Apoderado: BARBA DE VEGA LUIS FELIPE. Apo.Sol.: PEDROSA LUNA JUAN. Apoderado: GARCIA MORENOFRANCISCO GERARDO. Apo.Man.Soli: MURGA TOME ALVARO. Apo.Manc.: MURGA TOME ALVARO. Datos registrales. T 5231 ,F 163, S 8, H BI 167,A , I/ 2076 .(28.01.15).
27 de Enero de 2015Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Madrid S.A. 81.244.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la Inscripci贸n 2.067&. Datos registrales. T 5231 , F 163, S 8, H BI 167,A , I/ 2075 .(16.01.15).
22 de Enero de 2015Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia, 81.244.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2067&. Datos registrales. T 5231 , F 163, S 8, H BI 167,A , I/ 2072 .(13.01.15).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Barcelona, 81.244.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2067&. Datos registrales. T 5231 , F 163, S 8, H BI 167,A , I/ 2073 .(14.01.15).
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ-BESADA VALDES JOSE LUIS;GONZALEZ-BESADA VALDES JOSE LUIS. Datosregistrales. T 5231 , F 163, S 8, H BI 167,A , I/ 2074 .(14.01.15).
20 de Enero de 2015Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao 81.244.000 acciones emitidas mediante escritura de
08 de Enero de 2015Otros conceptos: Se modifican los Art铆culos 7, 26 y 27 del Reglamento del Consejo y se redacta nuevamente. Datos registrales. T5231 , F 152, S 8, H BI 167,A , I/ 2070 .(30.12.14).
31 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: GOMEZ RODRIGUEZ LUIS MARIA;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 5231 ,F 150, S 8, H BI 167,A , I/ 2068 .(19.12.14).
Revocaciones. Apo.Manc.: BECKER ZUAZUA FERNANDO. Apoderado: BECKER ZUAZUA FERNANDO. Apo.Manc.: BECKERZUAZUA FERNANDO. Datos registrales. T 5231 , F 152, S 8, H BI 167,A , I/ 2069 .(19.12.14).
29 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: ZUMARRAGA GOROSTIZA RAMON;IGLESIAS VELASCO PABLO;OCHOA GIL BEGO脩A;LOMBIDEPALACIOS AITOR;ZAMARRON CASSINELLO IGNACIO;SANCHEZ GALAN GARCIA TABERNERO IGNACIO;SOJO CIRION JOSEIGNACIO;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRI GLADYS. Datos registrales. T 5231 , F 145, S 8, H BI 167,A , I/ 2066.(11.12.14).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 60.933.000,00 Euros. Desembolsado: 60.933.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.791.362.250,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.791.362.250,00 Euros. Datos registrales. T 5231 , F 146, S 8, H BI 167,A , I/ 2067 .(18.12.14).
12 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apoderado: PERNIA OSTOLAZA JESUS MARIA;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 5231 , F144, S 8, H BI 167,A , I/ 2064 .(30.10.14).
Revocaciones. Apoderado: ESTELLA GOYTRE ALBERTO. Datos registrales. T 5231 , F 145, S 8, H BI 167,A , I/ 2065 .(30.10.14).
13 de Octubre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: PEDROSA LUNA JUAN;PEREZ AVILA JOSE ENRIQUE;MARTINEZ TENDERO MARIA JOSE;VIDALMOLTO RAMON JOSE;GIL AGUNDEZ EVARISTO;TEJEDA HERREROS JESUS;ALONSO SAN JUAN JOSE ANTONIO;PEREZBARRIOS JOSE LUIS;FERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS;ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA;SOTO MU脩OZEDUARDO;SOTO MU脩OZ EDUARDO;MARTINEZ ALCOBA MARIA BEGO脩A;OZCOIDI ARAGON FRANCISCO JAVIER;NIETO DELCA脩O CARLOS;BARREDO CEDRONIL MIGUEL ANGEL;BONAIL MARTINEZ FRANCISCO JAVIER;CRISOL VAZQUEZ MIGUELANGEL;GRACIA CHICHARRO JOSE MANUEL;MAROTO ALBARI脩O JOSE MARIA;SALAS TRUJILLO DIEGO. Datos registrales. T5231 , F 142, S 8, H BI 167,A , I/ 2062 .( 3.10.14).
Nombramientos. Apo.Manc.: REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;CANALES ABAITUA ASIS;SAN SEBASTIAN HECHT CRISTINA.Datos registrales. T 5231 , F 143, S 8, H BI 167,A , I/ 2063 .( 3.10.14).
23 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apoderado: ARIAS COTERILLO FERNANDO JULIO;MIGOYA VARGAS JOSE LUIS;JIMENEZ MARTINEZ JOSELUIS;MADURGA MAYOR IDOIA;MALLO CA脩O LUIS;ALONSO RODRIGUEZ I脩IGO;ZABALZA ESTEVEZ MERCEDES;SAENZMANCEBO JOSE RAMON;VARGAS MATO CAROLINA DEBORA;ALVAREZ IBA脩EZ GORKA. Datos registrales. T 5231 , F 142, S 8,H BI 167,A , I/ 2061 .(12.09.14).
21 de Agosto de 2014Revocaciones. Apoderado: MATTERN MARTINEZ MARIA JESUS. Datos registrales. T 5231 , F 141, S 8, H BI 167,A , I/ 2056.(12.08.14).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de valores de Bilbao 67.239.000 acciones emitidas mediante escritura defecha 18 de julio de 2014. Datos registrales. T 5231 , F 141, S 8, H BI 167,A , I/ 2057 .(12.08.14).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de valores de Valencia de 67.239.000 acciones emitidas mediante escritura de18 de julio de 2014. Datos registrales. T 5231 , F 141, S 8, H BI 167,A , I/ 2058 .(12.08.14).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la bolsa de valores de Madrid, 67.239.000 acciones emitidas mediante escritura defecha 18 de julio de 2014. Datos registrales. T 5231 , F 142, S 8, H BI 167,A , I/ 2059 .(12.08.14).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de valores de Barcelona, 67.239.000 acciones emitidas mediante escritura defecha 18 de julio de 2014. Datos registrales. T 5231 , F 142, S 8, H BI 167,A , I/ 2060 .(12.08.14).
30 de Julio de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 50.429.250,00 Euros. Desembolsado: 50.429.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.730.429.250,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.730.429.250,00 Euros. Datos registrales. T 5231 , F 134, S 8, H BI 167,A , I/ 2052 .(23.07.14).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;HERNANDO ISLAFRANCISCO JAVIER;MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO;ALCOLEA CANTOS JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 5231 , F 138, S 8,H BI 167,A , I/ 2053 .(23.07.14).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO;ROJO SEVILLANO FELIX;MARTIN GOMEZ SANTIAGO;PRIMOTERROBA CARLOS. Datos registrales. T 5231 , F 138, S 8, H BI 167,A , I/ 2054 .(23.07.14).
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ CORCOLES FRANCISCO. Apo.Manc.: SAN PEDRO GUERENABARRENA JOSELUIS;MARTINEZ CORCOLES FRANCISCO. Apo.Sol.: MARTINEZ CORCOLES FRANCISCO. Apoderado: MARTINEZ CORCOLESFRANCISCO. Apo.Manc.: MARTINEZ CORCOLES FRANCISCO. Datos registrales. T 5231 , F 140, S 8, H BI 167,A , I/ 2055.(23.07.14).
08 de Julio de 2014Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ PEREZ JESUS;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;ALA脩A LATXIONDO JOSEMIGUEL;URQUIDI GARCIA JAVIER;CASAS TXINTXURRETA PABLO;OCHOA GIL JUAN PEDRO;ARRIOLA ALCIBARITZIAR;LUENGO TOLOSA JOSE MIGUEL;MENJON ARIZMENDI ALBERTO;BARRONDO ARECHAGA JON;YBARRA ECHAVARRIALUIS;CHENTO CHENTO SONIA;ESTEBAN FERNANDEZ LAURA;ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;ARRIETA BLANCOJAVIER;SANCHEZ MAXI PABLO;LOPEZ-ARANGUREN GORDILLO BOSCO;INSUNZA GAMINDE PABLO;AGUIRRE UZQUIANOGREGORIO;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;BURGUERA PEREZ IVAN;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;PASTORZUAZAGA JAVIER;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;SOJO CIRION JOSE IGNACIO;FIGUEROA BAHILLO JOSE ANGEL;SAITUAIRIBAR MARTIN;CABEZUDO PUEYO MANUEL;DIEZ ALUSTIZA ROBERTO;ALONSO ARANA JON;DE PALACIO ALBIZUIDOIA;GARCIA PEREA JUNCAL;MARTINEZ GUTIERREZ MIGUEL;ARIAS COTERILLO FERNANDO JULIO;OMAECHEVARRIALEGARRA JOSE ANGEL;FERNANDEZ BEASCOECHEA JOSE MIGUEL;TOBAR PARDO DE SANTAYANA ROCIO;GIMENEZTAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRI GLADYS;PRIMO TERROBA CARLOS;MARTIN GOMEZ SANTIAGO;VIUDES SIMORAMON;JIMENEZ MARTINEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ PEREZ JESUS;REAL DE ASUA GUINEAIGNACIO;ALA脩A LATXIONDO JOSE MIGUEL;URQUIDI GARCIA JAVIER;CASAS CHINCHURRETA PABLO;OCHOA GIL JUANPEDRO;ARRIOLA ALCIBAR ITZIAR;LUENGO TOLOSA JOSE MIGUEL;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;BARRONDO ARECHAGAJON;YBARRA ECHAVARRIA LUIS;CHENTO CHENTO SONIA;ESTEBAN FERNANDEZ LAURA;GUTIERREZ CASTELLANOSFRANCISCO JAVIER;DE LA FUENTE LECANDA MARIA;ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;ARRIETA BLANCO JAVIER;SANCHEZ
Otros conceptos: Se modifican los Art铆culos 26.6 y 27 del Reglamento del Consejo y se redacta nuevamente. Datos registrales. T5231 , F 123, S 8, H BI 167,A , I/ 2049 .(27.06.14).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ CORCOLES FRANCISCO. Datos registrales. T 5231 , F 131, S 8, H BI 167,A , I/ 2050.(27.06.14).
Revocaciones. Apoderado: SAN PEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS. Datos registrales. T 5231 , F 133, S 8, H BI 167,A , I/2051 .(27.06.14).
11 de Junio de 2014Otros conceptos: Excluidas 133.467.000 acciones de la Bolsa de Valores de Valencia. Datos registrales. T 5231 , F 119, S 8, H BI167,A , I/ 2045 .( 2.06.14).
Otros conceptos: Excluidas 133.467.000 acciones de negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Madrid. Datos registrales. T 5231 , F119, S 8, H BI 167,A , I/ 2046 .( 2.06.14).
30 de Mayo de 2014Otros conceptos: Excluidas de la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Barcelona, 133.467.000 acciones. Datos registrales. T5231 , F 119, S 8, H BI 167,A , I/ 2044 .(20.05.14).
22 de Mayo de 2014Otros conceptos: Modificados los art铆culos 7, 25, 26 y 28 del Reglamento del Consejo de Administraci贸n y redactado nuevamentedicho Reglamento. Datos registrales. T 5231 , F 110, S 8, H BI 167,A , I/ 2042 .(12.05.14).
Otros conceptos: Excluidas de la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao, 133.467.000 acciones. Datos registrales. T 5231 ,F 119, S 8, H BI 167,A , I/ 2043 .(14.05.14).
16 de Mayo de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 100.100.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.680.000.000,00 Euros. Datos registrales. T5231 , F 108, S 8, H BI 167,A , I/ 2041 .( 7.05.14).
30 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL. Datos registrales. T 5231 , F 108, S 8, H BI 167,A , I/ 2040.(23.04.14).
24 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: ELORZA MARTIN I脩IGO. Datos registrales. T 5231 , F 108, S 8, H BI 167,A , I/ 2039 .(11.04.14).
15 de Abril de 2014Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Madrid, 133.492.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 2029&. Datos registrales. T 5231 , F 105, S 8, H BI 167,A , I/ 2035 .( 3.04.14).
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 5231 , F 105, S 8, H BI 167,A , I/ 2036 .( 4.04.14).
Reelecciones. Consejero: KESSEL MARTINEZ GEORGINA YAMILET. Datos registrales. T 5231 , F 105, S 8, H BI 167,A , I/ 2037 .(4.04.14).
Modificaciones estatutarias. Se modifican los art铆culos 34潞 y 44潞 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 5231 , F 105, S 8,H BI 167,A , I/ 2038 .( 4.04.14).
26 de Marzo de 2014Revocaciones. Apoderado: RUIZ GONZALEZ RICARDO JOSE. Datos registrales. T 5231 , F 104, S 8, H BI 167,A , I/ 2034.(19.03.14).
24 de Febrero de 2014Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia 133.492.000 acciones emitidas mediante escritura de29 de enero de 2014. Datos registrales. T 5231 , F 104, S 8, H BI 167,A , I/ 2031 .(17.02.14).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la bolsa de valores de Barcelona, 133.492.000 acciones emitidas mediante escritua de29 de enero de 2014. Datos registrales. T 5231 , F 104, S 8, H BI 167,A , I/ 2032 .(17.02.14).
18 de Febrero de 2014Otros conceptos: Se admiten a cotizaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao las 133.492.000 acciones de la Sociedad de esta hojaemitida en la ampliaci贸n de capital de la ins. 2.029潞. Datos registrales. T 5231 , F 104, S 8, H BI 167,A , I/ 2030 .(10.02.14).
11 de Febrero de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 100.119.000,00 Euros. Desembolsado: 100.119.000,00 Euros. Resultante Suscrito:4.780.100.250,00 Euros. Resultante Desembolsado: 4.780.100.250,00 Euros. Datos registrales. T 5231 , F 100, S 8, H BI 167,A , I/2029 .(30.01.14).
06 de Febrero de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: ESTELLA RODILLA JESUS IGNACIO. Apo.Sol.: ESTELLA RODILLA JESUS IGNACIO. Apo.Manc.:ESTELLA RODILLA JESUS IGNACIO. Datos registrales. T 5231 , F 99, S 8, H BI 167,A , I/ 2027 .(30.01.14).
Nombramientos. Apoderado: SAINZ HERNANDEZ NOEMI. Datos registrales. T 5231 , F 99, S 8, H BI 167,A , I/ 2028 .(30.01.14).
09 de Enero de 2014Otros conceptos: Se modifica parcialmente el Reglamento del Consejo de Administraci贸n y se aprueba un nuevo texto refundido delmismo. Datos registrales. T 5231 , F 92, S 8, H BI 167,A , I/ 2026 .(30.12.13).
03 de Enero de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;AZAGRA BLAZQUEZ PEDROJAVIER;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS. Apoderado: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO. Apo.Manc.: ALCOLEA CANTOS JOSEMIGUEL. Apo.Sol.: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER. Datos registrales. T 5231 , F 92, S 8, H BI 167,A , I/ 2025 .(26.12.13).
05 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER. Apo.Manc.: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;REBOLLOLICEAGA JUAN CARLOS;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO. Apo.Sol.: ESTELLA RODILLA JESUS IGNACIO;FUENTESCANTILLANA ISUSI PABLO;SANCHEZ HERRERO ISABEL PATRICIA;CASTRO PEREZ-MANZUCO JOSE LUIS;DE ORUETAGONZALEZ JOSE MANUEL;ROMERO IZQUIERDO JUAN. Apo.Manc.: FUENTES CANTILLANA ISUSI PABLO;ESTELLA RODILLAJESUS IGNACIO;SANCHEZ HERRERO ISABEL PATRICIA;CASTRO PEREZ-MANZUCO JOSE LUIS;DE ORUETA GONZALEZJOSE MANUEL;ROMERO IZQUIERDO JUAN;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;GIMENEZ TAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRIGLADYS. Apo.Sol.: GARCIA RUIZ FRANCISCO DE BORJA;FERNANDEZ SAEZ ELENA;DOMINGUEZ ALCOVER CARLOS. Datosregistrales. T 5231 , F 88, S 8, H BI 167,A , I/ 2024 .(27.11.13).
26 de Septiembre de 2013Nombramientos. Apoderado: ZOTES GARCIA ANA ARANZAZU. Datos registrales. T 5231 , F 88, S 8, H BI 167,A , I/ 2023.(18.09.13).
11 de Septiembre de 2013Otros conceptos: Se admiten a cotizaci贸n en la BOLSA DE VALORES DE MADRID,SA 109.539.416 acciones de la Sociedad deesta Hoja emitidas enla ampliaci贸n de capital de la inscripci贸n 2.016&. Datos registrales. T 5231 , F 88, S 8, H BI 167,A , I/ 2022.(29.08.13).
21 de Agosto de 2013Otros conceptos: Se admiten a contizaci贸n en la Bolsa de Valores de Barcelona las 109.539.416 acciones de la sociedad de estahoja, emitidas en la ampliaci贸n de capital de la inscripci贸n 2016&. Datos registrales. T 5231 , F 88, S 8, H BI 167,A , I/ 2021 .(9.08.13).
16 de Agosto de 2013Nombramientos. Miem.Com.Ej.: ACEBES PANIAGUA ANGEL JESUS. Datos registrales. T 5231 , F 87, S 8, H BI 167,A , I/ 2017 .(7.08.13).
Revocaciones. Apoderado: MORRAS ZUAZO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5231 , F 87, S 8, H BI 167,A , I/ 2018 .(7.08.13).
Otros conceptos: Con efectos 26 de julio de 2013 se admiten a cotizaci贸n la Bolsa de Valencia las 109.539.416 acciones deIberdrola, S.A.de la ampliaci贸n de capital de la inscripci贸n 2016&. Datos registrales. T 5231 , F 87, S 8, H BI 167,A , I/ 2019 .(8.08.13).
Otros conceptos: SE ADMITE A COTIZACION EN LA BOLSA DE BILBAO LAS 109.539.416 ACCIONES EMITIDAS EN LAAMPLIACION DE CAPITAL DE LA INSCRIPCION 2016. Datos registrales. T 5231 , F 87, S 8, H BI 167,A , I/ 2020 .( 8.08.13).
30 de Julio de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 82.154.562,00 Euros. Desembolsado: 82.154.562,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.679.981.250,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.679.981.250,00 Euros. Datos registrales. T 5231 , F 82, S 8, H BI 167,A , I/ 2016 .(23.07.13).
04 de Julio de 2013Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PEREZ JESUS;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;ALA脩A LATXIONDO JOSEMIGUEL;URQUIDI GARCIA JAVIER;CASAS TXINTXURRETA PABLO;OCHOA GIL JUAN PEDRO;ARRIOLA ALCIBARITZIAR;LUENGO TOLOSA JOSE MIGUEL;MENJON ARIZMENDI ALBERTO;BARRONDO ARECHAGA JON;YBARRA ECHAVARRIALUIS;CHENTO CHENTO SONIA;ESTEBAN FERNANDEZ LAURA;ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;ARRIETA BLANCOJAVIER;SANCHEZ MAXI PABLO;LOPEZ-ARANGUREN GORDILLO BOSCO;INSUNZA GAMINDE PABLO;AGUIRRE UZQUIANOGREGORIO;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;BURGUERA PEREZ IVAN;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;PASTORZUAZAGA JAVIER;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;SOJO CIRION JOSE IGNACIO;FIGUEROA BAHILLO JOSE ANGEL;SAITUAIRIBAR MARTIN;CABEZUDO PUEYO MANUEL;DIEZ ALUSTIZA ROBERTO;ALONSO ARANA JON;DE PALACIO ALBIZUIDOIA;GARCIA PEREA JUNCAL;MARTINEZ GUTIERREZ MIGUEL;ARIAS COTERILLO FERNANDO JULIO;OMAECHEVARRIALEGARRA JOSE ANGEL;FERNANDEZ BEASCOECHEA JOSE MIGUEL;TOBAR PARDO DE SANTAYANA ROCIO;GIMENEZTAMAYO ELENA;GALAN LECUBARRI GLADYS;PRIMO TERROBA CARLOS;MARTIN GOMEZ SANTIAGO;VIUDES SIMORAMON;JIMENEZ MARTINEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 5231 , F 80, S 8, H BI 167,A , I/ 2014 .(26.06.13).
Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO;MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN. Apo.Manc.: SAINZARMADA JOSE;MARTINEZ PEREZ JESUS;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;ALA脩A LATXIONDO JOSE MIGUEL;URQUIDIGARCIA JAVIER;CASAS TXINTXURRETA PABLO;OCHOA GIL JUAN PEDRO;ARRIOLA ALCIBAR ITZIAR;LUENGO TOLOSA JOSEMIGUEL;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;BARRONDO ARECHAGA JON;ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;ARRIETA BLANCO
26 de Junio de 2013Otros conceptos: Rectificaci贸n del DNI del Apoderado PABLO SANCHEZ MAXI, siewndo el correcto 51976158-E. Datosregistrales. T 5231 , F 79, S 8, H BI 167,A , I/ 2010 .(14.06.13).
Otros conceptos: Como consecuencia de la reducci贸n de capital acordada el 22-5-2013 causan baja en la cotizacion en la Bolsa deValores de Barcelona, 150.748.416 acciones de 0,75 euros de valor nominal cada una. Datos registrales. T 5231 , F 79, S 8, H BI167,A , I/ 2011 .(14.06.13).
Otros conceptos: Como consecuencia de la reduccion de capital acordada el 22-5-2013 causan baja en la cotizacion en la Bolsa deValores de Madrid, 150.748.416 acciones de 0,75 euros de valor nominal cada una. Datos registrales. T 5231 , F 80, S 8, H BI 167,A, I/ 2012 .(14.06.13).
Otros conceptos: Con efectos del 30/05/2013 se procedi贸 a dar de baja de la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia,150.748.416 acciones amortizadas en escritura de fecha 23/05/2013. Datos registrales. T 5231 , F 80, S 8, H BI 167,A , I/ 2013.(18.06.13).
18 de Junio de 2013Otros conceptos: Baja de la negociaci贸n en la Bolsa de Bilbao de 150.748.416acciones como consecuencia de la reducci贸n decapital de 113.061.312 euros, mediante la amortizaci贸n de 150.748.416 acciones, que motiv贸 la 2008 Inscripci贸n,. Datos registrales.T 5231 , F 79, S 8, H BI 167,A , I/ 2009 .( 7.06.13).
04 de Junio de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 113.061.312,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.597.826.688,00 Euros. Datos registrales. T5231 , F 77, S 8, H BI 167,A , I/ 2008 .(24.05.13).
22 de Mayo de 2013Nombramientos. Consejero: KESSEL MARTINEZ GEORGINA YAMILET. Datos registrales. T 5231 , F 76, S 8, H BI 167,A , I/ 2007.(10.05.13).
09 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: URRUTIA VALLEJO VICTOR. Vicpres C.E: URRUTIA VALLEJO VICTOR. Consejero: URRUTIAVALLEJO VICTOR. Miem.Com.Ej.: URRUTIA VALLEJO VICTOR. Datos registrales. T 5231 , F 76, S 8, H BI 167,A , I/ 2006.(26.04.13).
24 de Abril de 2013Revocaciones. Apoderado: JIMENO HIERRO I脩IGO. Datos registrales. T 5231 , F 76, S 8, H BI 167,A , I/ 2005 .(16.04.13).
10 de Abril de 2013Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 5231 , F 73, S 8, H BI 167,A , I/ 2001 .(26.03.13).
Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL. Reelecciones. Consejero: LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL. Datos registrales. T 5231 , F 74, S 8, H BI 167,A , I/ 2002 .(26.03.13).
Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 6潞, 39潞, 42潞 y 43潞 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 5231 , F 74,S 8, H BI 167,A , I/ 2003 .(26.03.13).
Otros conceptos: Modificados los art. 23潞 y 24潞 del Reglamento del consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 5231 , F 75, S 8,H BI 167,A , I/ 2004 .(26.03.13).
21 de Febrero de 2013Nombramientos. Apoderado: DELGADO MARTIN AGUSTIN. Datos registrales. T 5231 , F 73, S 8, H BI 167,A , I/ 2000 .(13.02.13).
14 de Febrero de 2013Otros conceptos: Admitidas a cotizaci贸n en la Bolsa de Madrid las 142.291.000 acciones de valor nominal 0.75 euros, de laampliaci贸n quemotiv贸 la inscripci贸n 1991&. Datos registrales. T 5231 , F 71, S 8, H BI 167,A , I/ 1995 .( 6.02.13).
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 5231 , F 71, S 8, H BI 167,A , I/ 1996 .(6.02.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: MENJON ERIZMENDI ALBERTO;ESTEBAN FERNANDEZ LAURA;ALONSO OSEGUERASILVIA;SANCHEZ MAXI PABLO. Datos registrales. T 5231 , F 72, S 8, H BI 167,A , I/ 1997 .( 6.02.13).
Nombramientos. Apoderado: DELGADO MARTIN AGUSTIN. Datos registrales. T 5231 , F 72, S 8, H BI 167,A , I/ 1998 .( 6.02.13).
Otros conceptos: ADMITIDAS A COTIZACION EN LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA LAS 142.291.000 ACCIONES DEVALOR NOMINAL 0,75 EUROS, DE LA AMPLIACION QUE MOTIVO LA INSCRIPCION 1991潞. Datos registrales. T 5231 , F 73, S 8,H BI 167,A , I/ 1999 .( 7.02.13).
12 de Febrero de 2013Otros conceptos: Admitidas a cotizaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao las142.291.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 1.991&.- Datos registrales. T 5231 , F 72, S 8, H BI 167,A , I/ 1993 .( 1.02.13).
Otros conceptos: Admitidas a cotizaci贸n en Bolsa de Valencia las 142.291.000de la ampliaci贸n que motiv贸 la inscripci贸n 1991&.Datos registrales. T 5231 , F 71, S 8, H BI 167,A , I/ 1994 .( 1.02.13).
31 de Enero de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 106.718.250,00 Euros. Desembolsado: 106.718.250,00 Euros. Resultante Suscrito:4.710.888.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 4.710.888.000,00 Euros. Datos registrales. T 5231 , F 66, S 8, H BI 167,A , I/1991 .(22.01.13).
Nombramientos. Apoderado: ITURRIA MALFATTI RICHARD;BASAGOITI MIRANDA I脩IGO. Datos registrales. T 5231 , F 70, S 8,H BI 167,A , I/ 1992 .(23.01.13).
18 de Enero de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ CORCOLES FRANCISCO;PEREZ FERNANDEZ GONZALO;SAINZ ARMADA JOSE;DELVALLE DOBLADO JOSE LUIS;SAN PEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;MARTINEZGARRIDO SANTIAGO;ALCOLEA CANTOS JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 4757 , F 166, S 8, H BI 167,A , I/ 1879 .(19.05.10).
04 de Enero de 2013Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 1潞, 22潞 y 27潞 del Reglamento del Consejo de Administraci贸n 1.. Datosregistrales. T 5231 , F 65, S 8, H BI 167,A , I/ 1990 .(26.12.12).
31 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: DE LA FUENTE GARCIA IGNACIO;VALLES NAVARRO CARMEN. Datos registrales. T 5231 , F 64, S 8,H BI 167,A , I/ 1989 .(21.12.12).
16 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apoderado: SAINZ ARMADA JOSE. Datos registrales. T 5231 , F 64, S 8, H BI 167,A , I/ 1988 .( 5.11.12).
15 de Octubre de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: DE LA FUENTE GARCIA IGNACIO;IRASTORZA VACA PEDRO;VALLES NAVARRO CARMEN;ZABALAALLICA RAUL CARLOS. Datos registrales. T 5231 , F 62, S 8, H BI 167,A , I/ 1986 .( 3.10.12).
Nombramientos. Apo.Manc.: BECKER ZUAZUA FERNANDO;ALVAREZ VAZQUEZ JOSE MARIA;IRASTORZA VACA PEDRO;DELA FUENTE GARCIA IGNACIO;VALLES NAVARRO CARMEN;ZABALA ALLICA RAUL CARLOS;REBOLLO LICEAGA JUANCARLOS;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;GALAN LECUBARRI GLADYS;OCHOA RENOBALES FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 5231 , F 63, S 8, H BI 167,A , I/ 1987 .( 3.10.12).
01 de Octubre de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: CASTRESANA SANCHEZ RAMON;MURGA TOME ALVARO. Datos registrales. T 5231 , F 61, S 8, HBI 167,A , I/ 1985 .(19.09.12).
26 de Septiembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: PONS ALCOY FRANCISCO. Miem.Com.Ej.: PONS ALCOY FRANCISCO. Nombramientos.Consejero: LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL. Miem.Com.Ej.: LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL. Datos registrales. T5231 , F 60, S 8, H BI 167,A , I/ 1984 .(14.09.12).
19 de Septiembre de 2012Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Bilbao con fecha 26 de Julio de 2012 las 166.028.000 acciones emitidas enla ampliaci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 1978&. Datos registrales. T 5231 , F 60, S 8, H BI 167,A , I/ 1983 .(10.09.12).
14 de Septiembre de 2012Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA, SA lasacciones emitidas en la ampliaci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 1978&. Datos registrales. T 5231 , F 60, S 8, H BI 167,A , I/1982 .(27.08.12).
21 de Agosto de 2012Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Madrid con fecha 27/07/2012, las 166.028.000 acciones emitidas en laampliaci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸 1978&. Datos registrales. T 5231 , F 60, S 8, H BI 167,A , I/ 1980 .( 9.08.12).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Barcelona con fecha 26 de Julio de 2012, las 166.028.000 accionesemitidas en laampliaci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 1978&. Datos registrales. T 5231 , F 60, S 8, H BI 167,A , I/ 1981 .(9.08.12).
13 de Agosto de 2012Reelecciones. Consejero: BARBER SAMANTHA. Datos registrales. T 5231 , F 59, S 8, H BI 167,A , I/ 1979 .(28.07.12).
02 de Agosto de 2012Nombramientos. Apoderado: LASHERAS GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 5231 , F 55, S 8, H BI 167,A , I/ 1977.(19.07.12).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 124.521.000,00 Euros. Desembolsado: 124.521.000,00 Euros. Resultante Suscrito:4.604.169.750,00 Euros. Resultante Desembolsado: 4.604.169.750,00 Euros. Datos registrales. T 5231 , F 55, S 8, H BI 167,A , I/1978 .(23.07.12).
18 de Julio de 2012Reelecciones. Consejero: DE IRALA ESTEVEZ XABIER;DE ORIOL IBARRA I脩IGO VICTOR;MACHO STADLER INES;MEDELCAMARA BRAULIO. Datos registrales. T 5231 , F 49, S 8, H BI 167,A , I/ 1970 .( 5.07.12).
Reelecciones. Consejero: PONS ALCOY FRANCISCO. Datos registrales. T 5231 , F 50, S 8, H BI 167,A , I/ 1971 .( 5.07.12).
Modificaciones estatutarias. Se modifican los art铆culos 19.1, 19.4, 20.1, 20.2, 20.4, y 23.3 de los Estatutos Sociales para suadaptaci贸n a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 25/2011. Semodifican los art铆culos 24.1, 24.2 y 25.2 de losEstatutos Sociales para incluir mejoras t茅cnicas.. Datos registrales. T 5231 , F 50, S 8, H BI 167,A , I/ 1972 .( 5.07.12).
Otros conceptos: Modificaci贸n de los art铆culos 8.1, 8.3, 8.4, 9.2, 12.10 -antiguo 12.9-, 13.3, 14.1, 14.2, 28.1, 32.1 y 35.2 delReglamento de la Junta General de Accionistas y adici贸n de dos nuevos art铆culos 12.9 y 13.5. Datos registrales. T 5231 , F 51, S 8,H BI 167,A , I/ 1973 .( 5.07.12).
P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.iberdrola.com. Datos registrales. T 5231 , F 53, S 8, H BI167,A , I/ 1974 .( 5.07.12).
Reelecciones. Miem.Com.Ej.: DE IRALA ESTEVEZ XABIER;MACHO STADLER INES;PONS ALCOY FRANCISCO;SAN PEDROGUERENABARRENA JOSE LUIS. Datos registrales. T 5231 , F 53, S 8, H BI 167,A , I/ 1975 .( 5.07.12).
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 5231 , F 54, S 8, H BI 167,A , I/ 1976 .( 9.07.12).
09 de Julio de 2012Revocaciones. Apoderado: RUIZ DE MIGUEL IGNACIO. Datos registrales. T 5231 , F 49, S 8, H BI 167,A , I/ 1969 .(27.06.12).
03 de Julio de 2012Otros conceptos: Se modifican los art. 7, 18, 22 y 23 del Reglamento del Consejo. Datos registrales. T 5231 , F 48, S 8, H BI 167,A
21 de Junio de 2012Nombramientos. Consejero: PONS ALCOY FRANCISCO. Datos registrales. T 5231 , F 48, S 8, H BI 167,A , I/ 1967 .( 8.06.12).
07 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: OLIVAS MARTINEZ JOSE LUIS. Consejero: OLIVAS MARTINEZ JOSE LUIS. Datos registrales.T 5231 , F 47, S 8, H BI 167,A , I/ 1966 .(25.05.12).
31 de Mayo de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: SAN PEDRO GUERRENABARRENA JOSE LUIS;SAN PEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS;SANPEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS. Apo.Sol.: SAN PEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS. Apoderado: SAN PEDROGUERENABARRENA JOSE LUIS. Datos registrales. T 5231 , F 47, S 8, H BI 167,A , I/ 1965 .(16.05.12).
28 de Mayo de 2012Otros conceptos: RECTIFICACION EN CUANTO AL SEGUNDO APELLIDO DE DON SANTIAGOMARTIN COMO GONZALEZ,CUANDO EN REALIDAD , EL NOMBRE CORRECTO ES DON SANTIAGO MARTIN GOMEZ, OTORGADO EN LA INSCRIPCION1951潞- Datos registrales. T 5231 , F 46, S 8, H BI 167,A , I/ 1964 .(16.05.12).
23 de Mayo de 2012Otros conceptos: LA DURACION DEL MANDATO DE DON JOSE LUIS SAN PEDRO GUERENABARRENA TERMINA EL DIA 26DE MARZO DE 2015. Datos registrales. T 5231 , F 46, S 8, H BI 167,A , I/ 1962 .(10.05.12).
Otros conceptos: LA DURACION DEL MANDATO DE DON ANGEL JESUS ACEBES PANIAGUA TERMINARA EL DIA 26 DEMARZO DE 2015. Datos registrales. T 5231 , F 46, S 8, H BI 167,A , I/ 1963 .(10.05.12).
09 de Mayo de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: BUITRAGO MONTORO ANA ISABEL. Apoderado: BUITRAGO MONTORO ANA ISABEL. Datosregistrales. T 5231 , F 41, S 8, H BI 167,A , I/ 1955 .(25.04.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ ISASI RICARDO;BERROETA ECHEVARRIA JOSE IGNACIO. Miem.Com.Ej.: BERROETAECHEVARRIA JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 5231 , F 42, S 8, H BI 167,A , I/ 1956 .(26.04.12).
Nombramientos. Consejero: SAN PEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS. Miem.Com.Ej.: SAN PEDRO GUERENABARRENAJOSE LUIS. Datos registrales. T 5231 , F 42, S 8, H BI 167,A , I/ 1957 .(26.04.12).
Nombramientos. Consejero: ACEBES PANIAGUA ANGEL JESUS. Datos registrales. T 5231 , F 43, S 8, H BI 167,A , I/ 1958.(26.04.12).
Nombramientos. Apoderado: SAN PEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS. Datos registrales. T 5231 , F 43, S 8, H BI 167,A , I/1959 .(26.04.12).
Revocaciones. Apoderado: ACEBES PANIAGUA ANGEL JESUS. Datos registrales. T 5231 , F 46, S 8, H BI 167,A , I/ 1960.(26.04.12).
Revocaciones. Apoderado: EGA脩A DIAZ PARDO IGNACIO. Datos registrales. T 5231 , F 46, S 8, H BI 167,A , I/ 1961 .(26.04.12).
02 de Abril de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: TALLON YAGUEZ FERNANDO;URIBARRI MARBAN RAFAEL;ASPURU SOLOAGA ANDER;REGUARTGIMENEZ EVA;ALVAREZ RIERA VICENTE;GONZALEZ BENITO JOSE ANTONIO;MATEOS GALLEGO JUAN;BARBA DE VEGALUIS FELIPE;LOPEZ OROL VICENTE;SERRANO JOVER GONZALEZ ALFREDO;MOLINA NU脩EZ LAGOS JOSE MARIA;LOPEZMARTINEZ PRIMITIVA;ALCAZAR GARCIA ANGELES;RODRIGUEZ FRADE ALFONSO MARIA;GARCIA REYES CUEVAS JOSEMANUEL. Apo.Manc.: AGUADO MARTINEZ JESUS. Apoderado: DE LA TORRE RODRIGUEZ MARIA. Datos registrales. T 5231 , F39, S 8, H BI 167,A , I/ 1952 .(21.03.12).
Nombramientos. Apoderado: CODES CALATRAVA GERARDO;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 5231 , F40, S 8, H BI 167,A , I/ 1953 .(21.03.12).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MORENO FRANCISCO GERARDO;CODES CALATRAVA GERARDO;HERRERA PEREDAMARIA DOLORES;GARZON ORTEGA JUSTO;REYES GALLUR REGINA;GARAY IBARRECHE BORJA;DE LA TORRE RODRIGUEZMARIA. Datos registrales. T 5231 , F 40, S 8, H BI 167,A , I/ 1954 .(21.03.12).
23 de Marzo de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ CORCOLES FRANCISCO;CHIARRI TOSCANO ANGEL JESUS;SIMON BUELAJOSE;CASTRO GONZALEZ JULIO RAMON;CAMPA脩A AVILA ANDRES;ROJO SEVILLANO FELIX;MARTIN GONZALEZSANTIAGO;PRIMO TERROBA CARLOS. Datos registrales. T 5231 , F 38, S 8, H BI 167,A , I/ 1951 .(13.03.12).
12 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: PERNIA OSTOLAZA JESUS MARIA. Datos registrales. T 5231 , F 38, S 8, H BI 167,A , I/ 1950.(27.02.12).
21 de Febrero de 2012Revocaciones. Apoderado: MORALEDA MARTINEZ AMPARO. Datos registrales. T 5231 , F 38, S 8, H BI 167,A , I/ 1949 .(9.02.12).
16 de Febrero de 2012Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Barcelonalas 90.375.000 acciones emitidas por la Sociedad envirtud de escritura de fecha 19 de enero de 2012 y que motiv贸 la inscripci贸n 1924&. Datos registrales. T 5231 , F 37, S 8, H BI 167,A, I/ 1948 .( 6.02.12).
13 de Febrero de 2012Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valencia con efectosdesde el 25 de enero de 2012, las 90.375.000acciones emitidas en la ampliaci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 1942&. Datos registrales. T 5231 , F 37, S 8, H BI 167,A , I/1946 .( 2.02.12).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Madrid con efectos desde el 25 de enero de 2012, las 90.375.000 accionesemitidas en la ampliaci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 1942&. Datos registrales. T 5231 , F 37, S 8, H BI 167,A , I/ 1947 .(2.02.12).
09 de Febrero de 2012Otros conceptos: Admisi贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao de las 90.375.000acciones emitidas en la inscripci贸n 1942&. Datosregistrales. T 5231 , F 36, S 8, H BI 167,A , I/ 1944 .(26.01.12).
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN;DE ELEJOSTE ECHEBARRIA AINARA;ARRIETAGARRAMIOLA MIGUEL. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN;ARRIETA GARRAMIOLAMIGUEL;DE ELEJOSTE ECHEBARRIA AINARA. Datos registrales. T 5231 , F 37, S 8, H BI 167,A , I/ 1945 .(27.01.12).
02 de Febrero de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: VELASCO GOMEZ PEDRO. Apoderado: VELASCOGOMEZ PEDRO. Datos registrales. T 5231 , F 32, S 8, H BI 167,A , I/ 1941 .(18.01.12).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 67.781.250,00 Euros. Desembolsado: 67.781.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.479.648.750,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.479.648.750,00 Euros. Datos registrales. T 5231 , F 32, S 8, H BI 167,A , I/ 1942 .(20.01.12).
09 de Enero de 2012Otros conceptos: Nueva redacci贸n del Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 5231 , F 24, S 8, H BI167,A , I/ 1940 .(28.12.11).
21 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ VAZQUEZ JOSE MARIA;ASENJO MARTIN ANTONIO;BASAGOITI GONZALEZ TREVILLAJAVIER;CASTRESANA SANCHEZ RAMON;DELGADO MARTIN AGUSTIN;GASSET LORING JOSE;GONZALEZ-BESADA VALDESJOSE LUIS;MORRAS ZUAZO FRANCISCO JAVIER;DE LA TORRE RODRIGUEZ MARIA;DEL OLMO RUIZ JOSEANTONIO;CANALES ABAITUA IGNACIO;FERNANDEZ ABALOS LUIS CARLOS;GARCIA LOPEZ JESUS;GOMEZ RODRIGUEZ LUISMARIA;PUGLISI REIG SILVIA;JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL;MARTINEZ CID PEDRO MARIA;MURGA TOMEALVARO;MONTEJO AYALA EDUARDO;GARCIA VILLACA脩AS ANTONIO;ROLDAN SANTIAS CELIA;JIMENO HIERROI脩IGO;GALAN LECUBARRI GLADYS;GIMENEZ TAMAYO ELENA;SOJO CIRION JOSE IGNACIO;CASTRESANA SANCHEZRAMON;MATTERN MARTINEZ MARIA JESUS;MURGA TOME ALVARO;RODRIGUEZ FRADE ALFONSO MARIA;RUIZ DE MIGUELIGNACIO;ZUBIETA JAUREGUI PEDRO FRANCISCO. Datos registrales. T 5231 , F 20, S 8, H BI 167,A , I/ 1938 .( 7.12.11).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN;DE ELEJOSTE ECHEBARRIA AINARA;ARRIETAGARRAMIOLA MIGUEL. Datos registrales. T 5231 , F 24, S 8, H BI 167,A , I/ 1939 .( 7.12.11).
16 de Noviembre de 2011Otros conceptos: Queda modificado el art铆culo 28.4 del Reglamento del Consejo. Datos registrales. T 5231 , F 18, S 8, H BI 167,A ,I/ 1935 .( 3.11.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANALES ABAITUA ASIS. Apo.Manc.: REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;HERNANDO ISLAFRANCISCO JAVIER;PASTOR ZUAZAGA JAVIER;BURGUERA PEREZ IVAN;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;SAITUA IRIBARMARTIN;IZAGUIRRE NAZAR JOSE;ROJO SEVILLANO FELIX;ESCONDRILLAS WENCEL JUAN;GABARRON COMASALFONSO;INSUNZA GAMINDE PABLO;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;MARTINEZ ATIENZA ANTONIO;CANALES ABAITUAPABLO;FERNANDEZ OLMEDO RAMON ANTONIO;ALCAIN LOPEZ DANIEL;TORRES SUAU JOSE MARIA;CAPELASTEGUI SAIZEDUARDO. Datos registrales. T 5231 , F 18, S 8, H BI 167,A , I/ 1936 .( 3.11.11).
Revocaciones. Apo.Sol.: CONEJERO PEREZ ENRIQUE. Datos registrales. T 5231 , F 19, S 8, H BI 167,A , I/ 1937 .( 3.11.11).
21 de Octubre de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: SAN PEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS;MARTINEZ CORCOLES FRANCISCO. Datosregistrales. T 5231 , F 13, S 8, H BI 167,A , I/ 1932 .( 5.10.11).
Nombramientos. Apoderado: SAN PEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS;BECKER ZUAZUA FERNANDO;SAINZ ARMADAJOSE;MARTINEZ CORCOLES FRANCISCO;VILLALBA SANCHEZ JAVIER;VITERI SOLAUN XABIER;MORALEDA MARTINEZAMPARO;AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;PINA MOURA JOAQUIM;VELASCO GOMEZ PEDRO;NAVARRO NAVARROCONRADO RAMON;GONZALEZ-BESADA VALDES JOSE LUIS;PEREZ FERNANDEZ GONZALO;REBOLLO LICEAGA JUANCARLOS;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO;ALCOLEA CANTOS JOSEMIGUEL;ORBEGOZO GUZMAN RAFAEL. Datos registrales. T 5231 , F 14, S 8, H BI 167,A , I/ 1933 .( 5.10.11).
Nombramientos. Apoderado: GABARRON COMAS ALFONSO;FERNANDEZ OLMEDO RAMON ANTONIO;DEL OLMO RUIZ JOSEANTONIO;SALLE ALONSO CARLOS EMILIO;ARIAS COTERILLO FERNANDO JULIO;ROJO SEVILLANO FELIX;IZAGUIRRE NAZARJOSE;SAITUA IRIBAR MARTIN;ESCONDRILLAS WENCEL JUAN;MARTINEZ ATIENZA ANTONIO;CAPELASTEGUI SAIZEDUARDO;CANALES ABAITUA PABLO;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;BURGUERA PEREZ IVAN;PASTOR ZUAZAGAJAVIER JULIO;MARIN RODENAS JORGE MANUEL;MIGOYA VARGAS JOSE LUIS;ALCAIN LOPEZ DANIEL;TORRES SUAU JOSEMARIA;ELORRIAGA FERNANDEZ DE ARROYABE I脩IGO;ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL;DE ELEJOSTE ECHEBARRIAAINARA;DE ELEJOSTE Y DE LA QUINTANA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 5231 , F 16, S 8, H BI 167,A , I/ 1934 .( 5.10.11).
10 de Octubre de 2011Cambio de domicilio social. PLAZA EUSKADI 5 (BILBAO). Datos registrales. T 5231 , F 13, S 8, H BI 167,A , I/ 1931 .(29.09.11).
05 de Octubre de 2011Otros conceptos: ADMISION A NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE MADRID DE LAS 60.294.000. ACCIONESEMITIDAS EN LA AMPLIACION DE CAPITAL QUE MOTIVO LA INSCRIPCION 1922潞. Datos registrales. T 5231 , F 13, S 8, H BI167,A , I/ 1930 .(20.09.11).
13 de Septiembre de 2011Otros conceptos: Con fecha 5 de Agosto de 2.011 se admiten a negociaci贸n en la Bolsa de Valencia de 60.294.000 acciones deIberdrola SA. Datos registrales. T 5231 , F 12, S 8, H BI 167,A , I/ 1927 .(31.08.11).
Otros conceptos: ADMISION A NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA DE LAS 60.294.000 ACCIONESEMITIDAS EN LA AMPLIACION QUE MOTIVO LA INSCRIPCION 1.922&. Datos registrales. T 5231 , F 12, S 8, H BI 167,A , I/ 1928.(31.08.11).
Otros conceptos: BAJA DE LA NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA DE 4.224.064.900 ACCIONES DE"IBERDROLA RENOVABLES SA". Datos registrales. T 5231 , F 13, S 8, H BI 167,A , I/ 1929 .( 2.09.11).
07 de Septiembre de 2011Otros conceptos: Baja de negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao de 4.224.064.900 de "IBERDROLA RENOVABLES, SA".Datos registrales. T 5231 , F 11, S 8, H BI 167,A , I/ 1924 .(25.08.11).
Otros conceptos: Baja de negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Madrid de 4.224.064.900 acciones de "IBERDROLARENOVABLES, SA". Datos registrales. T 5231 , F 12, S 8, H BI 167,A , I/ 1925 .(29.08.11).
Otros conceptos: Baja de la negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Barcelona de 4.224.064.900 acciones de "IBERDROLARENOVABLES, SA". Datos registrales. T 5231 , F 12, S 8, H BI 167,A , I/ 1926 .(29.08.11).
30 de Agosto de 2011Otros conceptos: Admisi贸n a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao de las 60.294.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapitalque motiv贸 la Inscripci贸n 1922. Datos registrales. T 5231 , F 11, S 8, H BI 167,A , I/ 1923 .(11.08.11).
09 de Agosto de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 45.220.500,00 Euros. Desembolsado: 45.220.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.411.867.500,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.411.867.500,00 Euros. Datos registrales. T 5231 , F 8, S 8, H BI 167,A , I/ 1922 .(28.07.11).
05 de Agosto de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: SODUPE ROURE JAIME;SODUPE ROURE JAIME. Datos registrales. T 5231 , F 7, S 8, H BI 167,A , I/1921 .(26.07.11).
02 de Agosto de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO;MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN. Apo.Manc.: SAINZARMADA JOSE;MARTINEZ PEREZ JESUS;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;ALA脩A LATXIONDO JOSE MIGUEL;URQUIDIGARCIA JAVIER;CASAS TXINTXURRETA PABLO;OCHOA GIL JUAN PEDRO;ARRIOLA ALCIBAR ITZIAR;LUENGO TOLOSA JOSEMIGUEL;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;BARRONDO ARECHAGA JON;ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;ARRIETA BLANCOJAVIER;SAN PEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;DEL OLMO RUIZ JOSEANTONIO;BURGUERA PEREZ IVAN;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;PASTOR ZUAZAGA JAVIER JULIO;INSUNZAGAMINDE PABLO;AGUIRRE UZQUIANO GREGORIO;MARIN RODENAS JORGE;SAITUA IRIBAR MARTIN;SOJO CIRION JOSEIGNACIO;FIGUEROA BAHILLO JOSE ANGEL;GIMENEZ TAMAYO ELENA;ROJO SEVILLANO FELIX;IZAGUIRRE NAZARJOSE;CABEZUDO PUEYO MANUEL;DIEZ ALUSTIZA ROBERTO. Datos registrales. T 5231 , F 7, S 8, H BI 167,A , I/ 1920.(20.07.11).
22 de Julio de 2011Nombramientos. Apo.Manc.: VITERI SOLAUN XABIER;MARRA RODRIGUEZ JOSE ANGEL;ORIOL HOYOS JOSE;RODRIGUEZRUIZ VICTOR MANUEL;CANALES ABAITUA PABLO;ASTIZ BARRENECHEA UNAI;CALVO HERNANDEZ CESAR;DE LA PE脩ACARRETON JORGE;TARANCO ZABALA ENEKO. Apo.Sol.: VITERI SOLAUN XABIER;MARRA RODRIGUEZ JOSE ANGEL;ORIOLHOYOS JOSE;RODRIGUEZ RUIZ VICTOR MANUEL;BUITRAGO MONTORO ANA ISABEL. Apoderado: BUITRAGO MONTORO ANAISABEL. Datos registrales. T 5231 , F 5, S 8, H BI 167,A , I/ 1919 .(12.07.11).
21 de Julio de 2011Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: IBERDROLA RENOVABLES SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 4757 , F223, S 8, H BI 167,A , I/ 1918 .( 8.07.11).
27 de Junio de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: IBA脩EZ SIMO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4757 , F 221, S 8, H BI 167,A , I/ 1915 .(16.06.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO;MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN. Apo.Manc.: SAINZARMADA JOSE;MARTINEZ PEREZ JESUS;REAL DE ASUA GUINEA IGNACIO;ALA脩A LATXIONDO JOSE MIGUEL;URQUIDIGARCIA JAVIER;CASAS TXINTXURRETA PABLO;OCHOA GIL JUAN PEDRO;ARRIOLA ALCIBAR ITZIAR;LUENGO TOLOSA JOSEMIGUEL;MENJON ERIZMENDI ALBERTO;BARRONDO ARECHAGA JON;ZU脩IGA BENAVIDES JUAN JOSE;ARRIETA BLANCOJAVIER;SONIA CHENTO CHENTO;ESTEBAN FERNANDEZ LAURA;YBARRA ECHAVARRIA LUIS;SAN PEDROGUERENABARRENA JOSE LUIS;REBOLLO LICEAGA JUAN CARLOS;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO;BURGUERA PEREZIVAN;HERNANDO ISLA FRANCISCO JAVIER;PASTOR ZUAZAGA JAVIER JULIO;INSUNZA GAMINDE PABLO;AGUIRREUZQUIANO GREGORIO;MARIN RODENAS JORGE;SAITUA IRIBAR MARTIN;SOJO CIRION JOSE IGNACIO;FIGUEROA BAHILLOJOSE ANGEL;GIMENEZ TAMAYO ELENA;ROJO SEVILLANO FELIX;IZAGUIRRE NAZAR JOSE;CABEZUDO PUEYO MANUEL;DIEZALUSTIZA ROBERTO;MARTINEZ GUTIERREZ MIGUEL;ALONSO ARANA JON;DE PALACIO ALBIZU IDOIA;GARCIA PEREAJUNCAL. Datos registrales. T 4757 , F 221, S 8, H BI 167,A , I/ 1916 .(16.06.11).
Nombramientos. Apoderado: ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL. Datos registrales. T 4757 , F 223, S 8, H BI 167,A , I/ 1917.(16.06.11).
24 de Junio de 2011Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 4757 , F 221, S 8, H BI 167,A , I/ 1914 .(10.06.11).
09 de Junio de 2011Modificaciones estatutarias. Modificados y refundidos los estatutos sociales de la sociedad. Otros conceptos: La duraci贸n de losconsejeros ser谩 de cuatro a帽os. Datos registrales. T 4757 , F 196, S 8, H BI 167,A , I/ 1911 .(30.05.11).
Otros conceptos: Modificado y redactado nuevamente el texto articulado del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Datosregistrales. T 4757 , F 209, S 8, H BI 167,A , I/ 1912 .(30.05.11).
Otros conceptos: Modificar el apartado 1 del art铆culo 9潞 del Reglamento del Consejo de Administraci贸n y suprimida la Disposici贸nTransitoria 煤nica de dicho Reglamento. Datos registrales. T 4757 , F 220, S 8, H BI 167,A , I/ 1913 .(30.05.11).
20 de Mayo de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN. Datos registrales. T 4757 , F 196, S 8, H BI 167,A , I/ 1910.(11.05.11).
18 de Abril de 2011Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Madrid las 338.353.000 acciones que se emitieron a laampliaci贸n de capital que motiv贸 la inscripci贸n 1905&. Datos registrales. T 4757 , F 196, S 8, H BI 167,A , I/ 1909 .( 6.04.11).
07 de Abril de 2011Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Barcelonalas 338.353.000 acciones emitidas en la ampliaci贸nde capital que motiv贸 la inscripci贸n 1905&. Datos registrales. T 4757 , F 195, S 8, H BI 167,A , I/ 1907 .(29.03.11).
Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia las 338.353.000 acciones emitidas en la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 1905&. Datos registrales. T 4757 , F 195, S 8, H BI 167,A , I/ 1908 .(29.03.11).
31 de Marzo de 2011Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao 338.353.000 acciones procedentes de la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la Inscripci贸n 1905&. Datos registrales. T 4757 , F 195, S 8, H BI 167,A , I/ 1906 .(22.03.11).
24 de Marzo de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 253.764.750,00 Euros. Desembolsado: 253.764.750,00 Euros. Resultante Suscrito:4.366.647.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 4.366.647.000,00 Euros. Datos registrales. T 4757 , F 190, S 8, H BI 167,A , I/1905 .(15.03.11).
14 de Marzo de 2011Nombramientos. Apo.Manc.: SAINZ ARMADA JOSE;VELASCO GOMEZ PEDRO;DE LA FUENTE GARCIA IGNACIO;VALLESNAVARRO CARMEN;ZABALA ALLICA RAUL;BOLINCHES SANCHEZ JULIAN;BONETA BEORLEGUI JOAQUIN;RODRIGUEZ RUIZVICTOR MANUEL;VALVERDE MEGIAS PATRICIO;AGUADO MARTINEZ JESUS;RYAN MURUA EDUARDO;MARTIN AREVALILLODAVID;ICHASO CALDEVILLA ANGEL;CAAMA脩O MARTINEZ FRANCISCO DE ASIS;SODUPE ROURE JAIME;YARTE DEL TOROALBERTO;GOLVANO SACRISTAN EFIGENIO;LLARENA GONZALEZ FERNANDO;PACHECO GONZALEZ TOMAS. Datosregistrales. T 4757 , F 190, S 8, H BI 167,A , I/ 1904 .( 2.03.11).
14 de Febrero de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: CAMPA脩A AVILA ANDRES;GONZALEZ FERNANDEZ DAVID JOSE;MAIRATA COROMINAS JAIMEMARIA;YUN GARCIA PABLO LUIS. Datos registrales. T 4757 , F 189, S 8, H BI 167,A , I/ 1903 .( 3.02.11).
28 de Enero de 2011Otros conceptos: Con efectos desde el d铆a 27 de Diciembre de 2010 se admitena negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Barcelona101.979.000 acciones emitidas el 20 de Diciembre de 2010. Datos registrales. T 4757 , F 187, S 8, H BI 167,A , I/ 1898 .(17.01.11).
Otros conceptos: Con efectos desde el d铆a 27-12-2010 se admiten a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Madrid, 101.979.000acciones emitidas el 20-12-2010. Datos registrales. T 4757 , F 188, S 8, H BI 167,A , I/ 1899 .(18.01.11).
Otros conceptos: Con efectos desde el 27 de diciembre de 2010, se admiten a cotizaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia, las101.979.000 acciones de "IBERDROLA S.A", emitidas el 20 de diciembrede 2010. Datos registrales. T 4757 , F 188, S 8, H BI 167,A, I/ 1900 .(18.01.11).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DEL VALLE DOBLADO JOSE LUIS. Apo.Manc.: DEL VALLE DOBLADO JOSE LUIS. Datosregistrales. T 4757 , F 188, S 8, H BI 167,A , I/ 1901 .(19.01.11).
Nombramientos. Apo.Manc.: VIDEGAIN MURO JUAN;BORRAS ALVAREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4757 , F 188, S 8,H BI 167,A , I/ 1902 .(19.01.11).
24 de Enero de 2011Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao, 101.979.000 acciones procedentes de la ampliaci贸n decapital que motiv贸 la inscripci贸n 1895&. Datos registrales. T 4757 , F 187, S 8, H BI 167,A , I/ 1896 .(11.01.11).
31 de Diciembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 76.484.250,00 Euros. Desembolsado: 76.484.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.112.882.250,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.112.882.250,00 Euros. Datos registrales. T 4757 , F 183, S 8, H BI 167,A , I/ 1895 .(20.12.10).
13 de Diciembre de 2010Nombramientos. Apoderado: ZABALA ALLICA CARLOS RAUL. Datos registrales. T 4757 , F 176, S 8, H BI 167,A , I/ 1893.(26.11.10).
Otros conceptos: Modificaci贸n y nueva redacci贸n del Reglamento del COnsejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 4757 , F176, S 8, H BI 167,A , I/ 1894 .(26.11.10).
10 de Noviembre de 2010Nombramientos. Miem.Com.Ej.: MACHO STADLER INES. Datos registrales. T 4757 , F 175, S 8, H BI 167,A , I/ 1892 .(28.10.10).
02 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: CASTRESANA SANCHEZ RAMON;MURGA TOME ALVARO. Datos registrales. T 4757 , F 175, S 8,H BI 167,A , I/ 1891 .(20.10.10).
04 de Octubre de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: AGUIRRE GARABIETA JOSE LUIS;MAROTO YURREBASO MARIA ELENA;ORBE BENGOECHEAJESUS MARIA. Datos registrales. T 4757 , F 174, S 8, H BI 167,A , I/ 1889 .(21.09.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: DE LA FUENTE GARCIA IGNACIO;VALLES NAVARRO CARMEN. Datos registrales. T 4757 , F 174, S8, H BI 167,A , I/ 1890 .(21.09.10).
16 de Septiembre de 2010Revocaciones. Apoderado: SAN PEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS. Datos registrales. T 4040 , F 175, S 8, H BI 167,A , I/1691 .(18.02.05).
12 de Agosto de 2010Otros conceptos: Con efectos desde el 2 de Julio de 2010 se admiten a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Madrid 129.540.284acciones emitidas el 30 de Junio de 2010. Datos registrales. T 4757 , F 173, S 8, H BI 167,A , I/ 1887 .(27.07.10).
Otros conceptos: Con efectos desde el 2 de Julio de 2010 se admiten a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Barcelona129.540.284 acciones emitidas el 30 de Junio de 2010. Datos registrales. T 4757 , F 173, S 8, H BI 167,A , I/ 1888 .(27.07.10).
03 de Agosto de 2010Otros conceptos: Con efectos desde el 2 de Julio de 2010 se admiten a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia S.A.129.540.284 acciones emitidas el 30 de Junio de 2010. Datos registrales. T 4757 , F 173, S 8, H BI 167,A , I/ 1886 .(16.07.10).
26 de Julio de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ DE ARRILUCEA ECHEZARRETA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4757 , F 173, S 8, HBI 167,A , I/ 1885 .(14.07.10).
19 de Julio de 2010Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n en la Bolsa de Valores de Bilbao, 129.540.284 acciones procedentes de la ampliaci贸n decapital de 30 de Junio de 2010. Datos registrales. T 4757 , F 173, S 8, H BI 167,A , I/ 1884 .( 7.07.10).
12 de Julio de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 97.155.213,00 Euros. Desembolsado: 97.155.213,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.036.398.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 4.036.398.000,00 Euros. Datos registrales. T 4757 , F 169, S 8, H BI 167,A , I/ 1883 .( 1.07.10).
05 de Julio de 2010Nombramientos. Apoderado: GARCIA DE FUENTES CHURRUCA JAVIER. Datos registrales. T 4757 , F 169, S 8, H BI 167,A , I/1882 .(24.06.10).
25 de Junio de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESTELLA RODILLA IGNACIO. Apo.Manc.: NAVARRO NAVARRO CONRADO RAMON. Datosregistrales. T 4757 , F 166, S 8, H BI 167,A , I/ 1880 .(16.06.10).
Nombramientos. Apoderado: ANDREU MERINO MARIA MAGDALENA. Datos registrales. T 4757 , F 168, S 8, H BI 167,A , I/ 1881.(16.06.10).
17 de Mayo de 2010Nombramientos. Apoderado: ACHA ECHEVARRIA JOSE MARIA;INSUNZA GAMINDE EDUARDO;MOSO RAIGOSO AITOR;VALLEVIANA MARISA;VILLALVILLA HERAS JOSE CARLOS;CAMPA脩A AVILA ANDRES;ESCONDRILLAS WENCEL JUAN FERNANDOLUIS MARIA;ROJO SEVILLANO FELIX;TALLON YAGUEZ FERNANDO. Datos registrales. T 4757 , F 165, S 8, H BI 167,A , I/ 1878.( 5.05.10).
06 de Mayo de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO;ALCOLEA CANTOS JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 4757 , F163, S 8, H BI 167,A , I/ 1876 .(21.04.10).
Nombramientos. Apo.Sol.: ELORRIAGA FERNANDEZ DE ARROYABE I脩IGO;ARRIETA GARRAMIOLA MIGUEL;DE ELEJOSTEECHEVARRIA AINARA. Datos registrales. T 4757 , F 164, S 8, H BI 167,A , I/ 1877 .(22.04.10).
21 de Abril de 2010Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ FORNIE MIGUEL ANGEL;IZAGUIRRE NAZAR JOSE. Datos registrales. T 4757 , F 162, S8, H BI 167,A , I/ 1874 .( 7.04.10).
Nombramientos. Apoderado: BLANCO GONZALEZ PEDRO CARMELO;BLANCO GONZALEZ PEDRO CARMELO;IZAGUIRRENAZAR JOSE Datos registrales. T 4757 , F 162, S 8, H BI 167,A , I/ 1875 .( 7.04.10).
14 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: ARREGUI CIARSOLO JUAN LUIS. Consejero: ARREGUI CIARSOLO JUAN LUIS. Miem.Com.Ej.:ARREGUI CIARSOLO JUAN LUIS. Vicpres C.E: ARREGUI CIARSOLO JUAN LUIS. Datos registrales. T 4757 , F 148, S 8, H BI167,A , I/ 1868 .(29.03.10).
Nombramientos. Consejero: ANTOLIN RAYBAUD MARIA HELENA;MARTINEZ LAGE SANTIAGO. Reelecciones. Consejero:SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO;URRUTIA VALLEJO VICTOR;ALVAREZ ISASI RICARDO;BERROETA ECHEVARRIA JOSEIGNACIO;MIGUEL AYNAT JULIO;BATTANER ARIAS SEBASTIAN. Datos registrales. T 4757 , F 149, S 8, H BI 167,A , I/ 1869.(29.03.10).
Modificaciones estatutarias. Art铆culo 11. Derecho de suscripci贸n preferente y su supresi贸n.. Art铆culo 62. Liquidaci贸n de la Sociedad.. Datos registrales. T 4757 , F 153, S 8, H BI 167,A , I/ 1870 .(29.03.10).
Reelecciones. Con.Delegado: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO. Miem.Com.Ej.: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO;URRUTIAVALLEJO VICTOR;BERROETA ECHEVARRIA JOSE IGNACIO. Pres.Com.Ej.: SANCHEZ GALAN JOSE IGNACIO. Datosregistrales. T 4757 , F 161, S 8, H BI 167,A , I/ 1871 .(29.03.10).
Otros conceptos: Fijaci贸n del n煤mero de miembros del Consejo de Administraci贸n de la Sociedad en catorce. Datos registrales. T4757 , F 161, S 8, H BI 167,A , I/ 1872 .(29.03.10).
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 4757 , F 161, S 8, H BI 167,A , I/ 1873 .(31.03.10).
08 de Abril de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: URIARTE ORAA JUAN MARIA. Apo.Sol.: URIARTE ORAA JUAN MARIA. Apo.Manc.: URIARTE ORAAJUAN MARIA. Apo.Man.Soli: URIARTE ORAA JUAN MARIA. Apoderado: TEJADAS ALVAREZ RAMON. Datos registrales. T 4757 ,F 147, S 8, H BI 167,A , I/ 1866 .(24.03.10).
Revocaciones. Apo.Sol.: CORTES JARAVA GABRIEL. Apo.Manc.: FERNANDEZ BRIONES CARLOS. Apoderado: FERNANDEZBRIONES CARLOS. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ OLMEDO RAMON. Datos registrales. T 4757 , F 148, S 8, H BI 167,A , I/ 1867.(24.03.10).
15 de Marzo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: ORBEGOZO ARROYO JOSE;DE ORIOL Y LOPEZ MONTENEGRO LUCAS MARIA. Datosregistrales. T 4757 , F 147, S 8, H BI 167,A , I/ 1865 .( 3.03.10).
08 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: ZUBIETA JAUREGUI PEDRO FRANCISCO. Datos registrales. T 4757 , F 147, S 8, H BI 167,A , I/1864 .(25.02.10).
01 de Marzo de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: MURGA TOME ALVARO. Apo.Manc.: SAN PEDRO GUERENABARRENA JOSE LUIS;DEL OLMORUIZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4757 , F 146, S 8, H BI 167,A , I/ 1862 .(17.02.10).
Nombramientos. Apo.Manc.: MURGA TOME ALVARO;MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO. Datos registrales. T 4757 , F 146, S 8, HBI 167,A , I/ 1863 .(17.02.10).
15 de Febrero de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: TEJADAS ALVAREZ RAMON. Datos registrales. T 4757 , F 146, S 8, H BI 167,A , I/ 1861 .( 3.02.10).
08 de Febrero de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: ZUMARRAGA GOROSTIZA RAMON;IGLESIAS VELASCO PABLO;OCHOA GIL BEGO脩A;LOMBIDEPALACIOS AITOR;ZAMARRON CASSINELLO IGNACIO. Apo.Manc.: SOJO CIRION JOSE IGNACIO;GIMENEZ TAMAYOELENA;GALAN LECUBARRI GLADYS. Datos registrales. T 4757 , F 145, S 8, H BI 167,A , I/ 1860 .(27.01.10).
19 de Enero de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: DE LA FUENTE GARCIA IGNACIO;GOLVANO SACRISTAN EFIGENIO. Datos registrales. T 4757 , F144, S 8, H BI 167,A , I/ 1859 .( 7.01.10).
11 de Enero de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: ARIAS COTERILLO FERNANDO JULIO;JIMENEZ MARTINEZ JOSE LUIS;MIGOYA VARGAS JOSELUIS;ALONSO RODRIGUEZ I脩IGO. Datos registrales. T 4757 , F 144, S 8, H BI 167,A , I/ 1858 .(24.12.09).
30 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: PERNIA OSTOLAZA JESUS MARIA;DEL OLMO RUIZ JOSE ANTONIO. Apo.Sol.: PERNIA OSTOLAZAJESUS MARIA. Datos registrales. T 4757 , F 143, S 8, H BI 167,A , I/ 1857 .(16.12.09).
25 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: PEDROSA LUNA JUAN;PEREZ AVILA JOSE ENRIQUE;CONEJERO PEREZ ENRIQUE;VIDAL MOLTORAMON JOSE;PALACIOS CALVO ALFONSO;TEJEDA HERREROS JESUS;ALONSO SAN JUAN JOSE ANTONIO;PEREZ BARRIOSJOSE LUIS;JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL;ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA;SOTO MU脩OZ EDUARDO;MARTINEZALCOBA MARIA BEGO脩A;OZCOIDI ARAGON FRANCISCO JAVIER;NIETO DEL CA脩O CARLOS;BARREDO CEDRONIL MIGUELANGEL;PEREZ DE ARRILUCEA ECHEZARRETA FRANCISCO JAVIER;CRISOL VAZQUEZ MIGUEL ANGEL;GRACIA CHICHARROJOSE MANUEL;MAROTO ALBARI脩O JOSE MARIA. Datos registrales. T 4757 , F 143, S 8, H BI 167,A , I/ 1856 .(11.11.09).
13 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: ARIAS COTERILLO FERNANDO JULIO;JIMENEZ MARTINEZ JOSE LUIS;MIGOYA VARGAS JOSELUIS;ALONSO RODRIGUEZ I脩IGO. Datos registrales. T 4757 , F 142, S 8, H BI 167,A , I/ 1855 .(28.10.09).
04 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apoderado: IBERDROLA GENERACION SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 4757 , F 141, S 8, H BI167,A , I/ 1854 .(22.10.09).
08 de Octubre de 2009Otros conceptos: Se aprueba un nuevo texto del Reglamento del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 4757 , F 135, S8, H BI 167,A , I/ 1852 .(28.09.09).
24 de Septiembre de 2009Nombramientos. Apoderado: LASHERAS GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 4757 , F 134, S 8, H BI 167,A , I/ 1851 .(9.09.09).
17 de Septiembre de 2009Otros conceptos: ADMITIDAS A NEGOCIACION 250.000.000. ACCIONES EMITIDAS EN LA AMPLIACION DE CAPITAL DEFECHA 18 DE JUNIO DE 2009 EN LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA. Datos registrales. T 4757 , F 134, S 8, H BI 167,A ,I/ 1850 .( 7.09.09).
10 de Septiembre de 2009Revocaciones. Apo.Sol.: OLARREAGA TELLECHEA FRANCISCO. Apo.Man.Soli: SANTOS DIAZ MARIA NELIDA. Datosregistrales. T 4757 , F 134, S 8, H BI 167,A , I/ 1849 .(31.08.09).
20 de Agosto de 2009Otros conceptos: Admitidas a negociaci贸n 250.000.000 acciones emitidas en laampliaci贸n de capital Junio 2009 en la Bolsa deMadrid. Datos registrales. T 4757 , F 134, S 8, H BI 167,A , I/ 1848 .( 4.08.09).
27 de Julio de 2009Otros conceptos: Admitidas a cotizaci贸n en la Bolsa de Valores de Valencia, 250.000.000 acciones de "IBERDROLA, S.A." de 0,75euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas. Datos registrales. T 4757 , F 133, S 8, H BI 167,A ,I/ 1846 .(13.07.09).
Otros conceptos: Admitidas en negociaci贸n a la Bolsa de valores de Bilbao, 250.000000 acciones ordinarias de 0,75 eurosnominales cada una, con prima de emisi贸n de 4,55 euros por acci贸n totalmentesuscritas y desembolsadas. Datos registrales. T 4757, F 133, S 8, H BI 167,A , I/ 1847 .(14.07.09).
29 de Junio de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 187.500.000,00 Euros. Desembolsado: 187.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito:3.939.242.787,00 Euros. Resultante Desembolsado: 3.939.242.787,00 Euros. Datos registrales. T 4757 , F 129, S 8, H BI 167,A , I/1845 .(18.06.09).
12 de Junio de 2009Nombramientos. Apoderado: ELORZA MARTIN I脩IGO. Datos registrales. T 4757 , F 128, S 8, H BI 167,A , I/ 1844 .( 1.06.09).
14 de Mayo de 2009Nombramientos. Apoderado: GARCIA MORENO FRANCISCO GERARDO. Datos registrales. T 4757 , F 128, S 8, H BI 167,A , I/1843 .( 4.05.09).
07 de Mayo de 2009Nombramientos. Apoderado: MARTIN AREVALILLO DAVID. Datos registrales. T 4757 , F 126, S 8, H BI 167,A , I/ 1841.(27.04.09).
30 de Abril de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;SAN PEDRO GUERRENABARRENA JOSE LUIS;REBOLLOLICEAGA JUAN CARLOS. Apoderado: MARTINEZ GARRIDO SANTIAGO. Apo.Manc.: ALCOLEA CANTOS JOSE MIGUEL. Apo.Sol.:AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER. Datos registrales. T 4757 , F 125, S 8, H BI 167,A , I/ 1840 .(20.04.09).
15 de Abril de 2009Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 4757 , F 121, S 8, H BI 167,A , I/ 1839 .( 1.04.09).
03 de Abril de 2009Nombramientos. Apoderado: CASTRESANA SANCHEZ RAMON. Datos registrales. T 4757 , F 96, S 8, H BI 167,A , I/ 1836.(18.03.09).
Reelecciones. Consejero: BARBER SAMANTHA. Datos registrales. T 4757 , F 97, S 8, H BI 167,A , I/ 1837 .(24.03.09).
Otros conceptos: MODIFICACION PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALESSe modifica el Reglamento de la Junta. Datosregistrales. T 4757 , F 100, S 8, H BI 167,A , I/ 1838 .(24.03.09).
18 de Febrero de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: AZAGRA BLAZQUEZ PEDRO JAVIER;MARTINEZ-SIMANCAS SANCHEZ JULIAN;DEL OLMO RUIZJOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4757 , F 95, S 8, H BI 167,A , I/ 1835 .( 5.02.09).