Buscador CIF Logo

Actos BORME Iberen Renovables Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Iberen Renovables Sa

Actos BORME Iberen Renovables Sa - A47607387

Tenemos registrados 30 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Iberen Renovables Sa con CIF A47607387

馃敊 Perfil de Iberen Renovables Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Iberen Renovables Sa

08 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: SILVAN GONZALEZ MARIA;AURIA CABALLERO MARIA;CERVERA CORTEZO BEATRIZ;PALACIOSVICENTE MARIA ESTHER. Datos registrales. T 42701 , F 20, S 8, H M 755142, I/A 16 ( 1.11.23).

24 de Abril de 2023
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Datos registrales. T 42701 , F 20, S 8, H M 755142, I/A 14(17.04.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ TREJO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 42701 , F 20, S 8, H M 755142, I/A 15(17.04.23).

08 de Febrero de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORTEZON SANTACLARA JULIO. Nombramientos. Adm. Unico: PEDROSA GOMEZ ENRIQUE.Datos registrales. T 42701 , F 20, S 8, H M 755142, I/A 13 ( 1.02.23).

23 de Enero de 2023
Nombramientos. Apoderado: VILLORIA MARTINEZ MIGUEL. Datos registrales. T 42701 , F 19, S 8, H M 755142, I/A 12(16.01.23).

05 de Diciembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: BRETON LEDESMA JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 42701 , F 18, S 8, H M 755142, I/A 10(28.11.22).

Nombramientos. Apoderado: BRETON LESMES JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 42701 , F 19, S 8, H M 755142, I/A 11(28.11.22).

05 de Octubre de 2022
Otros conceptos: SE SUBSANA EL SEGUNDO APELLIDO DEL APODERADO IGNACIO BRETON, SIENDO EL CORRECTO"LESMES" Y NO "LEDESMA". Datos registrales. T 42701 , F 18, S 8, H M 755142, I/A 8M (27.09.22).

02 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: BRETON LEDESMA JOSE IGNACIO;PEDROSA GOMEZ ENRIQUE;GOMEZ REDONDO SERGIOALFONSO;GARCIA ALAJARIN PAZ. Datos registrales. T 42701 , F 17, S 8, H M 755142, I/A 8 (26.08.22).

Nombramientos. Apoderado: AGUADO AGUADO JUSTO. Datos registrales. T 42701 , F 18, S 8, H M 755142, I/A 9 (26.08.22).

04 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Datos registrales. T 42701 , F 17, S 8, H M 755142, I/A 7(26.02.22).

01 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: ROSAS RODRIGO ALMUDENA;BENITO ZAMARRIEGO MARIANO;VAZQUEZ GONZALEZ JOSEFRANCISCO Nombramientos. Apoderado: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO;GOMEZ REDONDO SERGIOALFONSO;DE LA LAMA ALCAIDE JOSE MANUEL. Datos registrales. T 42701 , F 16, S 8, H M 755142, I/A 6 (25.01.22).

05 de Enero de 2022
Cambio de domicilio social. C/ MENDEZ ALVARO 44 (MADRID). Datos registrales. T 42701 , F 15, S 8, H M 755142, I/A 5(29.12.21).

20 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: MOURILLE CASTI脩EIRAS SANTOS;PEINADO BALDRICH IRENE;DE MIGUEL CALABIA CRISTINA.Datos registrales. T 42701 , F 15, S 8, H M 755142, I/A 3 (13.12.21).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Datos registrales. T 42701 , F 15, S 8, H M 755142, I/A 4(13.12.21).

18 de Noviembre de 2021
Cambio de domicilio social. C/ GENERAL LACY 23 (MADRID). Datos registrales. T 42701 , F 15, S 8, H M 755142, I/A 2(11.11.21).

13 de Noviembre de 2019
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: REPSOL NUEVAS ENERGIAS SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZGUIJAS JOSE LUIS. Presidente: GOMEZ GUIJAS JOSE LUIS. Consejero: ZARZUELA VAQUERIZO JESUS ANGEL. Vicepresid.:ZARZUELA VAQUERIZO JESUS ANGEL. Consejero: ZARZUELA MATEOS JESUS ANGEL. Secretario: ZARZUELA MATEOS JESUSANGEL. Consejero: SOLOMON SL;GALLEGO DE LERMA TENDERO MATEO;ZARZUELA CORTIJO FELIPE. Cons.Del.Sol: GOMEZGUIJAS JOSE LUIS;ZARZUELA VAQUERIZO JESUS ANGEL. Nombramientos. Adm. Unico: CORTEZON SANTACLARA JULIO.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Modificar losESTATUTOS SOCIALES de la Sociedad, con expresa derogaci贸n de su texto anterior,. Datos registrales. T 1298 , F 209, S 8, H VA20218, I/A 12 ( 6.11.19).

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ-ACEBO MUNTA脩OLA PABLO. Datos registrales. T 1298 , F 210, S 8, H VA 20218, I/A 13 (6.11.19).

Revocaciones. Apoderado: BLANCO GONZALEZ MARIO. Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MARTINALBERTO;RODRIGUEZ GONZALEZ CESAR RUFINO. Datos registrales. T 1564 , F 175, S 8, H VA 20218, I/A 14 ( 6.11.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: BLANCO GONZALEZ MARIO;REGUERA GIGANTO FERNANDO. Datos registrales. T 1564 , F 175, S8, H VA 20218, I/A 15 ( 6.11.19).

Nombramientos. Apo.Manc.: VAZQUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO;BENITO ZAMARRIEGO MARIANO;ROSAS RODRIGOALMUDENA;SEIJAS UZQUIZA IGNACIO. Datos registrales. T 1564 , F 175, S 8, H VA 20218, I/A 16 ( 6.11.19).

12 de Junio de 2019
Reelecciones. Consejero: GOMEZ GUIJAS JOSE LUIS. Presidente: GOMEZ GUIJAS JOSE LUIS. Consejero: ZARZUELAVAQUERIZO JESUS ANGEL. Vicepresid.: ZARZUELA VAQUERIZO JESUS ANGEL. Consejero: ZARZUELA MATEOS JESUSANGEL. Secretario: ZARZUELA MATEOS JESUS ANGEL. Consejero: SOLOMON SL;GALLEGO DE LERMA TENDEROMATEO;ZARZUELA CORTIJO FELIPE. Cons.Del.Sol: GOMEZ GUIJAS JOSE LUIS;ZARZUELA VAQUERIZO JESUS ANGEL. Datosregistrales. T 1298 , F 209, S 8, H VA 20218, I/A 11 ( 5.06.19).

22 de Abril de 2019
Nombramientos. Apoderado: BLANCO GONZALEZ MARIO. Datos registrales. T 1298 , F 187, S 8, H VA 20218, I/A 10 (11.04.19).

20 de Octubre de 2016
Reelecciones. Consejero: GOMEZ GUIJAS JOSE LUIS. Presidente: GOMEZ GUIJAS JOSE LUIS. Consejero: ZARZUELAVAQUERIZO JESUS ANGEL. Vicepresid.: ZARZUELA VAQUERIZO JESUS ANGEL. Consejero: ZARZUELA MATEOS JESUSANGEL. Secretario: ZARZUELA MATEOS JESUS ANGEL. Consejero: SOLOMON SL;GALLEGO DE LERMA TENDEROMATEO;ZARZUELA CORTIJO FELIPE. Cons.Del.Sol: GOMEZ GUIJAS JOSE LUIS;ZARZUELA VAQUERIZO JESUS ANGEL. Datosregistrales. T 1298 , F 187, S 8, H VA 20218, I/A 9 (13.10.16).

05 de Diciembre de 2012
Cambio de domicilio social. C/ GAMAZO 8 - ENTREPLANTA (VALLADOLID). Datos registrales. T 1298 , F 187, S 8, H VA 20218,I/A 8 (27.11.12).

08 de Noviembre de 2010
Ampliacion del objeto social. Objeto Social. La Sociedad tendr谩 por objeto: 1.-La producci贸n y venta de energ铆a el茅ctrica. 2.- Eldise帽o, planificaci贸n, promoci贸n, construcci贸n y explotaci贸n econ贸mica de parques e贸licos productores de energ铆a el茅ctricayfotovoltaica. 3.- La prestaci贸n y realizaci贸n de toda clase de actividades,. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: PARQUEEOLICO PARAMO DE MONTE SECO SL. Datos registrales. T 1298 , F 186, S 8, H VA 20218, I/A 7 (25.10.10).

25 de Octubre de 2010
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 385.000,00 Euros. Datos registrales. T 1298 , F 186, S 8, H VA 20218, I/A 6(14.10.10).

25 de Enero de 2010
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.100.000,00 Euros. Desembolsado: 275.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.100.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 3.275.000,00 Euros. Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 440.000,00 Euros. Datosregistrales. T 1298 , F 98, S 8, H VA 20218, I/A 5 (14.01.10).

10 de Julio de 2009
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 500.000,00 Euros. Datos registrales. T 1298 , F 97, S 8, H VA 20218, I/A 4 (1.07.09).

24 de Junio de 2009
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 1298 , F 97, S 8, H VA 20218, I/A 3(15.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n