Actos BORME de Iberen Renovables Sa
08 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SILVAN GONZALEZ MARIA;AURIA CABALLERO MARIA;CERVERA CORTEZO BEATRIZ;PALACIOSVICENTE MARIA ESTHER. Datos registrales. T 42701 , F 20, S 8, H M 755142, I/A 16 ( 1.11.23).
24 de Abril de 2023Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Datos registrales. T 42701 , F 20, S 8, H M 755142, I/A 14(17.04.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ TREJO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 42701 , F 20, S 8, H M 755142, I/A 15(17.04.23).
08 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORTEZON SANTACLARA JULIO. Nombramientos. Adm. Unico: PEDROSA GOMEZ ENRIQUE.Datos registrales. T 42701 , F 20, S 8, H M 755142, I/A 13 ( 1.02.23).
23 de Enero de 2023Nombramientos. Apoderado: VILLORIA MARTINEZ MIGUEL. Datos registrales. T 42701 , F 19, S 8, H M 755142, I/A 12(16.01.23).
05 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: BRETON LEDESMA JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 42701 , F 18, S 8, H M 755142, I/A 10(28.11.22).
Nombramientos. Apoderado: BRETON LESMES JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 42701 , F 19, S 8, H M 755142, I/A 11(28.11.22).
05 de Octubre de 2022Otros conceptos: SE SUBSANA EL SEGUNDO APELLIDO DEL APODERADO IGNACIO BRETON, SIENDO EL CORRECTO"LESMES" Y NO "LEDESMA". Datos registrales. T 42701 , F 18, S 8, H M 755142, I/A 8M (27.09.22).
02 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apoderado: BRETON LEDESMA JOSE IGNACIO;PEDROSA GOMEZ ENRIQUE;GOMEZ REDONDO SERGIOALFONSO;GARCIA ALAJARIN PAZ. Datos registrales. T 42701 , F 17, S 8, H M 755142, I/A 8 (26.08.22).
Nombramientos. Apoderado: AGUADO AGUADO JUSTO. Datos registrales. T 42701 , F 18, S 8, H M 755142, I/A 9 (26.08.22).
04 de Marzo de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Datos registrales. T 42701 , F 17, S 8, H M 755142, I/A 7(26.02.22).
01 de Febrero de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: ROSAS RODRIGO ALMUDENA;BENITO ZAMARRIEGO MARIANO;VAZQUEZ GONZALEZ JOSEFRANCISCO Nombramientos. Apoderado: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO;GOMEZ REDONDO SERGIOALFONSO;DE LA LAMA ALCAIDE JOSE MANUEL. Datos registrales. T 42701 , F 16, S 8, H M 755142, I/A 6 (25.01.22).
05 de Enero de 2022Cambio de domicilio social. C/ MENDEZ ALVARO 44 (MADRID). Datos registrales. T 42701 , F 15, S 8, H M 755142, I/A 5(29.12.21).
20 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: MOURILLE CASTI脩EIRAS SANTOS;PEINADO BALDRICH IRENE;DE MIGUEL CALABIA CRISTINA.Datos registrales. T 42701 , F 15, S 8, H M 755142, I/A 3 (13.12.21).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Datos registrales. T 42701 , F 15, S 8, H M 755142, I/A 4(13.12.21).
18 de Noviembre de 2021Cambio de domicilio social. C/ GENERAL LACY 23 (MADRID). Datos registrales. T 42701 , F 15, S 8, H M 755142, I/A 2(11.11.21).
13 de Noviembre de 2019Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: REPSOL NUEVAS ENERGIAS SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZGUIJAS JOSE LUIS. Presidente: GOMEZ GUIJAS JOSE LUIS. Consejero: ZARZUELA VAQUERIZO JESUS ANGEL. Vicepresid.:ZARZUELA VAQUERIZO JESUS ANGEL. Consejero: ZARZUELA MATEOS JESUS ANGEL. Secretario: ZARZUELA MATEOS JESUSANGEL. Consejero: SOLOMON SL;GALLEGO DE LERMA TENDERO MATEO;ZARZUELA CORTIJO FELIPE. Cons.Del.Sol: GOMEZGUIJAS JOSE LUIS;ZARZUELA VAQUERIZO JESUS ANGEL. Nombramientos. Adm. Unico: CORTEZON SANTACLARA JULIO.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Modificar losESTATUTOS SOCIALES de la Sociedad, con expresa derogaci贸n de su texto anterior,. Datos registrales. T 1298 , F 209, S 8, H VA20218, I/A 12 ( 6.11.19).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ-ACEBO MUNTA脩OLA PABLO. Datos registrales. T 1298 , F 210, S 8, H VA 20218, I/A 13 (6.11.19).
Revocaciones. Apoderado: BLANCO GONZALEZ MARIO. Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MARTINALBERTO;RODRIGUEZ GONZALEZ CESAR RUFINO. Datos registrales. T 1564 , F 175, S 8, H VA 20218, I/A 14 ( 6.11.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: BLANCO GONZALEZ MARIO;REGUERA GIGANTO FERNANDO. Datos registrales. T 1564 , F 175, S8, H VA 20218, I/A 15 ( 6.11.19).
Nombramientos. Apo.Manc.: VAZQUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO;BENITO ZAMARRIEGO MARIANO;ROSAS RODRIGOALMUDENA;SEIJAS UZQUIZA IGNACIO. Datos registrales. T 1564 , F 175, S 8, H VA 20218, I/A 16 ( 6.11.19).
12 de Junio de 2019Reelecciones. Consejero: GOMEZ GUIJAS JOSE LUIS. Presidente: GOMEZ GUIJAS JOSE LUIS. Consejero: ZARZUELAVAQUERIZO JESUS ANGEL. Vicepresid.: ZARZUELA VAQUERIZO JESUS ANGEL. Consejero: ZARZUELA MATEOS JESUSANGEL. Secretario: ZARZUELA MATEOS JESUS ANGEL. Consejero: SOLOMON SL;GALLEGO DE LERMA TENDEROMATEO;ZARZUELA CORTIJO FELIPE. Cons.Del.Sol: GOMEZ GUIJAS JOSE LUIS;ZARZUELA VAQUERIZO JESUS ANGEL. Datosregistrales. T 1298 , F 209, S 8, H VA 20218, I/A 11 ( 5.06.19).
22 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: BLANCO GONZALEZ MARIO. Datos registrales. T 1298 , F 187, S 8, H VA 20218, I/A 10 (11.04.19).
20 de Octubre de 2016Reelecciones. Consejero: GOMEZ GUIJAS JOSE LUIS. Presidente: GOMEZ GUIJAS JOSE LUIS. Consejero: ZARZUELAVAQUERIZO JESUS ANGEL. Vicepresid.: ZARZUELA VAQUERIZO JESUS ANGEL. Consejero: ZARZUELA MATEOS JESUSANGEL. Secretario: ZARZUELA MATEOS JESUS ANGEL. Consejero: SOLOMON SL;GALLEGO DE LERMA TENDEROMATEO;ZARZUELA CORTIJO FELIPE. Cons.Del.Sol: GOMEZ GUIJAS JOSE LUIS;ZARZUELA VAQUERIZO JESUS ANGEL. Datosregistrales. T 1298 , F 187, S 8, H VA 20218, I/A 9 (13.10.16).
05 de Diciembre de 2012Cambio de domicilio social. C/ GAMAZO 8 - ENTREPLANTA (VALLADOLID). Datos registrales. T 1298 , F 187, S 8, H VA 20218,I/A 8 (27.11.12).
08 de Noviembre de 2010Ampliacion del objeto social. Objeto Social. La Sociedad tendr谩 por objeto: 1.-La producci贸n y venta de energ铆a el茅ctrica. 2.- Eldise帽o, planificaci贸n, promoci贸n, construcci贸n y explotaci贸n econ贸mica de parques e贸licos productores de energ铆a el茅ctricayfotovoltaica. 3.- La prestaci贸n y realizaci贸n de toda clase de actividades,. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: PARQUEEOLICO PARAMO DE MONTE SECO SL. Datos registrales. T 1298 , F 186, S 8, H VA 20218, I/A 7 (25.10.10).
25 de Octubre de 2010Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 385.000,00 Euros. Datos registrales. T 1298 , F 186, S 8, H VA 20218, I/A 6(14.10.10).
25 de Enero de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.100.000,00 Euros. Desembolsado: 275.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.100.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 3.275.000,00 Euros. Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 440.000,00 Euros. Datosregistrales. T 1298 , F 98, S 8, H VA 20218, I/A 5 (14.01.10).
10 de Julio de 2009Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 500.000,00 Euros. Datos registrales. T 1298 , F 97, S 8, H VA 20218, I/A 4 (1.07.09).
24 de Junio de 2009Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 1298 , F 97, S 8, H VA 20218, I/A 3(15.06.09).