Actos BORME de Iberian Autoonline Sl
21 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: VELASCO RIVAS JAVIER. Nombramientos. Adm. Solid.: MAYO MATA JOSE LUIS. Apoderado:DOMINGUEZ GONZALEZ JULIANA;PEREZ TORRES ALINE ELISABETH. Datos registrales. T 33542 , F 138, S 8, H M 369271, I/A62 (14.09.23).
10 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: PEREZ LOPEZ JUAN LUIS. Datos registrales. T 33542 , F 137, S 8, H M 369271, I/A 58 ( 2.11.21).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: POVEDA CABALLERO ALFONSO. Nombramientos. Adm. Solid.: VELASCO RIVAS JAVIER.Datos registrales. T 33542 , F 137, S 8, H M 369271, I/A 59 ( 2.11.21).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: VELAZQUEZ NIETO EDUARDO. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ FERNANDEZ MARIAGUADALUPE;IRIARTE SOMOLINOS MARCO. Datos registrales. T 33542 , F 137, S 8, H M 369271, I/A 60 ( 2.11.21).
15 de Enero de 2021Revocaciones. Apoderado: CAÑADAS NAVARRO FRANCISCO. Apo.Man.Soli: CAÑADAS NAVARRO FRANCISCO;VELAZQUEZNIETO EDUARDO;PEREZ LOPEZ JUAN LUIS. Apo.Manc.: BALLESTEROS VAZQUEZ MARIA ELENA. Apoderado: TAPIA GORDONMARIA;GONZALEZ GORDON MARIA. Apo.Man.Soli: TAPIA GORDON MARIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: VELAZQUEZNIETO EDUARDO. Apo.Manc.: MAYO MATA JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: TAPIA GORDON MARIA;PEREZ LOPEZ JUAN LUIS.Apo.Manc.: BABIN DAVID LINDSEY;AGOSTINI ARNAUD DANIEL NICOLAS. Apo.Man.Soli: MAYO MATA JOSE LUIS;PEREZ LOPEZJUAN LUIS. Datos registrales. T 33542 , F 135, S 8, H M 369271, I/A 57 (10.01.21).
14 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BRADY JASON MICHAEL. Nombramientos. Adm. Solid.: BABIN DAVID LINDSEY. Datosregistrales. T 33542 , F 135, S 8, H M 369271, I/A 56 ( 6.10.20).
28 de Septiembre de 2020Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: AUDATEX AUTOONLINE GMBH. Datos registrales. T 33542 , F135, S 8, H M 369271, I/A 55 (21.09.20).
21 de Septiembre de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: VELASCO RIVAS JAVIER. Adm. Unico: AUDATEX ESPAÑA SA. Nombramientos. Adm. Solid.:BRADY JASON MICHAEL;POVEDA CABALLERO ALFONSO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración:
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GORDON MARIA;RODRIGUEZ ONTIVEROS JOSE LUIS. Datos registrales. T 33542 , F134, S 8, H M 369271, I/A 54 (14.09.20).
23 de Julio de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: HUERGA SANCHEZ GABRIEL. Nombramientos. Apoderado: TAPIA GORDON MARIA. Datosregistrales. T 33542 , F 134, S 8, H M 369271, I/A 52 (16.07.19).
03 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ BOUZA RUBEN. Datos registrales. T 33542 , F 133, S 8, H M 369271, I/A 51 (26.11.18).
31 de Julio de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: ROIG SANCHEZ IGNACIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: HUERGA SANCHEZ GABRIEL. Datosregistrales. T 33542 , F 133, S 8, H M 369271, I/A 50 (24.07.17).
09 de Mayo de 2017Revocaciones. Apoderado: BALLESTEROS VAZQUEZ MARIA ELENA. Apo.Manc.: BALLESTEROS VAZQUEZ MARIAELENA;MIRALLES MANRESA CARLOS. Apoderado: ROIG SANCHEZ IGNACIO. Datos registrales. T 33542 , F 133, S 8, H M369271, I/A 49 (27.04.17).
05 de Mayo de 2017Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/3. Datos registrales. T 33542 , F 133, S 8, H M 369271, I/A 48(25.04.17).
11 de Abril de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: CAÑADAS NAVARRO FRANCISCO;VELAZQUEZ NIETO EDUARDO;LOPEZ BOUZA RUBEN;ROIGSANCHEZ IGNACIO;PEREZ LOPEZ JUAN LUIS. Apo.Manc.: BALLESTEROS VAZQUEZ MARIA ELENA. Datos registrales. T 33542, F 131, S 8, H M 369271, I/A 47 ( 1.04.16).
28 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apoderado: RODRIGUES FREITAS ROSA PAULA CRISTINA. Datos registrales. T 33542 , F 131, S 8, H M 369271,I/A 46 (18.12.15).
24 de Julio de 2015Nombramientos. Apoderado: ROIG SANCHEZ IGNACIO. Datos registrales. T 20832 , F 95, S 8, H M 369271, I/A 45 (17.07.15).
26 de Febrero de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: BALLESTEROS VAZQUEZ MARIA ELENA;MIRALLES MANRESA CARLOS. Datos registrales. T20832 , F 95, S 8, H M 369271, I/A 44 (16.02.15).
12 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ SIETEIGLESIAS ANTONIO. Datos registrales. T 20832 , F 94, S 8, H M 369271, I/A 43 (4.11.14).
07 de Agosto de 2014Cambio de domicilio social. AVDA DE BRUSELAS 36 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 20832 , F 94, S 8, H M 369271, I/A 42(25.07.14).
24 de Abril de 2013Revocaciones. Apoderado: LEGUEY JIMENEZ NORBERTO MATIAS. Datos registrales. T 20832 , F 94, S 8, H M 369271, I/A 41(17.04.13).
15 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: RODRIGUES FREITAS ROSA PAULA CRISTINA. Datos registrales. T 20832 , F 94, S 8, H M369271, I/A 40 ( 5.04.13).
24 de Abril de 2012Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ ALFARO JOSE FERNANDO. Datos registrales. T 20832 , F 94, S 8, H M 369271, I/A 9(13.04.12).
27 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apoderado: CAVA MONTANER IGNACIO. Datos registrales. T 20832 , F 91, S 8, H M 369271, I/A 7 (16.12.10).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ SIETEIGLESIAS ANTONIO;CAÑADAS NAVARRO FRANCISCO;LEGUEY JIMENEZNORBERTO;BALLESTEROS VAZQUEZ MARIA ELENA;MARTINEZ ALFARO JOSE FERNANDO. Datos registrales. T 20832 , F 91,S 8, H M 369271, I/A 8 (16.12.10).
03 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SIERSLEBEN KAI. Nombramientos. Representan: VELASCO RIVAS JAVIER. Adm. Unico:AUDATEX ESPAÑA SA. Datos registrales. T 20832 , F 90, S 8, H M 369271, I/A 5 (23.08.10).
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 25. Cierre del Ejercicio.-. Ampliacion del objeto social. COMPRA YVENTA DE VEHICULOS. Datos registrales. T 20832 , F 91, S 8, H M 369271, I/A 6 (24.08.10).
04 de Febrero de 2010Cambio de domicilio social. CTRA ALCOBENDAS-BARAJAS Km 1,1 - PARQUE EMPRESARIA (ALCOBENDAS). Datosregistrales. T 20832 , F 90, S 8, H M 369271, I/A 4 (25.01.10).
01 de Febrero de 2010Declaración de unipersonalidad. Socio único: AUTOONLINE GMBH INFORMATIONSSYSTEME. Datos registrales. T 20832 , F90, S 8, H M 369271, I/A 3 (20.01.10).