Buscador CIF Logo

Actos BORME Iberian Holdings Spain Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Iberian Holdings Spain Sl

Actos BORME Iberian Holdings Spain Sl - B87654711

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Iberian Holdings Spain Sl con CIF B87654711

馃敊 Perfil de Iberian Holdings Spain Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Iberian Holdings Spain Sl

12 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: KAI ARILDSSON MARCUS. Presidente: KAI ARILDSSON MARCUS. Revocaciones. Apoderado:GAMBOA ABREU PESSEGUEIRO ALEXANDRE;DA SILVA FERREIRA FERNANDES ALEXANDRA MARIA;ESPARZA TORTOSAJOSE LUIS;MIHAESCU ANA IRINA;GALGUERA GARCIA CARLOS;ESPARZA TORTOSA JOSE LUIS;DURAO FERNANDESALEXANDRE MIGUEL;BRAVO JIMENEZ ALBERTO;DURAO FERNANDES ALEXANDRE MIGUEL;GAMBOA ABREU PESSEGUEIROALEXANDRE;SUAREZ TRAMON ENRIQUE;AGUIRREGOMEZCORTA CAUBET TATIANA;KAI ARILDSSON MARCUS;BRAVOJIMENEZ ALBERTO;DURAO FERNANDES ALEXANDRE MIGUEL. Nombramientos. Consejero: GAMBOA ABREU PESSEGUEIROALEXANDRE. Presidente: GAMBOA ABREU PESSEGUEIRO ALEXANDRE. Apoderado: BRAVO JIMENEZ ALBERTO;DURCOFERNANDES ALEXANDRE MIGUEL;GAMBOA ABREU PESSEGUEIRO ALEXANDRE;DA SILVA FERREIRA FERNANDESALEXANDRA MARIA;ESPARZA TORTOSA JOSE LUIS;MIHAESCU ANA IRINA;GALGUERA GARCIA CARLOS;GARCIA GARCIACARMEN MARIA;SUAREZ TRAMON ENRIQUE;AGUIRREGOMEZCORTA CAUBET TATIANA. Datos registrales. T 35173 , F 82, S8, H M 632481, I/A 10 ( 5.04.22).

22 de Diciembre de 2021
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SIERRA RETAIL VENTURES BV. Datos registrales. T 35173 , F82, S 8, H M 632481, I/A 9 (15.12.21).

03 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: D'HOMMEE CAUPERS PEDRO JOSE;FREITAS DUARTE VITOR MANUEL;FREITAS DUARTE VITORMANUEL. Nombramientos. Apoderado: GAMBOA ABREU PESSEGUEIRO ALEXANDRE;DA SILVA FERREIRA FERNANDESALEXANDRA MARIA;ESPARZA TORTOSA JOSE LUIS;MIHAESCU ANA IRINA;GALGUERA GARCIA CARLOS;ESPARZA TORTOSAJOSE LUIS;DURAO FERNANDES ALEXANDRE MIGUEL;BRAVO JIMENEZ ALBERTO;DURAO FERNANDES ALEXANDREMIGUEL;GAMBOA ABREU PESSEGUEIRO ALEXANDRE;SUAREZ TRAMON ENRIQUE;AGUIRREGOMEZCORTA CAUBETTATIANA;KAI ARILDSSON MARCUS;BRAVO JIMENEZ ALBERTO;DURAO FERNANDES ALEXANDRE MIGUEL. Datos registrales.T 35173 , F 80, S 8, H M 632481, I/A 8 (26.10.20).

05 de Noviembre de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANZ GIMENEZ JOSE FLORENCIO. Apo.Manc.: MATOS FERNANDES VALDEMARMEIRELES;FERRAZ FILIPA. Nombramientos. Apo.Manc.: FREITAS DUARTE VITOR MANUEL;GAMBOA ABREU PESSEGUEIROALEXANDRE;DA SILVA FERREIRA FERNANDES ALEXANDRA MARIA;ESPARZA TORTOSA JOSE LUIS;MIHAESCU ANA IRINA.Datos registrales. T 35173 , F 79, S 8, H M 632481, I/A 7 (28.10.19).

17 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: D'HOMMEE CAUPERS PEDRO JOSE. Presidente: D'HOMMEE CAUPERS PEDRO JOSE.Nombramientos. Consejero: KAI ARILDSSON MARCUS. Presidente: KAI ARILDSSON MARCUS. Datos registrales. T 35173 , F79, S 8, H M 632481, I/A 6 (10.06.19).

23 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: D'HOMMEE CAUPERS PEDRO JOSE. Apo.Man.Soli: BRAVO JIMENEZ ALBERTO;DURAOFERNANDES ALEXANDRE MIGUEL;SANZ GIMENEZ JOSE FLORENCIO;GAMBOA ABREU PESSEGUEIRO ALEXANDRE.Apo.Manc.: FREITAS DUARTE VITOR MANUEL. Apo.Sol.: SUAREZ TRAMON ENRIQUE;AGUIRREGOMEZCORTA CAUBETTATIANA. Apo.Manc.: DA SILVA FERREIRA FERNANDES ALEXANDRA MARIA;MATOS FERNANDES VALDEMARMEIRELES;FERRAZ FILIPA. Datos registrales. T 35173 , F 77, S 8, H M 632481, I/A 5 (16.11.18).

29 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: VILACA DE FARIA LELIS JOAO CARLOS. Nombramientos. Consejero: BRAVO JIMENEZALBERTO. Datos registrales. T 35173 , F 76, S 8, H M 632481, I/A 4 (21.09.17).

13 de Enero de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: D'HOMMEE CAUPERS PEDRO JOSE;VILACA DE FARIA LELIS JOAO CARLOS;DURAOFERNANDES ALEXANDRE MIGUEL;SANZ GIMENEZ JOSE FLORENCIO;GAMBOA ABREU PESSEGUEIRO ALEXANDRE;DASILVA FERREIRA FERNANDES ALEXANDRA MARIA;MATOS FERNANDES VALDEMAR MEIRELES;FREITAS DUARTE VITORMANUEL;FERRAZ FILIPA. Apo.Sol.: BRAVO JIMENEZ ALBERTO;DURAO FERNANDES ALEXANDRE MIGUEL;GAMBOA ABREUPESSEGUEIRO ALEXANDRE;SUAREZ TRAMON ENRIQUE;AGUIRREGOMEZCORTA CAUBET TATIANA;SANZ GIMENEZ JOSEFLORENCIO. Datos registrales. T 35173 , F 74, S 8, H M 632481, I/A 3 ( 5.01.17).

18 de Noviembre de 2016
Nombramientos. VsecrNoConsj: AGUIRREGOMEZCORTA CAUBET TATIANA. Presidente: D'HOMMEE CAUPERS PEDRO JOSE.Secretario: DURAO FERNANDES ALEXANDRE MIGUEL. Datos registrales. T 35173 , F 74, S 8, H M 632481, I/A 2 (10.11.16).

17 de Octubre de 2016
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 23.09.16. Objeto social: a) La promoci贸n, desarrollo, gesti贸n y explotaci贸n de actividadesrelacionadas con centros comerciales, catering, alojamiento, restaurantes, salas recreativas y zonas de ocio y de servicios en 谩reasurbanas o comerciales, parques de entretenimiento y hoteles. b) La elaboraci贸n, contrataci贸n de perso. Domicilio: C/ GOYA, N潞 22, 3潞PLANTA (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: DOS MARES SHOPPING CENTREBV. Nombramientos. Consejero: D'HOMMEE CAUPERS PEDRO JOSE;DURAO FERNANDES ALEXANDRE MIGUEL;VILACA DEFARIA LELIS JOAO CARLOS. Datos registrales. T 35173 , F 71, S 8, H M 632481, I/A 1 ( 7.10.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n