Buscador CIF Logo

Actos BORME Iberica De Almacenistas De Patatas Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Iberica De Almacenistas De Patatas Sl

Actos BORME Iberica De Almacenistas De Patatas Sl - B28041028

Tenemos registrados 8 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Iberica De Almacenistas De Patatas Sl con CIF B28041028

馃敊 Perfil de Iberica De Almacenistas De Patatas Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Iberica De Almacenistas De Patatas Sl

14 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: MADRINGES SL. Datos registrales. T 16687 , F 207, S 8, H M 10860, I/A 65 ( 5.12.23).

05 de Marzo de 2019
Cambio de domicilio social. C/ INDEPENDENCIA 4 (MADRID). Datos registrales. T 16687 , F 206, S 8, H M 10860, I/A 63(26.02.19).

Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 11 Y 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T16687 , F 206, S 8, H M 10860, I/A 64 (26.02.19).

30 de Enero de 2019
Nombramientos. SecreNoConsj: DE VICENTE-TUTOR RODRIGUEZ MANUEL. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LAINSCRIPCION 62陋 LA PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO DE DE VICENTE-TUTOR RODRIGUEZ MANUEL COMOSECRETARIO NO CONSEJERO. Datos registrales. T 16687 , F 205, S 8, H M 10860, I/A 62 (11.01.19).

18 de Enero de 2019
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PAJARES GIMENEZ MARIO. Consejero: JIMENEZ BLAZQUEZ GREGORIO. Presidente:JIMENEZ BLAZQUEZ GREGORIO. Cons.Del.Sol: JIMENEZ BLAZQUEZ GREGORIO. Nombramientos. Consejero: NIETO GARCIAANDONI;JIMENEZ BLAZQUEZ SANTIAGO;JIMENEZ BLAZQUEZ MARIA ISABEL;JIMENEZ JIMENEZ PABLO. Presidente: NU脩EZREBOLO FERNANDO. Datos registrales. T 16687 , F 205, S 8, H M 10860, I/A 62 (11.01.19).

28 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Secretario: COLLADO RODRIGUEZ RAUL. Nombramientos. SecreNoConsj: PAJARES GIMENEZ MARIO.Datos registrales. T 16687 , F 205, S 8, H M 10860, I/A 61 (19.12.16).

11 de Agosto de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 168.308,00 Euros. Resultante Suscrito: 673.232,00 Euros. Datos registrales. T 16687 , F204, S 8, H M 10860, I/A 60 (31.07.14).

14 de Abril de 2014
Reelecciones. Consejero: JIMENEZ BLAZQUEZ GREGORIO. Presidente: JIMENEZ BLAZQUEZ GREGORIO. Consejero: JIMENEZGOMEZ PABLO;NU脩EZ REBOLO FERNANDO. Cons.Del.Sol: JIMENEZ BLAZQUEZ GREGORIO;NU脩EZ REBOLOFERNANDO;JIMENEZ GOMEZ PABLO. Datos registrales. T 16687 , F 204, S 8, H M 10860, I/A 59 ( 4.04.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n