Actos BORME de Iberica De Manipulados Y Cartonajes Sa
14 de Octubre de 2019Otros conceptos: ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO. Datos registrales. T 7339 , F 138, S 8, H B72850, I/A A ( 4.10.19).
17 de Julio de 2012Cambio de domicilio social. CL GENOVA,19, PLANTA BAJA,LOCAL B (BARCELONA). Datos registrales. T 7339 , F 138, S 8, H B72850, I/A 27 ( 5.07.12).
29 de Julio de 2011Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: CONDE CERRATO RAFAEL;ACEVES LOPEZ BELEN. Nombramientos. ADM.UNICO: TATONRASH PRODUCCIONES SL. REPR.143 RRM: CONEJO DIAZ ENRIQUE. Datos registrales. T 7339 , F 138, S 8, H B 72850, I/A 25(20.07.11).
Revocaciones. APODERADO: PELETEIRO GOMEZ REINO ANTONIO. Datos registrales. T 7339 , F 138, S 8, H B 72850, I/A 26(20.07.11).
09 de Mayo de 2011Revocaciones. ADM.UNICO: CONDE CERRATO RAFAEL. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: CONDE CERRATORAFAEL;ACEVES LOPEZ BELEN. Datos registrales. T 7339 , F 135, S 8, H B 72850, I/A 23 (21.04.11).
Nombramientos. APODERADO: PELETEIRO GOMEZ REINO ANTONIO. Datos registrales. T 7339 , F 135, S 8, H B 72850, I/A 24(21.04.11).
04 de Abril de 2011Revocaciones. ADM.UNICO: CORNELIS VAN DEN BERG BLOM. Nombramientos. ADM.UNICO: CONDE CERRATO RAFAEL.Datos registrales. T 7339 , F 135, S 8, H B 72850, I/A 22 (23.03.11).
03 de Enero de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 60.120,00 Euros. Desembolsado: 60.120,00 Euros. Resultante Suscrito: 120.240,00 Euros.Resultante Desembolsado: 120.240,00 Euros. Datos registrales. T 7339 , F 134, S 8, H B 72850, I/A 21 (21.12.10).