Buscador CIF Logo

Actos BORME Iberica De Patatas Selectas Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Iberica De Patatas Selectas Sociedad Limitada

Actos BORME Iberica De Patatas Selectas Sociedad Limitada - B82935974

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Iberica De Patatas Selectas Sociedad Limitada con CIF B82935974

馃敊 Perfil de Iberica De Patatas Selectas Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Iberica De Patatas Selectas Sociedad Limitada

16 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Auditor: EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE SL. Datos registrales. T 25134 , F 210, S 8, H M277310, I/A 37 ( 8.11.23).

09 de Julio de 2020
Nombramientos. Auditor: EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE SL. Datos registrales. T 25134 , F 209, S 8, H M277310, I/A 36 ( 2.07.20).

09 de Junio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: NU脩EZ REBOLO FERNANDO. Nombramientos. Consejero: IBERICA DE ALMACENISTAS DEPATATAS SL. Representan: NU脩EZ REBOLO FERNANDO. Modificaciones estatutarias. Se modifican los Art铆culos 14陋 y 27潞 delos Estatutos Sociales.-. Datos registrales. T 25134 , F 208, S 8, H M 277310, I/A 35 ( 2.06.20).

20 de Mayo de 2020
Nombramientos. Cons.Del.Sol: JIMENEZ JIMENEZ PABLO;JIMENEZ JIMENEZ DAVID. Datos registrales. T 25134 , F 208, S 8, HM 277310, I/A 34 (12.05.20).

26 de Agosto de 2019
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 14, 20 Y 27 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. . Datos registrales.T 25134 , F 208, S 8, H M 277310, I/A 33 (19.08.19).

06 de Mayo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ BLAZQUEZ GREGORIO. Reelecciones. Consejero: JIMENEZ GOMEZ PABLO;NU脩EZREBOLO FERNANDO;JIMENEZ JIMENEZ PABLO;JIMENEZ JIMENEZ DAVID. Presidente: JIMENEZ GOMEZ PABLO. Cons.Del.Sol:JIMENEZ GOMEZ PABLO. Cons.Del.Man: JIMENEZ JIMENEZ PABLO;JIMENEZ JIMENEZ DAVID. SecreNoConsj: DE LA CRUZBERMEJO FEDERICO. Datos registrales. T 25134 , F 207, S 8, H M 277310, I/A 32 (25.04.19).

28 de Marzo de 2019
Reelecciones. Auditor: CROWE SERVICIOS DE AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 25134 , F 207, S 8, H M 277310, I/A 31(21.03.19).

03 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PAJARES GIMENEZ MARIO. Nombramientos. SecreNoConsj: DE LA CRUZ BERMEJOFEDERICO. Datos registrales. T 25134 , F 206, S 8, H M 277310, I/A 29 (26.06.18).

Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS REFERENTE A LA TRANSMISION DEPARTICIPACIONES SOCIALES. Datos registrales. T 25134 , F 206, S 8, H M 277310, I/A 30 (26.06.18).

31 de Mayo de 2018
Reelecciones. Auditor: HORWATH AUDITORES ESPA脩A SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 25134 , F 206, S8, H M 277310, I/A 28 (24.05.18).

03 de Noviembre de 2016
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: COLLADO RODRIGUEZ RAUL. Nombramientos. SecreNoConsj: PAJARES GIMENEZ MARIO.Datos registrales. T 25134 , F 206, S 8, H M 277310, I/A 27 (20.10.16).

07 de Abril de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ GOMEZ PABLO. Presidente: JIMENEZ GOMEZ PABLO. Consejero: JIMENEZ BLAZQUEZGREGORIO;NU脩EZ REBOLO FERNANDO. Cons.Del.Sol: JIMENEZ GOMEZ PABLO;JIMENEZ BLAZQUEZ GREGORIO;NU脩EZREBOLO FERNANDO. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ GOMEZ PABLO;JIMENEZ BLAZQUEZ GREGORIO;NU脩EZREBOLO FERNANDO;JIMENEZ JIMENEZ PABLO;JIMENEZ JIMENEZ DAVID. Presidente: JIMENEZ GOMEZ PABLO. Cons.Del.Sol:JIMENEZ GOMEZ PABLO. Cons.Del.Man: JIMENEZ JIMENEZ PABLO;JIMENEZ JIMENEZ DAVID. SecreNoConsj: COLLADORODRIGUEZ RAUL. Datos registrales. T 25134 , F 205, S 8, H M 277310, I/A 26 (29.03.16).

29 de Febrero de 2016
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 25134 , F 205, S 8, H M 277310, I/A 25 (19.02.16).

26 de Febrero de 2016
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ BLAZQUEZ GREGORIO. Datos registrales. T 25134 , F 204, S 8, H M 277310, I/A 24(17.02.16).

09 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ JIMENEZ DAVID. Datos registrales. T 25134 , F 203, S 8, H M 277310, I/A 23 (30.09.15).

01 de Octubre de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 381.285,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.830.344,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedadesabsorbidas: SEVERINO MARTIN SL. Datos registrales. T 25134 , F 201, S 8, H M 277310, I/A 22 (22.09.15).

22 de Enero de 2015
Nombramientos. Auditor: HORWATH AUDITORES ESPA脩A SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 25134 , F 200,S 8, H M 277310, I/A 21 (14.01.15).

04 de Mayo de 2009
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ BLAZQUEZ GREGORIO. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 33.873,00 Euros.Resultante Suscrito: 1.449.059,00 Euros. Datos registrales. T 16327 , F 225, S 8, H M 277310, I/A 20 (21.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n