Actos BORME de Iberica De Revestimientos Grupo Emp Sl
10 de Noviembre de 2023Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Otros conceptos: Modificacion y aprobacion de nuevosEstatutos. Cambio de objeto social. CNAE 2030 la fabricaci贸n y comercializaci贸n en Espa帽a y cn el extranjero de pinturas, lacas,productos de protecci贸n de construcciones, productos y sistemas compuestos de aislamiento t茅rmico, revestimientos de muros ysuelos, tejidos de decoraci贸n, productos qu铆micos para uso industrial y materiales. Datos registrales. T 4550 , F 26, S 8, H AS 50301,I/A 15 ( 3.11.23).
12 de Junio de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: SUAREZ GARCIA IVAN;LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA;GONZALEZ MOLINA JAVIER;PE脩A SAEZFERNANDO. Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ SUAREZ CRISTINA;SUAREZ GARCIA IVAN. Apo.Manc.: SUAREZ GARCIAIVAN. Apo.Sol.: PE脩A SAEZ FERNANDO. Apo.Manc.: GONZALEZ SUAREZ CRISTINA. Apo.Sol.: LLAMES GONZALEZ JOSEMARIA. Apo.Manc.: PE脩A SAEZ FERNANDO;LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA;BRA脩A VICTORERO LUCIA. Datos registrales. T4217 , F 132, S 8, H AS 50301, I/A 14 ( 5.06.23).
23 de Noviembre de 2022Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.105.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.350.900,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 4217 , F 132, S 8, H AS 50301, I/A 13 (16.11.22).
24 de Agosto de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4217 , F 132, S 8, H AS 50301, I/A 12 (16.08.22).
17 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: MURJAHN RALF ROBERT;STURMFELS RUDOLF. Presidente: MURJAHN RALF ROBERT.Nombramientos. Consejero: LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA. Presidente: PE脩A SAEZ FERNANDO. Datos registrales. T 4217 ,F 132, S 8, H AS 50301, I/A 11 ( 9.08.21).
21 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4217 , F 132, S 8, H AS 50301, I/A 10 (12.01.21).
17 de Octubre de 2018Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: DAW SE. Datos registrales. T 4217 , F 131, S 8, H AS 50301, I/A 9 ( 9.10.18).
03 de Octubre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: PE脩A SAEZ FERNANDO;SUAREZ GARCIA IVAN. Datos registrales. T 4217 , F 131, S 8, H AS 50301,I/A 8 (25.09.18).
14 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION. Datos registrales. T 4217 , F 131, S 8, H AS50301, I/A 7 ( 6.06.18).
10 de Mayo de 2018Revocaciones. Auditor: AUDIASTUR AUDITORES DEL PRINCIPADO SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL.Datos registrales. T 4217 , F 131, S 8, H AS 50301, I/A 6 (30.04.18).
08 de Marzo de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION. Consejero: ZABALA DEL REY MIGUELANGEL;CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION;LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA. Presidente: ZABALA DEL REYMIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: PE脩A SAEZ FERNANDO. Consejero:MURJAHN RALF ROBERT;STURMFELS RUDOLF;PE脩A SAEZ FERNANDO. Presidente: MURJAHN RALF. Vicepresid.: PE脩A SAEZFERNANDO. Apo.Sol.: SUAREZ GARCIA IVAN. Datos registrales. T 4217 , F 128, S 8, H AS 50301, I/A 4 (28.02.18).
Revocaciones. Apo.Manc.: SUAREZ GARCIA IVAN. Apo.Sol.: SUAREZ GARCIA IVAN;LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA.Nombramientos. Apo.Manc.: SUAREZ GARCIA IVAN;LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA;GONZALEZ MOLINA JAVIER;PE脩ASAEZ FERNANDO. Datos registrales. T 4217 , F 128, S 8, H AS 50301, I/A 5 (28.02.18).
17 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: AUDIASTUR AUDITORES DEL PRINCIPADO SL. Datos registrales. T 4217 , F 128, S 8, H AS 50301, I/A3 ( 9.01.17).
27 de Octubre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION;LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA;SUAREZGARCIA IVAN. Apo.Manc.: CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION;LLAMES GONZALEZ JOSE MARIA;SUAREZGARCIA IVAN. Datos registrales. T 4217 , F 127, S 8, H AS 50301, I/A 2 (19.10.16).
14 de Octubre de 2016Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 20.09.16. Objeto social: CNAE 2030. La fabricaci贸n, comercializaci贸n, exportaci贸n eimportaci贸n de todo tipo y clase de pinturas, esmaltes, barnices, lacas, revestimientos de todo tipo, impermeabilizantes, imprimaciones,plastes, disolventes, incluyendo todo tipo de productos derivados de los mismos. La fabricaci贸n, comerci. Domicilio: POLIGINDUSTRIAL DE SANTIANES S/N - SANTIANES (SARIEGO). Capital: 245.900,00 Euros. Nombramientos. Consejero: ZABALA DELREY MIGUEL ANGEL;SUAREZ GARCIA IVAN;CAMPILLO MARTINEZ PRUDENCIA ENCARNACION;LLAMES GONZALEZ JOSEMARIA. Presidente: ZABALA DEL REY MIGUEL ANGEL. Secretario: SUAREZ GARCIA IVAN. Datos registrales. T 4217 , F 110, S 8,H AS 50301, I/A 1 ( 5.10.16).