Buscador CIF Logo

Actos BORME Iberica De Tecnologia Avicola Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Iberica De Tecnologia Avicola Sa

Actos BORME Iberica De Tecnologia Avicola Sa - A47340138

Tenemos registrados 30 Actos BORME del Registro Mercantil de Valladolid para Iberica De Tecnologia Avicola Sa con CIF A47340138

🔙 Perfil de Iberica De Tecnologia Avicola Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Valladolid

Actos BORME de Iberica De Tecnologia Avicola Sa

07 de Marzo de 2023
Reelecciones. Auditor: PEREZ ALONSO JOSE MANUEL. Aud.Supl.: DIZ VARELA VICENTE MANUEL. Datos registrales. T 1364 ,F 113, S 8, H VA 5220, I/A 58 (28.02.23).

13 de Julio de 2022
Modificaciones estatutarias. Artículo 37º.- El ejercicio de los cargos del Consejo no será retribuido.. Datos registrales. T 1364 , F113, S 8, H VA 5220, I/A 57 ( 6.07.22).

09 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: WESJOHANN DIRK. Presidente: WESJOHANN DIRK. Nombramientos. Consejero: DEEKENCHRISTIAN. Presidente: DEEKEN CHRISTIAN. Datos registrales. T 1364 , F 112, S 8, H VA 5220, I/A 56 (29.04.22).

03 de Marzo de 2022
Reelecciones. Auditor: PEREZ ALONSO JOSE MANUEL. Aud.Supl.: DIZ VARELA VICENTE MANUEL. Datos registrales. T 1364 ,F 112, S 8, H VA 5220, I/A 55 (24.02.22).

13 de Agosto de 2021
Reelecciones. Auditor: PEREZ ALONSO JOSE MANUEL. Aud.Supl.: DIZ VARELA VICENTE MANUEL. Datos registrales. T 1364 ,F 112, S 8, H VA 5220, I/A 54 ( 6.08.21).

07 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO MORENO PASCUAL. Secretario: ALONSO MORENO PASCUAL. Nombramientos.Consejero: SAGARDIA PRADERA JORGE. Secretario: SAGARDIA PRADERA JORGE. Datos registrales. T 1364 , F 112, S 8, H VA5220, I/A 53 (30.06.20).

11 de Marzo de 2020
Reelecciones. Auditor: PEREZ ALONSO JOSE MANUEL. Aud.Supl.: DIZ VARELA VICENTE MANUEL. Datos registrales. T 1364 ,F 111, S 8, H VA 5220, I/A 51 ( 4.03.20).

Reelecciones. Auditor: PEREZ ALONSO JOSE MANUEL. Aud.Supl.: DIZ VARELA VICENTE MANUEL. Datos registrales. T 1364 ,F 111, S 8, H VA 5220, I/A 52 ( 4.03.20).

10 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: FLORES CEREZO FRANCISCO;ALONSO MORENO PASCUAL. Datos registrales. T 1364 , F 58, S 8,H VA 5220, I/A 48 ( 3.10.19).

Nombramientos. Apo.Manc.: SAGARDIA PRADERA JORGE;FLORES CEREZO FRANCISCO. Datos registrales. T 1364 , F 58, S8, H VA 5220, I/A 49 ( 3.10.19).

Nombramientos. Apo.Manc.: SAGARDIA PRADERA JORGE;SANCHEZ MAYORGA ANA ISABEL. Datos registrales. T 1364 , F111, S 8, H VA 5220, I/A 50 ( 3.10.19).

16 de Mayo de 2019
Modificaciones estatutarias. "Artículo 37º.- El ejercicio de los cargos del Consejo será retribuido mediante una cantidad que seráfijada para cada ejercicio o anualmente por la Junta General.. Datos registrales. T 1364 , F 58, S 8, H VA 5220, I/A 47 ( 8.05.19).

23 de Marzo de 2018
Reelecciones. Auditor: PEREZ ALONSO JOSE MANUEL. Aud.Supl.: DIZ VARELA VICENTE MANUEL. Datos registrales. T 1364 ,F 58, S 8, H VA 5220, I/A 46 (16.03.18).

19 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: WESJOHANN DIRK. Presidente: WESJOHANN DIRK. Consejero: RAMIREZ VILLAESCUSAFRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Consejero: ALONSO MORENO PASCUAL.Secretario: ALONSO MORENO PASCUAL. Nombramientos. Consejero: WESJOHANN DIRK;ALONSO MORENOPASCUAL;RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Presidente: WESJOHANN DIRK. Secretario: ALONSO MORENOPASCUAL. Con.Delegado: RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Otros conceptos: Los Consejeros ejercerán su cargo

04 de Julio de 2017
Reelecciones. Auditor: PEREZ ALONSO JOSE MANUEL. Aud.Supl.: DIZ VARELA VICENTE MANUEL. Datos registrales. T 1364 ,F 57, S 8, H VA 5220, I/A 44 (27.06.17).

14 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: FLORES CEREZO FRANCISCO. Datos registrales. T 1364 , F 57, S 8, H VA 5220, I/A 43 ( 5.12.16).

17 de Junio de 2016
Cambio de domicilio social. C/ TOMAS CERDA 7 (BOECILLO). Datos registrales. T 1364 , F 57, S 8, H VA 5220, I/A 41(10.06.16).

Revocaciones. Apo.Manc.: ALONSO MORENO PASCUAL;SACRISTAN MARTIN JOSE PEDRO. Datos registrales. T 1364 , F 57,S 8, H VA 5220, I/A 42 (10.06.16).

01 de Abril de 2016
Reelecciones. Auditor: PEREZ ALONSO JOSE MANUEL. Aud.Supl.: DIZ VARELA VICENTE MANUEL. Datos registrales. T 1364 ,F 57, S 8, H VA 5220, I/A 40 (23.03.16).

23 de Abril de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: ALONSO MORENO PASCUAL;FLORES CEREZO FRANCISCO. Datos registrales. T 1364 , F 56, S8, H VA 5220, I/A 39 (16.04.15).

18 de Febrero de 2015
Nombramientos. Aud.Supl.: DIZ VARELA VICENTE MANUEL. Reelecciones. Auditor: PEREZ ALONSO JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 1364 , F 56, S 8, H VA 5220, I/A 38 (11.02.15).

21 de Enero de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: PHILIPP HERLYN ENNO. Secretario: RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Consejero: ALONSO MORENO PASCUAL. Secretario: ALONSO MORENO PASCUAL. Datos registrales. T 1364, F 56, S 8, H VA 5220, I/A 37 (14.01.15).

24 de Enero de 2014
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: EUROPEAN LAYER DISTRIBUTION GMBH. Datos registrales. T1364 , F 55, S 8, H VA 5220, I/A 35 (17.01.14).

Reelecciones. Consejero: WESJOHANN DIRK. Presidente: WESJOHANN DIRK. Consejero: RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCOJAVIER. Secretario: RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Consejero: PHILIPP HERLYN ENNO. Con.Delegado: RAMIREZVILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1364 , F 56, S 8, H VA 5220, I/A 36 (17.01.14).

14 de Junio de 2013
Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ CABRERO ANGEL;ALONSO MORENO PASCUAL. Nombramientos. Apo.Manc.: ALONSOMORENO PASCUAL;SACRISTAN MARTIN JOSE PEDRO. Datos registrales. T 1364 , F 55, S 8, H VA 5220, I/A 34 ( 7.06.13).

14 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: FINCK HANS FIEDRICH. Nombramientos. Consejero: PHILIPP HERLYN ENNO. Datosregistrales. T 1364 , F 55, S 8, H VA 5220, I/A 32 ( 5.03.12).

Nombramientos. Auditor: PEREZ ALONSO JOSE MANUEL;ESCAÑO ROMAN LUIS. Datos registrales. T 1364 , F 55, S 8, H VA5220, I/A 33 ( 5.03.12).

25 de Febrero de 2010
Declaración de unipersonalidad. Socio único: LOHMANN TIERZUCHT GESELLSCHAT MIT BESCHRANKTER HAF.Ceses/Dimisiones. Secretario: DE LAS HERAS NIÑO RAFAEL. Consejero: BERND SEIDEL MICHAEL;PASCUAL GOMEZ-CUETARA TOMAS FLORENCIO;URBELZ PEREZ IGNACIO. Nombramientos. Consejero: FINCK HANS FIEDRICH;RAMIREZVILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Secretario: RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Reelecciones. Consejero:WESJOHANN DIRK. Presidente: WESJOHANN DIRK. Datos registrales. T 1364 , F 54, S 8, H VA 5220, I/A 30 (16.02.10).

Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ CABRERO ANGEL;RAMIREZ VILLAESCUSA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos.Apo.Manc.: GONZALEZ CABRERO ANGEL;ALONSO MORENO PASCUAL. Datos registrales. T 1364 , F 54, S 8, H VA 5220, I/A 31(16.02.10).

06 de Octubre de 2009
Nombramientos. Auditor: ESCAÑO ROMAN LUIS. Reelecciones. Auditor: PEREZ ALONSO JOSE MANUEL. Datos registrales. T679 , F 138, S 8, H VA 5220, I/A 29 (25.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información